SERCO SYSTEMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSERCO SYSTEMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01861237
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SERCO SYSTEMS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich SERCO SYSTEMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SERCO SYSTEMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RCA SYSTEMS LIMITED29. Nov. 198429. Nov. 1984
    TWOLAKE LIMITED06. Nov. 198406. Nov. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SERCO SYSTEMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für SERCO SYSTEMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Sept. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. März 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Sept. 2008

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Verschiedenes

    Res re specie
    1 SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von SERCO SYSTEMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SERCO CORPORATE SERVICES LIMITED
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Sekretär
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    115898490001
    HILL, Gavin
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritish84457250005
    LAWLOR, Timothy Charles
    Elcombe
    Malthouse Lane
    GU3 3PS Worplesdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Elcombe
    Malthouse Lane
    GU3 3PS Worplesdon
    Surrey
    United KingdomBritish150988490001
    CLEMENT, Thomas
    31 Wester Links
    IV10 8RZ Fortrose
    Ross Shire
    Sekretär
    31 Wester Links
    IV10 8RZ Fortrose
    Ross Shire
    British633700001
    ILAN, Ronen
    1 Saint Andrews Drive
    HA7 2LY Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    1 Saint Andrews Drive
    HA7 2LY Stanmore
    Middlesex
    British60757970003
    MCGREGOR-SMITH, Ruby
    84 Harvest Road
    Englefield Green
    TW20 0QR Egham
    Surrey
    Sekretär
    84 Harvest Road
    Englefield Green
    TW20 0QR Egham
    Surrey
    British39857280001
    ROBSON, Alan Lewis
    134 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    Sekretär
    134 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    British8210750001
    TODD, Francesca Anne
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    Sekretär
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    British72249980001
    ASTON, Leslie Harvey
    Farthings
    32 Mill Road
    MK44 1NX Sharnbrook
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Farthings
    32 Mill Road
    MK44 1NX Sharnbrook
    Bedfordshire
    British33887700001
    ASTON, Michael Philip
    79 Ferndale
    PO7 7PG Waterlooville
    Hampshire
    Geschäftsführer
    79 Ferndale
    PO7 7PG Waterlooville
    Hampshire
    British38870720001
    BEESTON, Kevin Stanley
    Serco House
    16bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    16bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    British45842770004
    BRYDEN, Gordon
    30 Tasman Court
    Staines Road West
    TW16 7BA Sunbury On Thames
    Middlesex
    Geschäftsführer
    30 Tasman Court
    Staines Road West
    TW16 7BA Sunbury On Thames
    Middlesex
    British53913100002
    CAVANAGH, Julia Naomi
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    British58204140007
    CHRISTIE, Michael John
    Whispering Springs
    Spring Lane, Cleeve Hill
    GL52 3PY Cheltenham
    Gloucestershire
    United Kindom
    Geschäftsführer
    Whispering Springs
    Spring Lane, Cleeve Hill
    GL52 3PY Cheltenham
    Gloucestershire
    United Kindom
    British107248770001
    CLEMENT, Thomas
    31 Wester Links
    IV10 8RZ Fortrose
    Ross Shire
    Geschäftsführer
    31 Wester Links
    IV10 8RZ Fortrose
    Ross Shire
    British633700001
    CORNWELL, Anthony Bruce
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritish3471920001
    DIXON, Josephine
    Hotspur House
    Allendale
    NE47 9BW Northumberland
    Geschäftsführer
    Hotspur House
    Allendale
    NE47 9BW Northumberland
    United KingdomBritish148347760001
    FELTON, Wayne Harold
    Treetops
    Furze Hill Road Headley Down
    GU35 8HA Bordon
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Treetops
    Furze Hill Road Headley Down
    GU35 8HA Bordon
    Hampshire
    United KingdomBritish173205650001
    FROST, Richard James
    4 Hall Park
    Heslington
    YO1 5DT York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    4 Hall Park
    Heslington
    YO1 5DT York
    Yorkshire
    British33449650001
    FUTCHER, William Frank
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    British51346890001
    HILL, Stephen Ronald
    7 Cransbill Drive
    Bure Park
    OX26 3WG Bicester
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    7 Cransbill Drive
    Bure Park
    OX26 3WG Bicester
    Oxfordshire
    British78629670001
    HUNTER-PARK, Ian
    Charlands
    Colwood Manor Spronketts Lane
    RH17 5SA Bolney
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Charlands
    Colwood Manor Spronketts Lane
    RH17 5SA Bolney
    West Sussex
    British44861480001
    MCEWAN, Thomas John
    85 Bruton Way
    Forest Park
    RG12 3GJ Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    85 Bruton Way
    Forest Park
    RG12 3GJ Bracknell
    Berkshire
    British33449630001
    MCGHIE, David Watt
    Old Post Cottage
    Silchester Road
    RG26 5ES Little London
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Old Post Cottage
    Silchester Road
    RG26 5ES Little London
    Hampshire
    British84663430001
    MCGREGOR-SMITH, Ruby
    84 Harvest Road
    Englefield Green
    TW20 0QR Egham
    Surrey
    Geschäftsführer
    84 Harvest Road
    Englefield Green
    TW20 0QR Egham
    Surrey
    British39857280001
    MCLEAN, William Bell
    Alderbush 2 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Strathclyde
    Geschäftsführer
    Alderbush 2 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Strathclyde
    British46199850001
    PATERSON, Gordon Allan
    1 Heather Gardens
    RG14 7RG Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1 Heather Gardens
    RG14 7RG Newbury
    Berkshire
    British46200410002
    PERKINS, David Ernest
    Flat 41 Devonhurst Place
    9 Heathfield Terrace Chiswick
    W4 4JB London
    Geschäftsführer
    Flat 41 Devonhurst Place
    9 Heathfield Terrace Chiswick
    W4 4JB London
    British11381240008
    ROBSON, Alan Lewis
    134 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    Geschäftsführer
    134 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    British8210750001
    RODGERS, Gerrard
    Brecon House Canon Hill Close
    Bray
    SL6 2DH Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Brecon House Canon Hill Close
    Bray
    SL6 2DH Maidenhead
    Berkshire
    British46199820002
    RODGERS, Gerry
    D3 Starling Close
    St Peters Park
    WA1 5RJ Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    D3 Starling Close
    St Peters Park
    WA1 5RJ Worcester
    Worcestershire
    British33449670001
    SHORT, Jeffrey Adam
    2 St Thomas Walk
    SL3 0RH Colnbrook
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 St Thomas Walk
    SL3 0RH Colnbrook
    Buckinghamshire
    British34307470002
    SIMPSON, John Lee
    Wymeswold
    Holyport Road
    SL6 2EY Holyport
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Wymeswold
    Holyport Road
    SL6 2EY Holyport
    Berkshire
    United KingdomBritish199318970001
    TAYLOR, John Howard
    305 Norton Way South
    SG6 1SU Letchworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    305 Norton Way South
    SG6 1SU Letchworth
    Hertfordshire
    British54317070001
    WOOLF, David Joseph
    2 Knighton House 102 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9AN London
    Geschäftsführer
    2 Knighton House 102 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9AN London
    British77567100001

    Hat SERCO SYSTEMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Conveyance
    Erstellt am 31. Okt. 1994
    Geliefert am 11. Nov. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    50% of the difference between the open market value of the land immediately before the grant of planning permission and such value immediately there-after where such grant permits development of the whole or any part of the property for purposes other than the current purpose being use for light industrial purposes and where such grant is made before 31ST october 2014
    Kurze Angaben
    Land containing 0.419 hectares (1.282 acres) or thereabouts in the parish of rollestone near salisbury in the county of wiltshire together with the buildings erected thereon or on some part thereof and known as hangers numbers 79 and 80 rollerstone camp shrewton salisbury as is more particularly described in the conveyance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Defence
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Conveyance
    Erstellt am 31. Okt. 1994
    Geliefert am 11. Nov. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Whichever is the greater of: one half of the amount by which the "total gross monetary consideration" realised on any "disposal" of the property charged before 31ST october 1997 exceeds the total of the purchase price (being £10000) plus the "cost of refurbishment. One half of the amount by which the "then open market value of the property" exceeds the total of the purchase price (being £10000) plus the "cost of refurbishment" all terms as defined in the conveyance
    Kurze Angaben
    Land 0.419 hectares (1.282 acres) or thereabouts in parish of rollestone near salisbury wiltshire together with buildings erected thereon k/a hangers numbers 79 and 80 rollerstone camp shrewton salisbury (as described in the conveyance). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Defence
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Jan. 1987
    Geliefert am 12. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    • 13. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SERCO SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Feb. 2010Aufgelöst am
    14. Sept. 2007Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0