DIGITAL COMPUTERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDIGITAL COMPUTERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01867793
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DIGITAL COMPUTERS LIMITED?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich DIGITAL COMPUTERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DIGITAL COMPUTERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für DIGITAL COMPUTERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Codemasters Campus, Stoneythorpe Southam Warwickshire CV47 2DL zum Grant Thornton Uk Llp 30 Finsbury Square London EC2P 2YU am 04. Feb. 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Jan. 2019

    LRESSP

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    11 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 12. Mai 2016

    • Kapital: GBP 61,562.376
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    11 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Frank Theodore Sagnier am 01. Juni 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 10. Mai 2015

    • Kapital: GBP 61,562.376
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Frank Theodore Sagnier am 18. März 2015

    2 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Frank Theodore Sagnier als Direktor am 18. März 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Rodney Peter Cousens als Geschäftsführer am 18. März 2015

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von DIGITAL COMPUTERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VARACHIA, Rashid
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Grant Thornton Uk Llp
    Sekretär
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Grant Thornton Uk Llp
    175103240001
    SAGNIER, Frank Theodore
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Grant Thornton Uk Llp
    Geschäftsführer
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Grant Thornton Uk Llp
    EnglandFrench196390590001
    VARACHIA, Rashid
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Grant Thornton Uk Llp
    Geschäftsführer
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Grant Thornton Uk Llp
    EnglandBritish170342880001
    BAYNES, David Graham
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    Sekretär
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    British177146390001
    DARLING, David
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    Sekretär
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    British25295440008
    DARLING, James Raymond
    Lower Farm Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    Lower Farm Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Leamington Spa
    Warwickshire
    British19392220001
    MARTIN, Paul Santo
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    Sekretär
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    154572070001
    PARSONS, Simon Lawrence
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    Sekretär
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    British161173620001
    STOCKTON, Neil David
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    Sekretär
    Codemasters Campus, Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Warwickshire
    172872110001
    WILSON, David John
    Benesque 214 Bramhall Moor Lane
    Hazel Grove
    SK7 5JJ Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    Benesque 214 Bramhall Moor Lane
    Hazel Grove
    SK7 5JJ Stockport
    Cheshire
    British10851370002
    BAYNES, David Graham
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish177146390001
    COUSENS, Rodney Peter
    Glebe House
    Petworth Road Chiddingfold
    GU8 4UF Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Petworth Road Chiddingfold
    GU8 4UF Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish42266870001
    DARLING, David
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Lower Farm
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish25295440008
    DARLING, James Raymond
    Lower Farm Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Lower Farm Stoneythorpe
    Southam
    CV47 2DL Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish19392220001
    PARSONS, Simon Lawrence
    Sandy Lane Farm
    Milverton Lane, Blackdown
    CV32 6RW Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Sandy Lane Farm
    Milverton Lane, Blackdown
    CV32 6RW Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish161173620001
    WILLIAMS, Tony
    17 Burlington Street
    BA1 2SB Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    17 Burlington Street
    BA1 2SB Bath
    Avon
    British108892230001
    WILSON, David John
    Benesque 214 Bramhall Moor Lane
    Hazel Grove
    SK7 5JJ Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Benesque 214 Bramhall Moor Lane
    Hazel Grove
    SK7 5JJ Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish10851370002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DIGITAL COMPUTERS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Codemasters Group Limited
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Codemasters Campus
    Warwickshire
    England
    06. Apr. 2016
    Stoneythorpe
    CV47 2DL Southam
    Codemasters Campus
    Warwickshire
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England & Wales
    Registrierungsnummer3158832
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat DIGITAL COMPUTERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 2012
    Geliefert am 21. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Export-Import Bank of India
    Transaktionen
    • 21. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 02. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Reliance Big Entertainment Pvt LTD
    Transaktionen
    • 02. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Amended and restated debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 06. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) Sarl
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession to a security agreement
    Erstellt am 24. Mai 2007
    Geliefert am 12. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Facilityagent)
    Transaktionen
    • 12. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 08. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery including the properties registered under t/nos. WK304172, WK299681 and WK396247. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • European Venture Partners Iii (Luxembourg) S.A.R.L.
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 18. März 2002
    Geliefert am 19. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Mai 1990
    Geliefert am 22. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 24. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DIGITAL COMPUTERS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Jan. 2019Beginn der Liquidation
    11. Apr. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0