QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameQUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01868770
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    QUORUM INVESTMENTS LIMITED10. Aug. 200110. Aug. 2001
    QUORUM ESTATES LIMITED05. Dez. 198405. Dez. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 SeitenLIQ13

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenNDISC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Okt. 2018

    15 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT zum Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road Whitefield Greater Manchester M45 7TA am 07. Nov. 2017

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Okt. 2017

    LRESSP

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2016

    4 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 018687700074 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 018687700075 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 018687700076 vollständig

    4 SeitenMR04

    Zweite Einreichung für die Ernennung von Paul Dominic Cook zum Geschäftsführer

    5 SeitenRP04AP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 018687700077 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 018687700078 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2015

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 04. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 20,502
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2014

    3 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed quorum investments LIMITED\certificate issued on 04/03/15
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 27. Feb. 2015

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 20,502
    SH01

    Eintragung der Belastung 018687700078

    32 SeitenMR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    27. Juni 2014This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Eintragung der Belastung 018687700077

    42 SeitenMR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2013

    3 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WARDLE, Katharine Jane
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    149162780001
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer7038430
    146358090001
    COOK, Paul Dominic
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor181927220001
    SLATER, John David
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director6240010001
    WARDLE, Paul Martin
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Manchester Road
    SK9 1BQ Wilmslow
    Barons Court
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCo Director25540580004
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Sekretär
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    SLATER, Ann Christine
    Tudor Cottage, 14 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    Tudor Cottage, 14 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    British43958640001
    OGLESBY, Michael John
    Moss Farm
    South Downs Road
    WA14 3DR Bowdon
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Moss Farm
    South Downs Road
    WA14 3DR Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director148307320001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    31. Dez. 2016Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 20. Juni 2014
    Geliefert am 27. Juni 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Property k/a 79 and 81 dane road sale t/no GM430829.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 27. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Juni 2014
    Geliefert am 24. Juni 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Feb. 2014
    Geliefert am 10. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All that leasehold property known as unit 2, clarke industrial estate, barton dock road, stretford. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 12. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 07. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 12. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 07. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Unit 2 clarke industrial estate, barton dock road, stretford, title numbers GM221602 and GM936233. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 12. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Apr. 2001
    Geliefert am 20. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H block 16 sharston industrial estate manchester.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Apr. 2001
    Geliefert am 19. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H block 16 sharston industrial estate manchester. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Feb. 2001
    Geliefert am 26. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from quorum developments limited ot the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land and buildings at the oakfield centre langley lane northenden t/n GM433353. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 2000
    Geliefert am 28. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter and/or in connection with the facility granted and/or under the charge
    Kurze Angaben
    Specific charge all the income and rights relating thereto from time to time arising or payable to or on behalf of the mortgagor in relation to the property and the proceeds of any sale, lease or other disposition in respect thereof and all deeds and documents from time to time relating and all insurance and compensation monies as defined in the legal charge. Floating charge all movable plant machinery implements, building materials of all kinds utensils and equipment belonging to the mortgagor.
    Berechtigte Personen
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Juni 1999
    Geliefert am 10. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a the oakfield centre longley lane harling road northenden greater manchester t/n GM433353. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 02. Jan. 1998
    Geliefert am 15. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H plot of land at the industrial estate winsford containing 5.72 acres or thereabouts.
    Berechtigte Personen
    • Nash Europe Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 16. Dez. 1997
    Geliefert am 23. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings road one winsford industrial estate winsford cheshire specific charge all income rights proceeds of sale all deeds insurance and compensation monies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 16. Dez. 1997
    Geliefert am 23. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter
    Kurze Angaben
    The towers towers business park wilmslow road didsbury manchester M20 2SL specific charge all income rights proceeds of sale all deed insurance compensation monies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 07. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a shirley towers didsbury greater manchester t/no.GM486813 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 30. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Shirley towers didsbury manchester t/no.GM486813.
    Berechtigte Personen
    • British Textile Technology Group
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Aug. 1995
    Geliefert am 29. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 9TH may 1995
    Kurze Angaben
    71/75 (odd) jameson street, kingston upon hull, humberside t/no. HS233356. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Mai 1995
    Geliefert am 19. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the east side of ripon road killinghall harrogate west yorkshire k/a crofters green t/n NYK157806 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Mai 1995
    Geliefert am 22. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the north east and south west sides grimshaw lane middleton lancashire k/a the linkway estate t/n LA115001 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 15. Dez. 1994
    Geliefert am 04. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The monies and liabilities secured by a legal charge in favour of hill samuel bank limited as agent and trustee for the banks (as defined in the legal charge)
    Kurze Angaben
    All present and future rights and interests which the company may have in abney hall and abney court,manchester road,cheadle,stockport,greater manchester.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 28. Sept. 1994
    Geliefert am 14. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The monies and liabilities secured by a legal charge in favour of hill samuel bank limited as agent and trustee for the banks and lending institutions
    Kurze Angaben
    All present or future rights and interests which the company may have in abney hall and abney court,manchester road,cheadle,stockport,greater manchester.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 1994
    Geliefert am 03. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 11TH february 1994
    Kurze Angaben
    All the property formerly comprising part of the white house hotel jameson street kingston upon hull.
    Berechtigte Personen
    • John Stewart Rogerson
    Transaktionen
    • 03. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of debt
    Erstellt am 17. Nov. 1993
    Geliefert am 27. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £652,335.65 due from the royal bank of scotland (I.O.M.) limited to the company including all interest accrued or accruing in the future on the amount of the debt and all increases in the amount of the debt.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juli 1992
    Geliefert am 28. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any associated company or any guarantor (as defined in the legal charge) to united dominions trust limited o any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land on the east side of bredbury park way bredbury stockport greater manchester t/n GM494884 all and any proceeds of the property,all value added tax,the benefit of all licences ,all insurance policies and agreements connected with the property (see form 395 and continuation sheets for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Mai 1992
    Geliefert am 02. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the estate interest right whatsoever of the company under an agreement dated 2ND june 1989 and all monies payable thereunder (for full details see form 395 and continuation sheets).
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 02. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 06. Apr. 1992
    Geliefert am 09. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 31ST march 1992
    Kurze Angaben
    The sum of one million one hundred and sixteen thousand two hundred and thirtythree pounds eighty three pence on an account numbered 66539901 held by the bank with reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • County Natwest
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat QUORUM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Okt. 2017Beginn der Liquidation
    09. März 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steve Markey
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Praktiker
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Martin Maloney
    Leonard Curtis House 1a Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Manchester
    Praktiker
    Leonard Curtis House 1a Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0