WADE ALLIED LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWADE ALLIED LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01871630
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WADE ALLIED LIMITED?

    • Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich WADE ALLIED LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Wade Ceramics Ltd
    Bessemer Drive
    ST1 5GR Stoke-On-Trent
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WADE ALLIED LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALLIED INSULATORS LTD18. März 198518. März 1985
    OFFSHELF (45) LTD13. Dez. 198413. Dez. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WADE ALLIED LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für WADE ALLIED LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 15. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 7,975,050
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Wade Ceramics Limited 5 Bessemer Drive Eutria Stoke-on-Trent Staffordshire ST1 5GR England zum C/O Wade Ceramics Ltd Bessemer Drive Stoke-on-Trent ST1 5GR am 14. Apr. 2016

    1 SeitenAD01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. März 2012

    Kapitalaufstellung am 27. März 2012

    • Kapital: GBP 7,975,050
    SH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Royal Victoria Pottery Westport Road Stoke on Trent Staffordshire ST6 4AG* am 06. Apr. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von WADE ALLIED LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FARMER, Paul William
    The Pines
    Aynsleys Drive
    ST11 9HJ Blythe Bridge
    Staffordshire
    Sekretär
    The Pines
    Aynsleys Drive
    ST11 9HJ Blythe Bridge
    Staffordshire
    BritishDirector107938650002
    DUKE, Edward
    Foul Rice Farm
    Marton Lordship Stillington
    YO61 1NT York
    Geschäftsführer
    Foul Rice Farm
    Marton Lordship Stillington
    YO61 1NT York
    United KingdomBritishCompany Director1876560002
    FARMER, Paul William
    The Pines
    Aynsleys Drive
    ST11 9HJ Blythe Bridge
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Pines
    Aynsleys Drive
    ST11 9HJ Blythe Bridge
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector107938650002
    JACKSON, Paul William
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    British8655120001
    BAILEY, Anthony Stanley
    2 Crossway Road
    Sneyd Green
    ST6 2NE Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    2 Crossway Road
    Sneyd Green
    ST6 2NE Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director8655130001
    BIGGIN, Anthony John
    Paddock End Ridley Hill Farm
    Ridley
    CW6 9RX Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Paddock End Ridley Hill Farm
    Ridley
    CW6 9RX Tarporley
    Cheshire
    BritishDirector58388890001
    COOPER, Alan Raymond
    63 Seven Star Road
    B91 2BZ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    63 Seven Star Road
    B91 2BZ Solihull
    West Midlands
    BritishDirector33870610001
    COOPER, Grant Geoffrey
    1 Monkleigh Close
    Treentham
    ST4 8TP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    1 Monkleigh Close
    Treentham
    ST4 8TP Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishProduction Director148123670001
    GIDMAN, Leonard
    17 Barley Croft
    Alsager
    ST7 2QU Stoke On Trent
    Geschäftsführer
    17 Barley Croft
    Alsager
    ST7 2QU Stoke On Trent
    United KingdomBritishCompany Director72471890002
    GILHAM, Clive Martin
    No 3 Birch House, The Alders
    Allerton Park Chapel
    LS1 4ND Allerton
    Leeds, West Yorkshire
    Geschäftsführer
    No 3 Birch House, The Alders
    Allerton Park Chapel
    LS1 4ND Allerton
    Leeds, West Yorkshire
    BritishCompany Director97163670001
    HUGHES, Michael Thomas
    1 Rambleford Way
    ST16 1TW Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    1 Rambleford Way
    ST16 1TW Stafford
    Staffordshire
    EnglandEnglishFoundry Director80207070001
    JACKSON, Paul William
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector8655120001
    JACKSON, Paul William
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director8655120001
    KINGSBURY, Derek John
    Birling Long Bottom Lane
    Seer Green
    HP9 2UL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Birling Long Bottom Lane
    Seer Green
    HP9 2UL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director18255570001
    LEE, Thomas Barrie
    1 Brookside
    GU6 7BA Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Brookside
    GU6 7BA Cranleigh
    Surrey
    BritishCompany Director8655160001
    LIPTROT, Frederick James
    3 The Mount
    ST13 6QZ Leek
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    3 The Mount
    ST13 6QZ Leek
    Staffordshire
    BritishCompany Director26359780001
    MEIGHAN, Jonathon Adam
    7 The Brambles
    ST5 4JJ Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    7 The Brambles
    ST5 4JJ Newcastle
    Staffordshire
    BritishCompany Director69523400001
    PAGE, Michael Brian
    90 Station Road
    Cropston
    LE7 7HE Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    90 Station Road
    Cropston
    LE7 7HE Leicester
    Leicestershire
    EnglandEnglishManaging Director24710330001
    PERRIN, Donald Roy
    65 Kingsgate Avenue
    CT10 3LW Broadstairs
    Kent
    Geschäftsführer
    65 Kingsgate Avenue
    CT10 3LW Broadstairs
    Kent
    EnglandBritishCompany Director76317740001
    POULTER, John William
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director4333730002
    RILEY, Frank Edward
    Four Trees
    Wetton Lane Butterton
    ST13 7ST Leek
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Four Trees
    Wetton Lane Butterton
    ST13 7ST Leek
    Staffordshire
    BritishCompany Director8655170001
    SHENTON, Reginald Gordon
    Cowal Meadows Farm Crowborough
    Lask Edge
    ST13 8QW Leek
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Cowal Meadows Farm Crowborough
    Lask Edge
    ST13 8QW Leek
    Staffordshire
    BritishCompany Director26359790001
    TRAVERS, Richard Benjamin
    Ragleth House
    73 High Street
    SY6 6BY Church Stretton
    Salop
    Geschäftsführer
    Ragleth House
    73 High Street
    SY6 6BY Church Stretton
    Salop
    BritishCompany Director34916570001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für WADE ALLIED LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    11. Apr. 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat WADE ALLIED LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2009
    Geliefert am 24. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Advantage Transition Bridge Fund Limited
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 15. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    All asset debenture
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 07. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 15. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the north and south side of leek new road, milton, stoke on trent, staffordshire t/no SF294002 by way of floating charge all plant, machinery, goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at milton, leek new road, milton, stoke on trent, staffordshire t/no SF117104. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Erstellt am 11. Apr. 2006
    Geliefert am 21. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Itochu Corporation
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 2003
    Geliefert am 24. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 2003
    Geliefert am 07. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at milton leek new road milton stoke on trent. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Juni 2002
    Geliefert am 13. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a land on the west side of sandbach road, cobridge, stoke on trent, t/n SF324387 (part). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. März 2002
    Geliefert am 06. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north and south sides of leek new road milton t/no;-SF117104. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2002
    Geliefert am 15. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land at leek new road milton stoke on trent t/n SF117104.
    Berechtigte Personen
    • Woodford Industries Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Mai 1999
    Geliefert am 08. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts payable under £1,800,000 8% secured loan stock and £500,000 20% secured loan stock issued to the chargee and all other future actual or contingent obligations and liabilities owed to the chargee by the company or any of the other companies named in schedule 1 of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    First fixed charge over the company's present and future interest in plant and machinery stock shares debentures bonds or other securities and share rights attaching to them money standing to the credit of accounts book and other debts and the proceeds of their realisation the benefits and proceeds of insurances and the right of return of any insurance premium the benefit of all licences ,goodwill uncalled capital and by way of floating charge all the company's present and future undertaking and assets.
    Berechtigte Personen
    • Capital Partners Ii Limited
    Transaktionen
    • 08. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 12. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Mai 1999
    Geliefert am 05. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the finance documents or any other document
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bny International Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Jan. 1998
    Geliefert am 29. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Jan. 1998
    Geliefert am 27. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at leek new road milton stoke on trent. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Juni 1987
    Geliefert am 16. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and all moneys due from fairey group limited an any account whatsoever to security pacific everofimance (UK) limited.
    Kurze Angaben
    F/Hold land at buildings on the north & south sies of leek new road, milton stoke on trent t/n sf 117104 & the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and athes fixtures. See doc M24/17JUL/ln.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific Everofimance (UK.) Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Jan. 1987
    Geliefert am 04. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from fairey group limited to samuel montagu & co. Limited as agent & trustee for itself and the banks under the terms of the loan agreement dated 31 dec '86 and for securing all moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for itself and the banks under the term of the a foresaid loan agreement dated 31 dec '86
    Kurze Angaben
    F/Hold land & buildings on the south side of hampton street, hanley, stoke-on-trent, staffordshire. Title no. Sf 215608. f/hold land & buildings on the north and south sides of leek new road, milton, stoke-on-trent title no. Sf 11704 specific equitable charge over all esates & interests in any f/h & l/h property charged to the company/other than the property referred to above. Assignment of all debts and other sums of money (please see doc for fuller details).
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trusee for Itself and the Banks Joined as Parties to the Loan Agreement
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 16. Jan. 1987
    Geliefert am 27. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage and or the proceeds of sale on f/h land & buildings on the south side of hampton street henley stoke on trent. Title no SE 215608 and f/h land & buildings on the north and south sides of leek new road milton stoke on trent. Title no. Sf 11704. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 15. März 1985
    Geliefert am 26. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north and south sides of leek new road milton staffordshire title no. Sf 117104.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 11. März 1985
    Geliefert am 26. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1985Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0