WICKES NOMINEE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WICKES NOMINEE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01874380 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WICKES NOMINEE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WICKES NOMINEE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | MAZARS LLP 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WICKES NOMINEE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WICKES UK HOLDINGS LIMITED | 16. Dez. 1985 | 16. Dez. 1985 |
| WICKES INVESTMENTS LIMITED | 07. Feb. 1985 | 07. Feb. 1985 |
| SHINEFORE LIMITED | 27. Dez. 1984 | 27. Dez. 1984 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WICKES NOMINEE LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2015 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. März 2016 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WICKES NOMINEE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Deborah Grimason am 13. Okt. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton Northamptonshire NN5 7UG zum 45 Church Street Birmingham B3 2RT am 06. Jan. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Miss Deborah Grimason als Direktor am 10. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony David Buffin als Geschäftsführer am 10. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Peter Carter als Geschäftsführer am 10. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2014 bis 30. Juni 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Stephen Pike als Sekretär am 23. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Tp Directors Ltd als Direktor am 19. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 16 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Anthony David Buffin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Hampden Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WICKES NOMINEE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIMASON, Deborah | Geschäftsführer | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | England | British | 185755960002 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Sekretär | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | 65678800002 | ||||||||||
| RIMMER, Barbara | Sekretär | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||||||
| STOKES-SMITH, Keith Reginald | Sekretär | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75650590001 | ||||||||||
| ARCHER, William Ernest | Geschäftsführer | The Priory 2 Astley Close WA16 8GJ Knutsford Cheshire | British | 15170380004 | ||||||||||
| BATTERSBY, Geoffrey Brian | Geschäftsführer | 13 15 Westcombe Park Road Blackheath SE3 7RE London | British | 41548740003 | ||||||||||
| BHOTE, Sanaya Homi | Geschäftsführer | 50 Bonnersfield Lane HA1 2LE Harrow Middlesex | British | 72716110002 | ||||||||||
| BIRD, Richard Sidney | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | British | 111500210001 | ||||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 178011680001 | |||||||||
| CARTER, John Peter | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| CORNER, Michael Richmond | Geschäftsführer | 95 Castelnau Barnes SW13 London | British | 21206150001 | ||||||||||
| GRIMSEY, William | Geschäftsführer | The Capita Group Plc 71 Victoria Street SW1H 0XA London | United Kingdom | British | 50647840002 | |||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Geschäftsführer | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| HORNE, Nicholas Paul Stewart | Geschäftsführer | 4 Braemar Close GU7 1SA Godalming Surrey | British | 983490001 | ||||||||||
| HOSKINS, William John | Geschäftsführer | 3 Homewood Road AL1 4BE St. Albans Hertfordshire | British | 49295070002 | ||||||||||
| LLEWELLYN, Trefor Wilmot | Geschäftsführer | Hill Farm House Ipsden OX10 6AD Wallingford Oxfordshire | England | British | 107250730001 | |||||||||
| PENNY, Michael William Harrison | Geschäftsführer | Windrush 9 Downsway GU1 2YA Guildford Surrey | United Kingdom | British | 144262470001 | |||||||||
| RICE, John Michael | Geschäftsführer | Wayside Cottage Street Lane Rodeheath ST7 3SN Cheshire | British | 72718070001 | ||||||||||
| STOKES-SMITH, Keith Reginald | Geschäftsführer | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75650590001 | ||||||||||
| STRADLING, Stuart Rhys | Geschäftsführer | 68 Howards Lane Putney SW15 6QD London | United Kingdom | British | 44265550001 | |||||||||
| SWEETBAUM, Henry Alan | Geschäftsführer | 11 Park Village West NW1 4AE London | United Kingdom | American | 10349960001 | |||||||||
| WILSON, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 72996700001 |
Hat WICKES NOMINEE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A mezzanine debenture | Erstellt am 28. Juli 2003 Geliefert am 13. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Senior security accession deed | Erstellt am 29. Jan. 2003 Geliefert am 13. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordinated security accession deed | Erstellt am 29. Jan. 2003 Geliefert am 13. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent | Erstellt am 16. Jan. 2001 Geliefert am 31. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Dez. 2000 Geliefert am 09. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed between wickes nominee limited, the parent (as defined) and ing bank N.V. london branch (being supplemental to a debenture dated 26TH september 2000) | Erstellt am 27. Okt. 2000 Geliefert am 06. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors (as defined) to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) (or any of them) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Jan. 1997 Geliefert am 15. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Limited recourse guarantee and debenture | Erstellt am 12. Dez. 1996 Geliefert am 20. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all or any of the o f the companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Juli 1996 Geliefert am 10. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WICKES NOMINEE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0