WICKES NOMINEE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWICKES NOMINEE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01874380
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WICKES NOMINEE LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich WICKES NOMINEE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WICKES NOMINEE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WICKES UK HOLDINGS LIMITED16. Dez. 198516. Dez. 1985
    WICKES INVESTMENTS LIMITED07. Feb. 198507. Feb. 1985
    SHINEFORE LIMITED27. Dez. 198427. Dez. 1984

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WICKES NOMINEE LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Juni 2015
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. März 2016
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für WICKES NOMINEE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Änderung der Details des Direktors für Miss Deborah Grimason am 13. Okt. 2016

    2 SeitenCH01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton Northamptonshire NN5 7UG zum 45 Church Street Birmingham B3 2RT am 06. Jan. 2016

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Dez. 2015

    LRESSP

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 22. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 335,012
    SH01

    Ernennung von Miss Deborah Grimason als Direktor am 10. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Anthony David Buffin als Geschäftsführer am 10. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Peter Carter als Geschäftsführer am 10. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2014 bis 30. Juni 2015

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 335,012
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    1 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Stephen Pike als Sekretär am 23. Sept. 2014

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Tp Directors Ltd als Direktor am 19. Sept. 2014

    2 SeitenAP02

    Beschlüsse

    Resolutions
    16 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Ernennung von Anthony David Buffin als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 335,012
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    1 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Paul Hampden Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von WICKES NOMINEE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRIMASON, Deborah
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Geschäftsführer
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    EnglandBritish185755960002
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03480295
    191205550001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Sekretär
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Sekretär
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BATTERSBY, Geoffrey Brian
    13 15 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RE London
    Geschäftsführer
    13 15 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RE London
    British41548740003
    BHOTE, Sanaya Homi
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    British72716110002
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Geschäftsführer
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Lodge Way House
    Lodge Way Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish178011680001
    CARTER, John Peter
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Geschäftsführer
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish46226920007
    CORNER, Michael Richmond
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    Geschäftsführer
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    British21206150001
    GRIMSEY, William
    The Capita Group Plc
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    Geschäftsführer
    The Capita Group Plc
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    United KingdomBritish50647840002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HORNE, Nicholas Paul Stewart
    4 Braemar Close
    GU7 1SA Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Braemar Close
    GU7 1SA Godalming
    Surrey
    British983490001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    LLEWELLYN, Trefor Wilmot
    Hill Farm House
    Ipsden
    OX10 6AD Wallingford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Hill Farm House
    Ipsden
    OX10 6AD Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish107250730001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Geschäftsführer
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    STRADLING, Stuart Rhys
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    Geschäftsführer
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    United KingdomBritish44265550001
    SWEETBAUM, Henry Alan
    11 Park Village West
    NW1 4AE London
    Geschäftsführer
    11 Park Village West
    NW1 4AE London
    United KingdomAmerican10349960001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001

    Hat WICKES NOMINEE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A mezzanine debenture
    Erstellt am 28. Juli 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Senior security accession deed
    Erstellt am 29. Jan. 2003
    Geliefert am 13. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordinated security accession deed
    Erstellt am 29. Jan. 2003
    Geliefert am 13. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent
    Erstellt am 16. Jan. 2001
    Geliefert am 31. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.,London Branch
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 2000
    Geliefert am 09. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed between wickes nominee limited, the parent (as defined) and ing bank N.V. london branch (being supplemental to a debenture dated 26TH september 2000)
    Erstellt am 27. Okt. 2000
    Geliefert am 06. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors (as defined) to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) (or any of them)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Jan. 1997
    Geliefert am 15. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Limited recourse guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1996
    Geliefert am 20. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and all or any of the o f the companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Juli 1996
    Geliefert am 10. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WICKES NOMINEE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Dez. 2015Beginn der Liquidation
    09. Mai 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praktiker
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0