PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED

PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01875121
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PRIMELIGHT 6'S LIMITED13. März 199513. März 1995
    PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED11. Apr. 199411. Apr. 1994
    PRIMESIGHT IN-FLIGHT LIMITED15. Nov. 198515. Nov. 1985
    AIR TRANSPORT ADVERTISING INTERNATIONAL LIMITED13. Feb. 198513. Feb. 1985
    ROUNDINFO LIMITED03. Jan. 198503. Jan. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Feb. 2012

    4 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Met Building 22 Percy Street London W1T 2BU England am 15. März 2011

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Insolvenzbeschluss

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution :- "In Specie"
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 08. März 2011

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 12. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Naren Anirudha Patel am 31. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Simon Green am 31. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    16 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Charlotte House 14 Windmill Street London W1T 2DY am 27. Sept. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Monica Ellen Mackinnon am 01. Jan. 2010

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Jonathan Daniels am 01. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    18 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    14 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MACKINNON, Monica Ellen
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Sekretär
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    BritishAccountant107899210001
    DANIELS, Paul Jonathan
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritishDirector127121890001
    GREEN, Timothy Simon
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritishDirector124282610001
    PATEL, Naren Anirudha
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritishCommercial Director44514540003
    CLARK, Peter Ian
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    Sekretär
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    New Zealander64941070001
    CLARKE, Sara
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    Sekretär
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    BritishChartered Management Accountan77963580002
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Sekretär
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    DESAI, Falguni
    6 Buckleigh Avenue
    SW20 9JZ London
    Sekretär
    6 Buckleigh Avenue
    SW20 9JZ London
    British77755390001
    PHILIP, Ian Edward
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    British10317680001
    PINNELL, Judith Helen
    12 Linden Road
    TW12 2JB Hampton
    Middlesex
    Sekretär
    12 Linden Road
    TW12 2JB Hampton
    Middlesex
    BritishSecretary127121950001
    TAMES, Jane Elizabeth Anne
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    Sekretär
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    British118367070001
    WHITE, Leonard Henry
    19 Montana Road
    SW20 8TW London
    Sekretär
    19 Montana Road
    SW20 8TW London
    British12308620001
    CANDERLE, Sebastien
    116 Edith Road
    W14 9AP London
    Geschäftsführer
    116 Edith Road
    W14 9AP London
    EnglandFrenchDirector124282690001
    CLARK, Peter Ian
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    Geschäftsführer
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    New ZealanderChartered Accountant64941070001
    COSTELLO, Christine
    Flat N
    66 St John Street
    EC1M 4DT London
    Geschäftsführer
    Flat N
    66 St John Street
    EC1M 4DT London
    EnglandBritishDirector64907900003
    DANIELS, Charles James
    Yew Tree End Springwoods
    Wentworth
    GU25 4PW Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    Yew Tree End Springwoods
    Wentworth
    GU25 4PW Virginia Water
    Surrey
    BritishDirector69233900002
    DANIELS, Paul Jonathan
    12 Beechwood Close
    GU51 5PT Church Crookham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Beechwood Close
    GU51 5PT Church Crookham
    Hampshire
    BritishOperations Director99302630001
    DUNSEATH, William Antony
    The Ridge
    GL12 7PT Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    The Ridge
    GL12 7PT Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    BritishUk Commercial Director55240600002
    EMSLIE, Donald Gordon
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    Geschäftsführer
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    ScotlandBritishDirector61177720002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishCompany Director42787120004
    HANCOCK, Michael Wooding
    2 Southview Road
    KT21 2NB Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Southview Road
    KT21 2NB Ashtead
    Surrey
    BritishCompany Director34223020001
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Geschäftsführer
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritishFinance Director72256160002
    HUGILL, Charles
    Flat 1 89 South Worple Way
    East Sheen
    SW14 8NG London
    Geschäftsführer
    Flat 1 89 South Worple Way
    East Sheen
    SW14 8NG London
    BritishExec93557380001
    JENKINS, Derek William
    10 Beauchamp Road
    KT8 0PA East Molesey
    Surrey
    Geschäftsführer
    10 Beauchamp Road
    KT8 0PA East Molesey
    Surrey
    BritishCompany Director28267720001
    SIMS, Martin George Montague
    Bow Cottage 27 Germain Street
    HP5 1LH Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Bow Cottage 27 Germain Street
    HP5 1LH Chesham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director13950670001
    TAPSALL, Simon Guy
    Sowton Cottage Davis Street
    Hurst
    RG10 0TH Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Sowton Cottage Davis Street
    Hurst
    RG10 0TH Reading
    Berkshire
    BritishSales Dir53019110001
    WATT, William George
    7 Millar Grove
    ML3 9BF Hamilton
    Geschäftsführer
    7 Millar Grove
    ML3 9BF Hamilton
    ScotlandBritishChartered Accountant72664400006
    WILLIAMSON, Alan Norval
    "Balerno 5 Freemans Close
    Stoke Poges
    SL2 4ER Slough
    Bucks
    Geschäftsführer
    "Balerno 5 Freemans Close
    Stoke Poges
    SL2 4ER Slough
    Bucks
    BritishCompany Director44447810001
    WOODFINE, David George
    58 Patrick Way
    HP21 9XJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    58 Patrick Way
    HP21 9XJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishDeveloper3180320001
    WOODWARD, Robert Stanley Lawrence
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    Geschäftsführer
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    ScotlandBritishDirector122562020001

    Hat PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 04. Apr. 2003
    Geliefert am 16. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent on Trust for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 18. Juli 2002
    Geliefert am 24. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 02. Juni 1997
    Geliefert am 11. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness, liabilities and obligations which are as at 2ND june 1997 or may at any time thereafter be due, owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee, by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Kurze Angaben
    First fixed and floating charges over the undertaking and all its property and assets present and future incuding its goodwill and uncalled capital and all plant and machinery. (N.B. the property described in part I and ii of the schedule attached to this form 395 is described as being "none").. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Bank")
    Transaktionen
    • 11. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 07. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 05. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Primesight PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Loan stock trust deed
    Erstellt am 01. Dez. 1995
    Geliefert am 14. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the loan stock deed including but not limited to payment of the amount of the principal sum then outstanding on the security of the stock and interest on the amount of such principal sum for the time being outstanding at the rate of 10% per year payable half yearly on 31ST december and 30TH june in the years 1996 1997 and 1998 but at 12% per year in 1999 and 14% in 2000
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Martin Jenkins(As Trustees)
    • Botts Capital Nominees Limited
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Indemnity and debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1995
    Geliefert am 05. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of a guarantee dated 4TH september 1995
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of a guarantee dated 4TH september 1995.
    Berechtigte Personen
    • Martin Barber
    Transaktionen
    • 05. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Aug. 1995
    Geliefert am 31. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Mai 2012Aufgelöst am
    08. März 2011Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0