PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01875121 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PRIMELIGHT 6'S LIMITED | 13. März 1995 | 13. März 1995 |
PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED | 11. Apr. 1994 | 11. Apr. 1994 |
PRIMESIGHT IN-FLIGHT LIMITED | 15. Nov. 1985 | 15. Nov. 1985 |
AIR TRANSPORT ADVERTISING INTERNATIONAL LIMITED | 13. Feb. 1985 | 13. Feb. 1985 |
ROUNDINFO LIMITED | 03. Jan. 1985 | 03. Jan. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Feb. 2012 | 4 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Met Building 22 Percy Street London W1T 2BU England am 15. März 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Insolvenzbeschluss Resolution INSOLVENCY:Special Resolution :- "In Specie" | 1 Seiten | LIQ MISC RES | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Naren Anirudha Patel am 31. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Simon Green am 31. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Charlotte House 14 Windmill Street London W1T 2DY am 27. Sept. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Monica Ellen Mackinnon am 01. Jan. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Jonathan Daniels am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b |
Wer sind die Geschäftsführer von PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACKINNON, Monica Ellen | Sekretär | Baker Street W1U 7EU London 55 | British | Accountant | 107899210001 | |||||
DANIELS, Paul Jonathan | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | Director | 127121890001 | ||||
GREEN, Timothy Simon | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | Director | 124282610001 | ||||
PATEL, Naren Anirudha | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | Commercial Director | 44514540003 | ||||
CLARK, Peter Ian | Sekretär | 120 Barrowgate Road W4 4QP Chiswick London | New Zealander | 64941070001 | ||||||
CLARKE, Sara | Sekretär | Old Stable Cottage Old Barn Farm, Uplawmoor G78 4AZ Glasgow | British | Chartered Management Accountan | 77963580002 | |||||
DAVIDSON, Dawn | Sekretär | Langhaugh Carmichael ML12 6PQ Biggar Lanarkshire | British | 51065860001 | ||||||
DESAI, Falguni | Sekretär | 6 Buckleigh Avenue SW20 9JZ London | British | 77755390001 | ||||||
PHILIP, Ian Edward | Sekretär | 13 St Johns Road TN13 3LR Sevenoaks Kent | British | 10317680001 | ||||||
PINNELL, Judith Helen | Sekretär | 12 Linden Road TW12 2JB Hampton Middlesex | British | Secretary | 127121950001 | |||||
TAMES, Jane Elizabeth Anne | Sekretär | 5 Hatfield Drive Kelvinside G12 0XZ Glasgow | British | 118367070001 | ||||||
WHITE, Leonard Henry | Sekretär | 19 Montana Road SW20 8TW London | British | 12308620001 | ||||||
CANDERLE, Sebastien | Geschäftsführer | 116 Edith Road W14 9AP London | England | French | Director | 124282690001 | ||||
CLARK, Peter Ian | Geschäftsführer | 120 Barrowgate Road W4 4QP Chiswick London | New Zealander | Chartered Accountant | 64941070001 | |||||
COSTELLO, Christine | Geschäftsführer | Flat N 66 St John Street EC1M 4DT London | England | British | Director | 64907900003 | ||||
DANIELS, Charles James | Geschäftsführer | Yew Tree End Springwoods Wentworth GU25 4PW Virginia Water Surrey | British | Director | 69233900002 | |||||
DANIELS, Paul Jonathan | Geschäftsführer | 12 Beechwood Close GU51 5PT Church Crookham Hampshire | British | Operations Director | 99302630001 | |||||
DUNSEATH, William Antony | Geschäftsführer | The Ridge GL12 7PT Wotton Under Edge Gloucestershire | British | Uk Commercial Director | 55240600002 | |||||
EMSLIE, Donald Gordon | Geschäftsführer | 32 Drumsheugh Gardens EH3 7RN Edinburgh | Scotland | British | Director | 61177720002 | ||||
FLANAGAN, Andrew Henry | Geschäftsführer | 7 Collylinn Road Bearsden G61 4PN Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | Company Director | 42787120004 | ||||
HANCOCK, Michael Wooding | Geschäftsführer | 2 Southview Road KT21 2NB Ashtead Surrey | British | Company Director | 34223020001 | |||||
HUGHES, Gary William | Geschäftsführer | 64 Crown Road North Dowanhill G12 9HW Glasgow | Uk | British | Finance Director | 72256160002 | ||||
HUGILL, Charles | Geschäftsführer | Flat 1 89 South Worple Way East Sheen SW14 8NG London | British | Exec | 93557380001 | |||||
JENKINS, Derek William | Geschäftsführer | 10 Beauchamp Road KT8 0PA East Molesey Surrey | British | Company Director | 28267720001 | |||||
SIMS, Martin George Montague | Geschäftsführer | Bow Cottage 27 Germain Street HP5 1LH Chesham Buckinghamshire | British | Company Director | 13950670001 | |||||
TAPSALL, Simon Guy | Geschäftsführer | Sowton Cottage Davis Street Hurst RG10 0TH Reading Berkshire | British | Sales Dir | 53019110001 | |||||
WATT, William George | Geschäftsführer | 7 Millar Grove ML3 9BF Hamilton | Scotland | British | Chartered Accountant | 72664400006 | ||||
WILLIAMSON, Alan Norval | Geschäftsführer | "Balerno 5 Freemans Close Stoke Poges SL2 4ER Slough Bucks | British | Company Director | 44447810001 | |||||
WOODFINE, David George | Geschäftsführer | 58 Patrick Way HP21 9XJ Aylesbury Buckinghamshire | British | Developer | 3180320001 | |||||
WOODWARD, Robert Stanley Lawrence | Geschäftsführer | Crawfordston Farm Maybole KA19 7JS Ayrshire | Scotland | British | Director | 122562020001 |
Hat PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Erstellt am 04. Apr. 2003 Geliefert am 16. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 18. Juli 2002 Geliefert am 24. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 02. Juni 1997 Geliefert am 11. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness, liabilities and obligations which are as at 2ND june 1997 or may at any time thereafter be due, owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee, by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Kurze Angaben First fixed and floating charges over the undertaking and all its property and assets present and future incuding its goodwill and uncalled capital and all plant and machinery. (N.B. the property described in part I and ii of the schedule attached to this form 395 is described as being "none").. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 30. Sept. 1996 Geliefert am 07. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1996 Geliefert am 05. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Loan stock trust deed | Erstellt am 01. Dez. 1995 Geliefert am 14. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the loan stock deed including but not limited to payment of the amount of the principal sum then outstanding on the security of the stock and interest on the amount of such principal sum for the time being outstanding at the rate of 10% per year payable half yearly on 31ST december and 30TH june in the years 1996 1997 and 1998 but at 12% per year in 1999 and 14% in 2000 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Indemnity and debenture | Erstellt am 04. Sept. 1995 Geliefert am 05. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of a guarantee dated 4TH september 1995 | |
Kurze Angaben All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of a guarantee dated 4TH september 1995. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Aug. 1995 Geliefert am 31. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat PRIMELIGHT ADVERTISING LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0