ASPECTS SOFTWARE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASPECTS SOFTWARE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01875584
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASPECTS SOFTWARE LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich ASPECTS SOFTWARE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ASPECTS SOFTWARE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NABETU LIMITED07. Jan. 198507. Jan. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASPECTS SOFTWARE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASPECTS SOFTWARE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Mai 2009

    5 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    legacy

    1 Seiten287

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Mai 2008

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2007

    15 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2006

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    9 Seiten363s

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2005

    18 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    9 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    1 Seiten288b

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2004

    22 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    8 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von ASPECTS SOFTWARE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SF SECRETARIES LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Sekretär
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    78293470002
    SERODON, Didier
    4 Bi8, Rue Gabriel Peri
    78220 Viroglay
    France
    Geschäftsführer
    4 Bi8, Rue Gabriel Peri
    78220 Viroglay
    France
    French101894700002
    MUNRO, Mark Alistair
    Barnton Park View
    EH4 6HJ Edinburgh
    40
    Sekretär
    Barnton Park View
    EH4 6HJ Edinburgh
    40
    British129090870001
    STEWART, Linda Clark
    3 Learmonth Place
    EH4 1AX Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    3 Learmonth Place
    EH4 1AX Edinburgh
    Midlothian
    British6387570001
    STEEDMAN RAMAGE W.S.
    6 Alva Street
    EH2 4QQ Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    6 Alva Street
    EH2 4QQ Edinburgh
    Midlothian
    1198110001
    BROWN, Robert Neil
    10 East Fettes Avenue
    EH4 1DN Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    10 East Fettes Avenue
    EH4 1DN Edinburgh
    Midlothian
    British84839900002
    D'ANGELO, Amedeo
    Casa Sull Adda Arlate Fraz
    Di Calco 23885
    Lecco
    Italy
    Geschäftsführer
    Casa Sull Adda Arlate Fraz
    Di Calco 23885
    Lecco
    Italy
    Italian86701870001
    EDWARDS, David
    Brockweir House
    Brockweir
    NP16 7PE Chepstow
    Gwent
    Geschäftsführer
    Brockweir House
    Brockweir
    NP16 7PE Chepstow
    Gwent
    United KingdomBritish67528660001
    HAMILTON, Giles
    12 Lugton Brae
    EH22 1JX Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    12 Lugton Brae
    EH22 1JX Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish64708510001
    LIVINGSTON, Neil
    82 Pittencrieff Street
    KY12 8AH Dunfermline
    Fife
    Geschäftsführer
    82 Pittencrieff Street
    KY12 8AH Dunfermline
    Fife
    British68266760001
    MACRAE, Alexander Morgan
    Beauly 4 Primrose Bank Road
    EH5 3JH Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Beauly 4 Primrose Bank Road
    EH5 3JH Edinburgh
    Midlothian
    British66177230001
    MUNRO, Mark Alistair
    Barnton Park View
    EH4 6HJ Edinburgh
    40
    Geschäftsführer
    Barnton Park View
    EH4 6HJ Edinburgh
    40
    ScotlandBritish129090870001
    PETKEN, Gavin Christopher
    15 Nightingale Close
    WD7 8NT Radlett
    Herts
    Geschäftsführer
    15 Nightingale Close
    WD7 8NT Radlett
    Herts
    United KingdomBritish72444800002
    STEWART, Ian
    71 Studdridge Street
    SW6 3TD London
    Geschäftsführer
    71 Studdridge Street
    SW6 3TD London
    British50967950001
    STEWART, Linda Clark
    3 Learmonth Place
    EH4 1AX Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    3 Learmonth Place
    EH4 1AX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish6387570001
    STEWART, Neil Millar
    3 Learmonth Place
    EH4 1AX Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    3 Learmonth Place
    EH4 1AX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish1341370001
    WAITE, Gary
    123 Oldwood Place
    EH54 6US Livingston
    West Lothian
    Geschäftsführer
    123 Oldwood Place
    EH54 6US Livingston
    West Lothian
    British68266820001
    WOOD, Nicholas, Mr.
    The White House
    Odell Road, Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    The White House
    Odell Road, Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish70235850001
    DAROY GORDON LIMITED
    103 High Street
    EN8 7AN Waltham Cross
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    103 High Street
    EN8 7AN Waltham Cross
    Hertfordshire
    88236910001
    DAROY GORDON LIMITED
    103 High Street
    EN8 7AN Waltham Cross
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    103 High Street
    EN8 7AN Waltham Cross
    Hertfordshire
    88236910001

    Hat ASPECTS SOFTWARE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 22. Sept. 2004
    Geliefert am 01. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all liens charges options agreements rights and interests in or over land or the proceeeds of sale of land and all buildings fixtures (including trade fixtures) plant and machinery all uncalled capital and goodwill by way of floating charge its undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank Ventures Limited
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 05. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish Equity Partnership
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 18. Juni 1999
    Geliefert am 26. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    Transaktionen
    • 26. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juni 1999
    Geliefert am 08. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juni 1990
    Geliefert am 18. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ASPECTS SOFTWARE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Mai 2008Beginn der Liquidation
    05. Apr. 2010Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praktiker
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0