SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01879848 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?
- Pflegeheime (86102) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Dorset Rise EC4Y 8EN London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GOLDSBOROUGH DEVELOPMENTS LIMITED | 26. März 1985 | 26. März 1985 |
ZEDMORE BUILDING LIMITED | 22. Jan. 1985 | 22. Jan. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Daniel Francis Toner am 06. Juni 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 19. Jan. 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Gordon als Geschäftsführer am 12. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Spire Healthcare Limited als Direktor am 02. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Roger als Geschäftsführer am 02. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Gordon am 01. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Roger am 01. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Roger am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Gordon am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom zum 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 21 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 120 Holborn London EC1N 2TD* am 12. Dez. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONER, Daniel Francis | Sekretär | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 | British | 100270040001 | ||||||||||
TONER, Daniel Francis | Geschäftsführer | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 | United Kingdom | British | Solicitor | 100270040003 | ||||||||
SPIRE HEALTHCARE LIMITED | Geschäftsführer | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 United Kingdom |
| 202359590001 | ||||||||||
BEAZLEY, Nicholas Tetley | Sekretär | The Dower House Westmill SG9 9LY Buntingford Hertfordshire | British | 105797560001 | ||||||||||
MORRIS, David Richard | Sekretär | 22 Lee Lane East Horsforth LS18 5RE Leeds West Yorkshire | British | Finance Director | 64514410001 | |||||||||
WALFORD, Arthur David | Sekretär | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | British | 6658190001 | ||||||||||
BARKER, Hilary Jane | Geschäftsführer | Flat B22 Herbal Hill Gardens 9 Herbal Hill EC1R 5EJ London | British | Finance Director | 62838010001 | |||||||||
BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | The Dower House Westmill SG9 9LY Buntingford Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 105797560001 | ||||||||
BURNS, Robert Ian | Geschäftsführer | 6 Netherfield Road AL5 2AG Harpenden Hertfordshire | England | British | Director | 36584260002 | ||||||||
DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 29367700001 | ||||||||
DE GORTER, Jean Jacques, Dr | Geschäftsführer | Holborn EC1N 2TD London 120 | United Kingdom | French | Director | 128865640001 | ||||||||
DONALD, Alan Charles | Geschäftsführer | 13 Craven Gardens Wimbledon SW19 8LU London | British | Group Financial Controller | 58742090001 | |||||||||
DUGDALE, Michael Ian | Geschäftsführer | 29 Magnolia Dene HP15 7QE Hazlemere Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 79570840001 | |||||||||
ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 40582650004 | ||||||||
FOZARD, Ian | Geschäftsführer | The Old Brewhouse 8a Waterside HG5 9AZ Knaresborough North Yorkshire | England | British | Director | 21934910001 | ||||||||
GORDON, Simon | Geschäftsführer | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 162037020001 | ||||||||
GRAY, Duncan Archibald | Geschäftsführer | 51 Exchange Building 132 Commercial Street E1 6NG London | England | British | Finance & Commercial Director | 68845270002 | ||||||||
GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | Director | 107664270001 | ||||||||
HAYES, Dominic Patrick Thomas | Geschäftsführer | The Old Presbytery Rudding Lane Follifoot HG3 1DQ Harrogate Yorkshire | England | British | Property Director | 126532450001 | ||||||||
HOLDEN, Dean Allan | Geschäftsführer | Spring House Spring Hill Fordcombe TN3 0SE Tunbridge Wells Kent | British | Group Financial Controller | 32671980002 | |||||||||
HOLLINGSWORTH, Clare Margaret | Geschäftsführer | House Farm Crowhurst Lane Crowhurst RH7 6LR Lingfield Mansion Surrey | United Kingdom | British | Managing Director-Hospitals | 62952630002 | ||||||||
JONES, Richard James Edward | Geschäftsführer | Holborn EC1N 2TD London 120 | England | British | Director | 133019680001 | ||||||||
KEE, Fergus Alexander | Geschäftsführer | The Old Cottage Howe Green SG13 8LH Hertford | United Kingdom | Irish | Uk Finance Director | 26911740008 | ||||||||
KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 93897360003 | ||||||||
MORRIS, David Richard | Geschäftsführer | 22 Lee Lane East Horsforth LS18 5RE Leeds West Yorkshire | British | Finance Director | 64514410001 | |||||||||
ROGER, Robert | Geschäftsführer | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 151959030001 | ||||||||
SABOURN, Denis | Geschäftsführer | 35 Boroughbridge Road HG5 0ND Knaresborough North Yorkshire | British | Technical Director | 22209730001 | |||||||||
SMITH, Graham | Geschäftsführer | Moor Lane LS297AF Burley In Wharfedale Briarfield West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 142125320001 | ||||||||
SMITH, Russell Stansfield | Geschäftsführer | 64 Riverside Court Victoria Road BD18 3LZ Shipley Saltaire | British | Director | 809230004 | |||||||||
STEVENS, Geoffrey Robert | Geschäftsführer | Beech House 3 Millhouses Court S11 9HZ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 57380020001 | ||||||||
TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | Accountant | 62846800003 | ||||||||
WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 6658190001 | ||||||||
WHEATON, James Gordon | Geschäftsführer | The Long Barn, Mount Mill Farm Stratford Road, Wicken MK19 6DG Milton Keynes Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 77841040001 | |||||||||
WISE, Robert Jeffrey | Geschäftsführer | Holborn EC1N 2TD London 120 | United Kingdom | Australian | Director | 125754410002 |
Hat SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security accession deed | Erstellt am 22. Okt. 2008 Geliefert am 29. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A supplemental deed to the borrower debenture dated 17 july 2002 | Erstellt am 23. Juli 2005 Geliefert am 03. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsosver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The preference shares all dividends interest and other monies payable in respect. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Juli 2002 Geliefert am 31. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Juli 1996 Geliefert am 20. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Tunbridge wells independent hospital ashurst park fordcombe tunbridge wells t/no K699273 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. März 1996 Geliefert am 12. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or goldsborough healthcare PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a land on the east side of picktree lane washigton tyne & wear sunderland t/n ty 222310. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Sept. 1995 Geliefert am 12. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a harts house harts grove monkhams grove estate snakes lane woodford green. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 25. Sept. 1995 Geliefert am 06. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land & buildings k/a yale hospital croesnewydd road wrexham t/no WA510296 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 25. Sept. 1995 Geliefert am 06. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the medium term loan facility letter dated 21ST july 1995 | |
Kurze Angaben All rights in the work carried out in relation to land at acre street lindley huddersfield. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Okt. 1993 Geliefert am 15. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land on the east side of picktree lane washington tyne & wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 12. Okt. 1992 Geliefert am 21. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in "the debenture" | |
Kurze Angaben Freehold goldsborough nursing home 76 wellington road enfield,middlesex title number ngl 58225 freehold 3 wetherby road,leeds title number WYK381268 1A wetherby road,leeds title number wyk 38221 see doc ref M565C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 09. Okt. 1992 Geliefert am 10. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £7,050 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 134 almsford drive harrogate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Sept. 1992 Geliefert am 15. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1000,00 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 24 wentworth court harrogate north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Juli 1992 Geliefert am 01. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £23,050.00 | |
Kurze Angaben 2 esplanade court, st marys walk, harrogate, north yorkshire and garage. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 1992 Geliefert am 16. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £550 due from the company to the chargees | |
Kurze Angaben Flat 3 grayson house, harrogate, north yorkshire and garage. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 24. Juni 1992 Geliefert am 25. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £ 12,050 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of this deed | |
Kurze Angaben 29 dorchester road,fixby,huddersfield. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Apr. 1992 Geliefert am 21. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £6,550 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 9 grayson house, beech grove, harrogate and garage. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & trust debenture | Erstellt am 06. März 1991 Geliefert am 20. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents and the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben Various properties as defined in form 395 ref M78. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 17. Dez. 1990 Geliefert am 21. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all book and other debts, floating charge or all other the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of charge | Erstellt am 06. Sept. 1989 Geliefert am 11. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from goldsborough limited and/or goldsborough homecare services (pendle) limited and/or goldsborough home care & nursing services limited and/or piper higginson home care limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or account(s) of the company in the bank's books. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Sept. 1987 Geliefert am 04. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or goldsborough limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land having a frontage to ripon rd and swan rd. N. yorks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of charge | Erstellt am 12. Sept. 1985 Geliefert am 02. Okt. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the goldsborough limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0