SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED

SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01879848
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    • Pflegeheime (86102) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GOLDSBOROUGH DEVELOPMENTS LIMITED26. März 198526. März 1985
    ZEDMORE BUILDING LIMITED22. Jan. 198522. Jan. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    A5GHAFCB

    Änderung der Details des Direktors für Mr Daniel Francis Toner am 06. Juni 2014

    2 SeitenCH01
    X58E1643

    legacy

    1 SeitenSH20
    S4Y4BRPU

    Kapitalaufstellung am 19. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19
    L4Y4IHMB

    legacy

    1 SeitenCAP-SS
    S4Y4BRPM

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium cancelled 16/12/2015
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 07. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 12,000,000
    SH01
    X4Y4N7HF

    Beendigung der Bestellung von Simon Gordon als Geschäftsführer am 12. Nov. 2015

    1 SeitenTM01
    X4K0B7S8

    Ernennung von Spire Healthcare Limited als Direktor am 02. Nov. 2015

    2 SeitenAP02
    X4JCUYQP

    Beendigung der Bestellung von Robert Roger als Geschäftsführer am 02. Nov. 2015

    1 SeitenTM01
    X4JFBO14

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    12 SeitenAA
    A4GKW7FN

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Gordon am 01. Juni 2015

    2 SeitenCH01
    X4B6CB9K

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Roger am 01. Juni 2015

    2 SeitenCH01
    X4B3SNYG

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Roger am 01. Juli 2015

    2 SeitenCH01
    X4AQRO9U

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Gordon am 01. Juli 2015

    2 SeitenCH01
    X4AQR20B

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom zum 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ geändert

    1 SeitenAD02
    X43FEYR4

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 12,000,000
    SH01
    X3YFIK1F

    Erfüllung der Belastung 21 vollständig

    4 SeitenMR04
    L3J1BAL6

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    12 SeitenAA
    A3H13EDT

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 09. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 12,000,000
    SH01
    X2Z72MY3

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 120 Holborn London EC1N 2TD* am 12. Dez. 2013

    1 SeitenAD01
    L2MUYPD7

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    12 SeitenAA
    A2GUX9L5

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X1OX2X6S

    Wer sind die Geschäftsführer von SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Sekretär
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    British100270040001
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Geschäftsführer
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritishSolicitor100270040003
    SPIRE HEALTHCARE LIMITED
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer1522532
    202359590001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    British105797560001
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinance Director64514410001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British6658190001
    BARKER, Hilary Jane
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    Geschäftsführer
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    BritishFinance Director62838010001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector105797560001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector36584260002
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector29367700001
    DE GORTER, Jean Jacques, Dr
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Geschäftsführer
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    United KingdomFrenchDirector128865640001
    DONALD, Alan Charles
    13 Craven Gardens
    Wimbledon
    SW19 8LU London
    Geschäftsführer
    13 Craven Gardens
    Wimbledon
    SW19 8LU London
    BritishGroup Financial Controller58742090001
    DUGDALE, Michael Ian
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant79570840001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector40582650004
    FOZARD, Ian
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector21934910001
    GORDON, Simon
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Geschäftsführer
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritishChief Financial Officer162037020001
    GRAY, Duncan Archibald
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    Geschäftsführer
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    EnglandBritishFinance & Commercial Director68845270002
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector107664270001
    HAYES, Dominic Patrick Thomas
    The Old Presbytery
    Rudding Lane Follifoot
    HG3 1DQ Harrogate
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Presbytery
    Rudding Lane Follifoot
    HG3 1DQ Harrogate
    Yorkshire
    EnglandBritishProperty Director126532450001
    HOLDEN, Dean Allan
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    BritishGroup Financial Controller32671980002
    HOLLINGSWORTH, Clare Margaret
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    Geschäftsführer
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director-Hospitals62952630002
    JONES, Richard James Edward
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Geschäftsführer
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    EnglandBritishDirector133019680001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Geschäftsführer
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrishUk Finance Director26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director93897360003
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinance Director64514410001
    ROGER, Robert
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Geschäftsführer
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritishChief Executive Officer151959030001
    SABOURN, Denis
    35 Boroughbridge Road
    HG5 0ND Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    35 Boroughbridge Road
    HG5 0ND Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishTechnical Director22209730001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector142125320001
    SMITH, Russell Stansfield
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    Geschäftsführer
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    BritishDirector809230004
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director57380020001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Geschäftsführer
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritishAccountant62846800003
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishSolicitor6658190001
    WHEATON, James Gordon
    The Long Barn, Mount Mill Farm
    Stratford Road, Wicken
    MK19 6DG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Long Barn, Mount Mill Farm
    Stratford Road, Wicken
    MK19 6DG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant77841040001
    WISE, Robert Jeffrey
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Geschäftsführer
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    United KingdomAustralianDirector125754410002

    Hat SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security accession deed
    Erstellt am 22. Okt. 2008
    Geliefert am 29. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A supplemental deed to the borrower debenture dated 17 july 2002
    Erstellt am 23. Juli 2005
    Geliefert am 03. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsosver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The preference shares all dividends interest and other monies payable in respect. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (as the Borrower Security Trustee for the Borrower Securedcreditors)
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 2002
    Geliefert am 31. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Borrower Security Trustee (as Defined Therein)
    Transaktionen
    • 31. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Juli 1996
    Geliefert am 20. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Tunbridge wells independent hospital ashurst park fordcombe tunbridge wells t/no K699273 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 1996
    Geliefert am 12. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or goldsborough healthcare PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a land on the east side of picktree lane washigton tyne & wear sunderland t/n ty 222310. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Sept. 1995
    Geliefert am 12. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a harts house harts grove monkhams grove estate snakes lane woodford green. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Sept. 1995
    Geliefert am 06. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land & buildings k/a yale hospital croesnewydd road wrexham t/no WA510296 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 25. Sept. 1995
    Geliefert am 06. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the medium term loan facility letter dated 21ST july 1995
    Kurze Angaben
    All rights in the work carried out in relation to land at acre street lindley huddersfield.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Okt. 1993
    Geliefert am 15. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land on the east side of picktree lane washington tyne & wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcas Agent & Trustee for Itself & Each of the Banks (As Defined in the Charge)
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Okt. 1992
    Geliefert am 21. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in "the debenture"
    Kurze Angaben
    Freehold goldsborough nursing home 76 wellington road enfield,middlesex title number ngl 58225 freehold 3 wetherby road,leeds title number WYK381268 1A wetherby road,leeds title number wyk 38221 see doc ref M565C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcin Its Capacity as Agent and Trustee for Itselfand Each of the Banks
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Okt. 1992
    Geliefert am 10. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £7,050 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    134 almsford drive harrogate.
    Berechtigte Personen
    • Vera Woods
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Sept. 1992
    Geliefert am 15. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1000,00 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    24 wentworth court harrogate north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Lady Ruth Madeleine Dawson
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Juli 1992
    Geliefert am 01. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £23,050.00
    Kurze Angaben
    2 esplanade court, st marys walk, harrogate, north yorkshire and garage.
    Berechtigte Personen
    • Jack Woolard
    • Constance Rayner Woolard
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juli 1992
    Geliefert am 16. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £550 due from the company to the chargees
    Kurze Angaben
    Flat 3 grayson house, harrogate, north yorkshire and garage.
    Berechtigte Personen
    • Arthur Knowlson Dytch
    • Sadie Elizabeth Dytch
    Transaktionen
    • 16. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juni 1992
    Geliefert am 25. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £ 12,050 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of this deed
    Kurze Angaben
    29 dorchester road,fixby,huddersfield.
    Berechtigte Personen
    • Faith Waide Crummack
    Transaktionen
    • 25. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 1992
    Geliefert am 21. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £6,550 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    9 grayson house, beech grove, harrogate and garage.
    Berechtigte Personen
    • Joan Pamela Paul
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & trust debenture
    Erstellt am 06. März 1991
    Geliefert am 20. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Various properties as defined in form 395 ref M78.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcas Trustee for Itself
    Transaktionen
    • 20. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 01. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 17. Dez. 1990
    Geliefert am 21. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all book and other debts, floating charge or all other the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    Letter of charge
    Erstellt am 06. Sept. 1989
    Geliefert am 11. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from goldsborough limited and/or goldsborough homecare services (pendle) limited and/or goldsborough home care & nursing services limited and/or piper higginson home care limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or account(s) of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 01. Sept. 1987
    Geliefert am 04. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or goldsborough limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land having a frontage to ripon rd and swan rd. N. yorks.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    Letter of charge
    Erstellt am 12. Sept. 1985
    Geliefert am 02. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the goldsborough limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1985Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0