ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED

ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01880791
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WAYBRASS LIMITED28. Jan. 198528. Jan. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    8 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Aug. 2018

    9 SeitenLIQ03

    Vermögensübersicht

    10 SeitenLIQ02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9BQ England zum 1 Kings Avenue Winchmore Hill London N21 3NA am 08. Sept. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Aug. 2017

    LRESEX

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Notification of Shirley Racher as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC01

    Cessation of Ansgate Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    1 SeitenPSC07

    Geänderte Geschäftsanschrift vom (Suite G9) Springfield House Sandling Road Maidstone Kent ME14 2LP zum Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9BQ am 11. Apr. 2017

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2016

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. März 2016

    Kapitalaufstellung am 17. März 2016

    • Kapital: GBP 396,000
    SH01

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RACHER, Shirley
    2-8 Cossack Street
    ME1 2EF Rochester
    Flat 8
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    2-8 Cossack Street
    ME1 2EF Rochester
    Flat 8
    Kent
    United Kingdom
    British105328320003
    RACHER, Michael
    2-8 Cossack Street
    ME1 2EF Rochester
    Flat 8
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2-8 Cossack Street
    ME1 2EF Rochester
    Flat 8
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish64400330006
    RACHER, Michael
    46 Mount Street
    W1Y 5RD London
    Sekretär
    46 Mount Street
    W1Y 5RD London
    British64400330001
    RACHET, Matthew Alexander
    3 Yew Tree Court
    Littlebourne
    CT3 1TH Canterbury
    Kent
    Sekretär
    3 Yew Tree Court
    Littlebourne
    CT3 1TH Canterbury
    Kent
    British78775990001
    SUTHERLAND, John Alexander
    55a Parson Street
    Hendon
    NW4 1QT London
    Sekretär
    55a Parson Street
    Hendon
    NW4 1QT London
    British13759780001
    BAILY, John Edward
    Queen Anne's Gate
    WS1 9BU London
    21
    Geschäftsführer
    Queen Anne's Gate
    WS1 9BU London
    21
    EnglandEngland151450470001
    FIELD, Martin John
    Bridge Street
    B1 2JR Birmingham
    No. 1 Kings Court 26
    Geschäftsführer
    Bridge Street
    B1 2JR Birmingham
    No. 1 Kings Court 26
    EnglandBritish43428820004
    FIELD, Martin John
    57 Cadogan Gardens
    SW3 2TH London
    Geschäftsführer
    57 Cadogan Gardens
    SW3 2TH London
    British43428820003
    RACHER, Matthew Alexander
    Western Avenue
    ME12 3BS Minster On Sea
    29
    Kent
    Geschäftsführer
    Western Avenue
    ME12 3BS Minster On Sea
    29
    Kent
    U KBritish124950520004
    RACHER, Shirley
    Argrove House
    6 Lansdowne Place
    BA9 9FB Wincanton
    Somerset
    Geschäftsführer
    Argrove House
    6 Lansdowne Place
    BA9 9FB Wincanton
    Somerset
    British105328320001
    RACHER, Timothy Simon
    3 Yew Tree Court
    The Hill
    CT3 1TH Littlebourne
    Kent
    Geschäftsführer
    3 Yew Tree Court
    The Hill
    CT3 1TH Littlebourne
    Kent
    British72435440001
    THOMAS, Gareth Jones
    56 Grosvenor Hill
    W1X 9FA London
    Geschäftsführer
    56 Grosvenor Hill
    W1X 9FA London
    British11926030003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ansgate Plc
    Springfield House
    Sanding Road
    ME14 2LP Maidstone
    Suite G9
    England
    06. Apr. 2016
    Springfield House
    Sanding Road
    ME14 2LP Maidstone
    Suite G9
    England
    Ja
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer03533430
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Shirley Racher
    Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    1
    06. Apr. 2016
    Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    1
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 10. Feb. 2011
    Geliefert am 15. Feb. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the west side of 180 maidstone road chatham t/nos. K972996, K972997 and K972995.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 29. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a cemetery lodge house western avenue minster sheerness t/no: K921166. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 29. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 5 - 8 cpssack street and land at the rear of 9 and 10 cossack street rochester t/no: K919453. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Dez. 2003
    Geliefert am 13. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as land at loewy crescent poole dorset part of t/n DT280700. By way of specific charge the goodwill and connection of the business. By way of floating security all moveable lant, machinery, implements, furniture, equipment, stock-in-trade, work-in-progress & other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h property known as tower house street somerset BA16 0TS t/n ST89683. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Apr. 2002
    Geliefert am 25. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property known as loewy crescent poole dorset t/no;-DT294984. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 24. Apr. 2002
    Geliefert am 25. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Juni 2000
    Geliefert am 14. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a land on the south side of urswick road dagenham t/n EGL393993. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Juni 1996
    Geliefert am 11. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited
    Kurze Angaben
    All that f/h property part of 35 cheriton gardens and 1 and 3 ingles road folkestone kent t/n's KG25591 and K81707 see form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1996
    Geliefert am 05. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or kenside properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south side of barton road dover kent t/n K102319.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juli 1995
    Geliefert am 28. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or worth construction limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    East street nursery east street hythe kent t/n k 735331.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Jan. 1994
    Geliefert am 20. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Jan. 1994
    Geliefert am 20. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    East street nursery east street hythe kent and the goodwill and the connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 21. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land at edred road dover kent t/n K676035. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 1991
    Geliefert am 17. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 35B frindsbury hill strood rochester kent by way of fixed charge all rents and other income.
    Berechtigte Personen
    • Alban Marshall Finance PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Mai 1991
    Geliefert am 22. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the north east side of dorman avenue north aylesham kent adjoining numbers 12/14 dorman avenue north. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Bank P.L.C.
    Transaktionen
    • 22. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Mai 1991
    Geliefert am 22. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the north west and south west of dorman avenue south, aylesham kent formerly k/as aylesham depot. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 22. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat ANSGATE SECURITIES (1985) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Aug. 2017Beginn der Liquidation
    17. Aug. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ninos Koumettou
    Alexander Lawson & Co
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London
    Praktiker
    Alexander Lawson & Co
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0