ADMINSTORE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ADMINSTORE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01882853 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ADMINSTORE LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ADMINSTORE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ADMINSTORE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EUROPA CONVENIENCE STORES LIMITED | 26. Apr. 1985 | 26. Apr. 1985 |
| ADMINSTORE LIMITED | 05. Feb. 1985 | 05. Feb. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ADMINSTORE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Feb. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ADMINSTORE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tesco House, Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 22. Apr. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1GA verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1GA geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. Feb. 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 29. Feb. 2020 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 176 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Ernennung von Lynda Jane Heywood als Direktor am 10. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bruce Marsh als Geschäftsführer am 10. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tesco Services Limited als Geschäftsführer am 10. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 23. Feb. 2019 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ADMINSTORE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESCO SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 182118090001 | ||||||||||
| HEYWOOD, Lynda Jane | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 213408010001 | |||||||||
| WELCH, Robert John | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 212146700001 | |||||||||
| O'KEEFE, Helen Jane | Sekretär | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 96031250001 | ||||||||||
| PATEL, Anil Gunvantbhai | Sekretär | 18 Spinnells Road Rayners Lane HA2 9RA Harrow Middlesex | British | 6518780001 | ||||||||||
| SANKAR, Nadine Amanda | Sekretär | 90 Edbury Road WD1 2SB Watford Hertfordshire | British | 97385340001 | ||||||||||
| BELL, Robbie Ian | Geschäftsführer | 101 Hemp Lane Wigginton HP23 6HE Tring Hertfordshire | United Kingdom | British | 97384120001 | |||||||||
| FIELD, Martin John | Geschäftsführer | 42 Lygean Avenue SG12 7AR Ware Hertfordshire | British | 71986450003 | ||||||||||
| HOLMES, Colin Peter | Geschäftsführer | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 86778500002 | ||||||||||
| IDDON, Michael James | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147746220002 | |||||||||
| LEAHY, Terence Patrick, Sir | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 183358310001 | |||||||||
| LLOYD, Jonathan Mark | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 160028560001 | |||||||||
| MARSH, Adrian Ross Thomas | Geschäftsführer | Delamare Road Cheshunt EN89SL Herts Tesco House England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 157987530001 | |||||||||
| MARSH, Bruce | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | United Kingdom | British | 209704350001 | |||||||||
| MCMEIKAN, Kennedy | Geschäftsführer | Saint Rhadegund Villa 82 Chesterton Road CB4 1ER Cambridge | British | 90169080001 | ||||||||||
| MOORE, Paul Anthony | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | England | British | 194306140002 | |||||||||
| NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms. | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 148079740001 | |||||||||
| PATEL, Jitendrakumar Maganbhai | Geschäftsführer | 2 Hedgeside Road HA6 2NX Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 94807170001 | |||||||||
| PATEL, Maheshkumar Mohanbhai | Geschäftsführer | 9 Poles House Poles Park Hanbury Drive SG12 0UD Thundridge Hertfordshire | United Kingdom | British, | 155258730001 | |||||||||
| PATEL, Nareshkumar Mohanbhai | Geschäftsführer | 15 Broad Walk Winchmore Hill N21 3DA London | British | 6518810001 | ||||||||||
| TESCO SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 175259630001 | ||||||||||
| TESCO SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom |
| 175259630001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ADMINSTORE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesco Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ADMINSTORE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge (corporate) | Erstellt am 28. Feb. 2002 Geliefert am 07. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 53-55 balham hill in the london borough of wandsworth t/n 34912. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Dez. 2001 Geliefert am 06. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 5 croxted road dulwich london SE21. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Dez. 2001 Geliefert am 06. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property 1-3 croxted road dulwich london SE21. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Okt. 2001 Geliefert am 25. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 25 clifton road maida vale london W9. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Okt. 2001 Geliefert am 25. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 21 and 23 clifton road maida vale london W9 t/n NGL543702. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 18. Sept. 1998 Geliefert am 25. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from europa foods limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a europa house northolt industrial estate northolt l/b of ealing t/n NGL75568. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 08. Mai 1997 Geliefert am 20. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re adminstore limited consideration charged business premium account number 10094064. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 08. Mai 1997 Geliefert am 20. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re adminstore limited 90% full drawdown trust business premium account number 50400718. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 08. Mai 1997 Geliefert am 20. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re adminstore limited cash cover charged business premium account number 60895857. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Nov. 1994 Geliefert am 04. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 83 western road brighton t/n SX82457. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Nov. 1994 Geliefert am 04. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a 83 western road in district of brighton and county of east sussex t/n SX82457 together with all buildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Mai 1994 Geliefert am 11. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 83 gloucester road and 18 stanhope mews west london borough of kensington and chelsea t/n NGL573219. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Nov. 1993 Geliefert am 22. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ground floor shop & basement 110 baker street & ground floor shop & basement 112 baker street l/b of westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 25. Apr. 1990 Geliefert am 30. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 468,000 from the company to the chargee under the mortgage conditions | |
Kurze Angaben 53-55 balham hill london T.n- 34912. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Apr. 1990 Geliefert am 26. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 53 and 55 balham hill title no 34912 tog with all plant and machinery the goodwill of the business and the benefit of licenses held. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 29. März 1990 Geliefert am 10. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Juli 1989 Geliefert am 24. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Juli 1989 Geliefert am 12. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a europe house northolt industrial estate northolt middlesex title no ngl 75568 tog with all buildings & fixtures and the goodwill of the business and the benefit of licenses held. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Mai 1989 Geliefert am 13. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property at 83, western road, brighton & all fixtures title no sx 87457 & goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 06. Apr. 1989 Geliefert am 12. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H land with warehouse & office premises formerly k/a the beecham building rowdell road western avenue northolt middlesex title no ngl 75568. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further charge | Erstellt am 10. Juni 1988 Geliefert am 13. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H warehouse and offices (formerly beechams buildings) rowdell road western avenue north west middlesex title no ngl 75568. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 10. März 1988 Geliefert am 14. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 1,800,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed. | |
Kurze Angaben F/H warehouse & offices (formerly beechams building) rowdell road, western ave northolt, middlesex ngl 75568. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee debenture | Erstellt am 31. Jan. 1986 Geliefert am 11. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. März 1985 Geliefert am 18. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Please see doc M8. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ADMINSTORE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0