NEW DAWN GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNEW DAWN GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01885114
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NEW DAWN GROUP LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich NEW DAWN GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Mary Street House
    Mary Street
    TA1 3NW Taunton
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEW DAWN GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis01. Okt. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für NEW DAWN GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Juni 2017

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Whiteoaks Farm the Old Sidings Corsham Road Lacock Wiltshire SN15 2LZ zum Mary Street House Mary Street Taunton TA1 3NW am 21. Juni 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Okt. 2016

    11 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von James David Sheppard als Geschäftsführer am 19. Juni 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James David Sheppard als Sekretär am 19. Juni 2017

    1 SeitenTM02

    Erfüllung der Belastung 018851140029 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 018851140030 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 27 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 018851140028 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 26 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 25 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    7 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 018851140031 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 03. Okt. 2015

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 018851140031, erstellt am 18. Apr. 2016

    35 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 018851140030, erstellt am 18. Apr. 2016

    10 SeitenMR01

    Ernennung von Mr Adrian David Gott als Direktor am 18. Apr. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. März 2016

    Kapitalaufstellung am 11. März 2016

    • Kapital: GBP 6,729.9
    SH01

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 26

    5 SeitenMR05

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 27

    8 SeitenMR05

    Wer sind die Geschäftsführer von NEW DAWN GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOTT, Adrian David
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish111647120004
    ANDREWS, Colin William
    Inver Cottage Maple Walk
    Bexhill
    TN39 4SR Bexhill On Sea
    East Sussex
    Sekretär
    Inver Cottage Maple Walk
    Bexhill
    TN39 4SR Bexhill On Sea
    East Sussex
    British6845410001
    HAYTER, Bruce Norman Frank
    22 Charleston Road
    Old Town
    BN21 1SF Eastbourne
    East Sussex
    Sekretär
    22 Charleston Road
    Old Town
    BN21 1SF Eastbourne
    East Sussex
    British34474000001
    REDMAN, Nicholas James
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    Sekretär
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    British74444770001
    SHEPPARD, James David
    Whiteoaks Farm
    The Old Sidings Corsham Road
    SN15 2LZ Lacock
    Wiltshire
    Sekretär
    Whiteoaks Farm
    The Old Sidings Corsham Road
    SN15 2LZ Lacock
    Wiltshire
    147724350001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    Sekretär
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    British104835460001
    HAYTER, Bruce Norman Frank
    22 Charleston Road
    Old Town
    BN21 1SF Eastbourne
    East Sussex
    Geschäftsführer
    22 Charleston Road
    Old Town
    BN21 1SF Eastbourne
    East Sussex
    EnglandBritish34474000001
    KENT, Michael Richard John
    Horizon Poultry Farm
    Tremar
    PL14 6EA Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Horizon Poultry Farm
    Tremar
    PL14 6EA Liskeard
    Cornwall
    British67069980001
    MARTIN, George William
    Bemzells Cottage
    Trolliloes Cowbeech
    BN27 4QN Hailsham
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Bemzells Cottage
    Trolliloes Cowbeech
    BN27 4QN Hailsham
    East Sussex
    United KingdomBritish25595510001
    MUIR, Graham Dennis
    66 Warren Drive
    RH13 9GL Southwater
    West Sussex
    Geschäftsführer
    66 Warren Drive
    RH13 9GL Southwater
    West Sussex
    British83795060001
    PARKER, Andrew John
    Pastures
    Flowers Green
    BN27 1RJ Herstmonceux
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Pastures
    Flowers Green
    BN27 1RJ Herstmonceux
    East Sussex
    British6769410001
    PARSONS, Paul Gray
    10 Beachy Head Road
    BN20 7QP Eastbourne
    East Sussex
    Geschäftsführer
    10 Beachy Head Road
    BN20 7QP Eastbourne
    East Sussex
    British1975400001
    REDMAN, Nicholas James
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    Geschäftsführer
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    British74444770001
    ROGERS, Nicholas Ian
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    British42807600003
    SHEPPARD, James David
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    United KingdomBritish123411450001
    VELLINO, Max
    Pippins Hadlow Stair
    TN10 4HD Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Pippins Hadlow Stair
    TN10 4HD Tonbridge
    Kent
    British27952340001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NEW DAWN GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Stonegate Farmers Ltd
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    06. Apr. 2016
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer00740635
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat NEW DAWN GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Apr. 2016
    Geliefert am 28. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Pamela Jane Corbett
    • Richard Gerard Heaton Corbett
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Apr. 2016
    Geliefert am 21. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 2015
    Geliefert am 04. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 2015
    Geliefert am 03. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Each company with full title guarantee hereby charges its credit balances to the bank to secure repayment of the secured obligations.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 03. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Denlark farm hinton lane steeple ashton trowbridge (also k/a new dawn farm) wilts t/no WT150331,portfield farm portfield lane curry rivel langport somerset t/no WS13948 and keinton mandeville rearing farm keinton yeovil somerset (also k/a land at lyford) t/no WS13947 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Aug. 2015Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 09. März 2016Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2016Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 05. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property and all buildings and fixtures from time to time thereon known as keinton mandeville rearing farm keinton yeovil somerset (also known as land at lyford) t/n WS13947.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 05. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property and all buildings and fixtures from time to time thereon known as land at portfield farm portfield lane curry rivel langport somerset t/n WS13948.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 05. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property and all buildings and fixtures from time to time thereon known as denlark farm hinton lane steeple ashton trowbridge (also known as new dawn farm) t/n WT150331.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 05. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Feb. 2005
    Geliefert am 18. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property at new dawn farm, hinton lane, steeple, ashton t/n WT150331. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 29. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Okt. 2004
    Geliefert am 26. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property land on the south side of portfield lane,curry rivel,t/no WS13948. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Aug. 2004
    Geliefert am 24. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at west lydford t/n WS13947,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 2001
    Geliefert am 01. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or stonegate farmers limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at fosseway farm (plot 14) west lydford somerset (alson k/a keinton mandeville).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 2001
    Geliefert am 01. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or stonegate farmers limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at portfield curry rivel portfield somerset.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2001
    Geliefert am 18. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or stonegate farmers limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    New dawn farm, hinton lane, steeple ashton, wiltshire t/n WT150331.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 09. Okt. 2001
    Geliefert am 18. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 1994
    Geliefert am 19. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at fosseway farm west lydford somerset with fixtures fittings.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 1994
    Geliefert am 19. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property fronting hinton lane steeple ashton wiltshire and land at steeple ashton with goodwill fixtures and fittings.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 1994
    Geliefert am 19. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at curry rivel somerset with goodwill fixtures fittings.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 1994
    Geliefert am 19. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at langport industrial estate and plots 5,6,7,8 and other property at the estate langport somerset with goodwill fixtures fittings.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 04. Feb. 1994
    Geliefert am 09. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NEW DAWN GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Okt. 2018Aufgelöst am
    30. Juni 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Laurence George Russell
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset
    Praktiker
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0