WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01886368 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Nov. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Neil Garth Jones als Direktor am 01. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rebecca Adele Horne als Geschäftsführer am 01. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY zum 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN am 05. Aug. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY England zum 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY am 19. Okt. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Rebecca Adele Horne als Direktor am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alison Jane Clarke als Geschäftsführer am 14. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD zum 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY am 03. Juli 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Alison Jane Clarke als Direktor am 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sally-Ann Patricia Withey als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Neil Garth | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | England | British | Finance Director | 204774750001 | ||||
MORROW, Martin | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 167225950001 | ||||
CULVER EVANS, Philip Frederick | Sekretär | Bradfield Cottage Bradfield Willand EX15 2RA Cullompton Devon | British | Accountant | 93870000001 | |||||
HATFIELD, Adam George Roland | Sekretär | Old Berkeley Cottage Common Road WD3 5LW Chorleywood Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 84503340001 | |||||
LAWSON, David Sydney | Sekretär | 15 Montford Mews Hazlemere HP15 7FR High Wycombe Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 69676920003 | |||||
LEES, Jennifer Kathryn | Sekretär | 15-17 Huntsworth Mews NW1 6DD London | British | 24587010002 | ||||||
LEVINE, Eric Grant | Sekretär | 50 Park Court Chandos Way NW11 London | South African | 20719550001 | ||||||
LEVINE, Roy Maurice | Sekretär | 3 Falcon Lodge Oak Hill Park NW3 7LD London | British | Business Consultant | 48417780002 | |||||
WHITE, Jeremy Mark | Sekretär | 14 Parkway Ratton BN20 9DX Eastbourne Sussex | British | Chartered Accountant | 51297980001 | |||||
ADAMS, Colin Raymond | Geschäftsführer | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | England | British | Finance Director | 39245820011 | ||||
BENTON, Peter | Geschäftsführer | Northgate House Highgate Hill N6 5HD London | British | Company Director | 7307620001 | |||||
BROADHEAD, Tymon Piers | Geschäftsführer | Huntsworth Mews NW1 6DD London 15-17 | England | British | Accountant | 105342600002 | ||||
CLARKE, Alison Jane | Geschäftsführer | London Wall Buildings EC2M 5SY London 3 England | United Kingdom | British | Company Director | 93418210001 | ||||
CULVER EVANS, Philip Frederick | Geschäftsführer | Bradfield Cottage Bradfield Willand EX15 2RA Cullompton Devon | United Kingdom | British | Accountant | 93870000001 | ||||
DICKIE, Nigel Hugh | Geschäftsführer | The Old Lodge 2 Saint Marys Road KT22 8EU Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Managing Director | 126167930001 | ||||
DURDEN-SMITH, Neil | Geschäftsführer | 28 Hillway Highgate N6 6HH London | British | Company Director | 3116540001 | |||||
FLOWER, Jennie | Geschäftsführer | 40 Stanley Hill HP7 9HL Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | Finance Director | 79244890002 | ||||
HARDING, Colin Michael | Geschäftsführer | 2 Shaw Park Wellington Chase RG45 7QL Crowthorne Berkshire | England | British | Pr Executive | 73968770001 | ||||
HORNE, Rebecca Adele | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | United Kingdom | British | Accountant | 188956200001 | ||||
LEVINE, Eric Grant | Geschäftsführer | 50 Park Court Chandos Way NW11 London | South African | Business Consultant | 20719550001 | |||||
LEVINE, Roy Maurice | Geschäftsführer | 3 Falcon Lodge Oak Hill Park NW3 7LD London | British | Business Consultant | 48417780002 | |||||
MAGNIN, Roland Eugene Gaston | Geschäftsführer | 6 St Johns Villas Kensington Green W8 5UQ London | French | Business Consultant | 53141790001 | |||||
NIELD, Ashley Robert | Geschäftsführer | 50 Lower Mortlake Road TW9 2LW Richmond Surrey | British | Public Relations Executive | 76615790001 | |||||
PALMER, George Frederick Douglas | Geschäftsführer | 27 West Heath Gardens NW3 7TR London | British | Business Consultant | 20719560001 | |||||
PALMER, George Frederick Douglas | Geschäftsführer | 27 West Heath Gardens NW3 7TR London | British | Business Consultants | 20719560001 | |||||
SELMAN, Roger Malcolm | Geschäftsführer | 5 Vineries Bank Milespit Hill Mill Hill NW7 2RP London | United Kingdom | British | Finance Director | 10691510002 | ||||
SLEE, Crispin David | Geschäftsführer | 4 Hill House Court Off Fosters Booth Road Pattishall NN12 8JN Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 46564370002 | ||||
THOMAS, Kevin Hugh | Geschäftsführer | Thorington Close Great Notley CM77 7XE Braintree 5 Essex United Kingdom | British | Finance Director | 131085020001 | |||||
WITHEY, Sally-Ann Patricia | Geschäftsführer | Huntsworth Mews NW1 6DD London 15-17 | England | British | Group Finance Director | 109428260052 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huntsworth Investments Limited | 06. Apr. 2016 | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and | Erstellt am 24. Apr. 2007 Geliefert am 15. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 03. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 20. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and | Erstellt am 12. Aug. 2005 Geliefert am 26. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and | Erstellt am 27. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus letter of set-off | Erstellt am 18. Okt. 2004 Geliefert am 19. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any su or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank, either in sterling or any other currency. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an onmibus letter of set-off dated 13 july 2001 | Erstellt am 18. Mai 2004 Geliefert am 21. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any accounts of the companies or any of them. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of deposit and charge | Erstellt am 12. Okt. 1995 Geliefert am 25. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over securities | Erstellt am 03. Okt. 1995 Geliefert am 24. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Portfolio of securities (stocks,shares,bonds etc) held under an investment management agreement with james capel £ co.limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0