WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED

WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01886368
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8th Floor, Holborn Gate
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share prem a/c 21/11/2018
    RES13

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 26. Nov. 2018

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    7 SeitenAA

    Ernennung von Mr Neil Garth Jones als Direktor am 01. Juli 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Rebecca Adele Horne als Geschäftsführer am 01. Juli 2016

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY zum 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN am 05. Aug. 2016

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 216
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY England zum 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY am 19. Okt. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    3 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Ernennung von Mrs Rebecca Adele Horne als Direktor am 01. Juli 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Alison Jane Clarke als Geschäftsführer am 14. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD zum 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY am 03. Juli 2015

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Ms Alison Jane Clarke als Direktor am 31. Dez. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Sally-Ann Patricia Withey als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 07. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 216
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JONES, Neil Garth
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Geschäftsführer
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    EnglandBritishFinance Director204774750001
    MORROW, Martin
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Geschäftsführer
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant167225950001
    CULVER EVANS, Philip Frederick
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    Sekretär
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    BritishAccountant93870000001
    HATFIELD, Adam George Roland
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    Sekretär
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant84503340001
    LAWSON, David Sydney
    15 Montford Mews
    Hazlemere
    HP15 7FR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Sekretär
    15 Montford Mews
    Hazlemere
    HP15 7FR High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant69676920003
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Sekretär
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    LEVINE, Eric Grant
    50 Park Court
    Chandos Way
    NW11 London
    Sekretär
    50 Park Court
    Chandos Way
    NW11 London
    South African20719550001
    LEVINE, Roy Maurice
    3 Falcon Lodge
    Oak Hill Park
    NW3 7LD London
    Sekretär
    3 Falcon Lodge
    Oak Hill Park
    NW3 7LD London
    BritishBusiness Consultant48417780002
    WHITE, Jeremy Mark
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    Sekretär
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    BritishChartered Accountant51297980001
    ADAMS, Colin Raymond
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Geschäftsführer
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishFinance Director39245820011
    BENTON, Peter
    Northgate House
    Highgate Hill
    N6 5HD London
    Geschäftsführer
    Northgate House
    Highgate Hill
    N6 5HD London
    BritishCompany Director7307620001
    BROADHEAD, Tymon Piers
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Geschäftsführer
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritishAccountant105342600002
    CLARKE, Alison Jane
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    Geschäftsführer
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    United KingdomBritishCompany Director93418210001
    CULVER EVANS, Philip Frederick
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    Geschäftsführer
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    United KingdomBritishAccountant93870000001
    DICKIE, Nigel Hugh
    The Old Lodge
    2 Saint Marys Road
    KT22 8EU Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Old Lodge
    2 Saint Marys Road
    KT22 8EU Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director126167930001
    DURDEN-SMITH, Neil
    28 Hillway
    Highgate
    N6 6HH London
    Geschäftsführer
    28 Hillway
    Highgate
    N6 6HH London
    BritishCompany Director3116540001
    FLOWER, Jennie
    40 Stanley Hill
    HP7 9HL Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    40 Stanley Hill
    HP7 9HL Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Director79244890002
    HARDING, Colin Michael
    2 Shaw Park
    Wellington Chase
    RG45 7QL Crowthorne
    Berkshire
    Geschäftsführer
    2 Shaw Park
    Wellington Chase
    RG45 7QL Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritishPr Executive73968770001
    HORNE, Rebecca Adele
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Geschäftsführer
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritishAccountant188956200001
    LEVINE, Eric Grant
    50 Park Court
    Chandos Way
    NW11 London
    Geschäftsführer
    50 Park Court
    Chandos Way
    NW11 London
    South AfricanBusiness Consultant20719550001
    LEVINE, Roy Maurice
    3 Falcon Lodge
    Oak Hill Park
    NW3 7LD London
    Geschäftsführer
    3 Falcon Lodge
    Oak Hill Park
    NW3 7LD London
    BritishBusiness Consultant48417780002
    MAGNIN, Roland Eugene Gaston
    6 St Johns Villas
    Kensington Green
    W8 5UQ London
    Geschäftsführer
    6 St Johns Villas
    Kensington Green
    W8 5UQ London
    FrenchBusiness Consultant53141790001
    NIELD, Ashley Robert
    50 Lower Mortlake Road
    TW9 2LW Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    50 Lower Mortlake Road
    TW9 2LW Richmond
    Surrey
    BritishPublic Relations Executive76615790001
    PALMER, George Frederick Douglas
    27 West Heath Gardens
    NW3 7TR London
    Geschäftsführer
    27 West Heath Gardens
    NW3 7TR London
    BritishBusiness Consultant20719560001
    PALMER, George Frederick Douglas
    27 West Heath Gardens
    NW3 7TR London
    Geschäftsführer
    27 West Heath Gardens
    NW3 7TR London
    BritishBusiness Consultants20719560001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Geschäftsführer
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishFinance Director10691510002
    SLEE, Crispin David
    4 Hill House Court
    Off Fosters Booth Road Pattishall
    NN12 8JN Towcester
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    4 Hill House Court
    Off Fosters Booth Road Pattishall
    NN12 8JN Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector46564370002
    THOMAS, Kevin Hugh
    Thorington Close
    Great Notley
    CM77 7XE Braintree
    5
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Thorington Close
    Great Notley
    CM77 7XE Braintree
    5
    Essex
    United Kingdom
    BritishFinance Director131085020001
    WITHEY, Sally-Ann Patricia
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Geschäftsführer
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritishGroup Finance Director109428260052

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Huntsworth Investments Limited
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    06. Apr. 2016
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Nein
    RechtsformLimited Liability Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006 (As Amended)
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer01894682
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat WOODSIDE COMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Erstellt am 24. Apr. 2007
    Geliefert am 15. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004
    Erstellt am 16. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Erstellt am 12. Aug. 2005
    Geliefert am 26. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Erstellt am 27. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 18. Okt. 2004
    Geliefert am 19. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any su or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank, either in sterling or any other currency.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of admission to an onmibus letter of set-off dated 13 july 2001
    Erstellt am 18. Mai 2004
    Geliefert am 21. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any accounts of the companies or any of them.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit and charge
    Erstellt am 12. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over securities
    Erstellt am 03. Okt. 1995
    Geliefert am 24. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Portfolio of securities (stocks,shares,bonds etc) held under an investment management agreement with james capel £ co.limited.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank Limited
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0