SLG REALISATIONS PLC
Überblick
Unternehmensname | SLG REALISATIONS PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 01890236 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SLG REALISATIONS PLC?
- (7240) /
Wo befindet sich SLG REALISATIONS PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place London SE1 2AF |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SLG REALISATIONS PLC?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SMARTLOGIK GROUP PLC | 06. Juli 2001 | 06. Juli 2001 |
BRIGHT STATION PLC | 05. Mai 2000 | 05. Mai 2000 |
M.A.I.D. PLC | 10. Feb. 1994 | 10. Feb. 1994 |
M.A.I.D. SYSTEMS LIMITED | 27. März 1985 | 27. März 1985 |
MAPOLA LIMITED | 27. Feb. 1985 | 27. Feb. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SLG REALISATIONS PLC?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis |
Welche sind die letzten Einreichungen für SLG REALISATIONS PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Apr. 2012 | 6 Seiten | 4.68 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 3 Seiten | 4.72 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Nov. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Mai 2011 | 6 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Nov. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Mai 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Nov. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Mai 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Nov. 2008 | 7 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Nov. 2008 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 6 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 5 Seiten | 4.68 | ||
Verschiedenes S/S cert.:-release of liquidator | 1 Seiten | MISC | ||
Verschiedenes C/O replacement of liquidator | 37 Seiten | MISC | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 6 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 5 Seiten | 4.68 | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren | 6 Seiten | 4.68 |
Wer sind die Geschäftsführer von SLG REALISATIONS PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIR, James Henry | Geschäftsführer | 31001 Palomares Road Castro Valley California 94552 Usa | American | Software Industry Advisor | 75209650001 | |||||
CANHAM, Simon Anthony Charles | Geschäftsführer | 168 Westwood Road Tilehurst RG31 6LN Reading Berkshire | England | British | Finance Director | 72748180002 | ||||
HILL, Stephen James | Geschäftsführer | Monks Well House Monks Well GU10 1RH Farnham Surrey | British | Director | 68448760002 | |||||
JEFFERIES, David George | Geschäftsführer | Espada 30 Abbots Drive GU25 4SE Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | Director | 73661520003 | ||||
LOMNITZ, Robert Kurt | Geschäftsführer | 25 Aberdare Gardens NW6 3AJ London | United Kingdom | American | Director | 42406160005 | ||||
BALL, Jonathan Andre Stoner | Sekretär | 13 Combemartin Road SW18 5PP London | British | 41360300003 | ||||||
GIBSON, Terence Albert | Sekretär | 5 Lichfield Terrace Cranham RM14 3JD Upminster Essex | British | 82077160001 | ||||||
MATTEY, David Gary | Sekretär | 17 Bryanston Mews West W1 London | British | 7199250001 | ||||||
BARTON, Ian Joseph, Dr | Geschäftsführer | Five Farthings 53 Moorfield Road Duxford CB2 4PP Cambridge Cambridgeshire | British | Investment Manager | 36400650002 | |||||
BURROWS, Graham | Geschäftsführer | 16383 Hillow Road Los Gatos 95032 FOREIGN Ca Usa | American | Director | 61121760001 | |||||
GALT, Jeffery | Geschäftsführer | 14991 Granite Court Saratoga 95070 California FOREIGN Usa | Amercian | Director | 54422140001 | |||||
HUSSEY OF NORTH BRADLEY, Marmaduke James, Lord | Geschäftsführer | Flat 15 47 Courtfield Road SW7 4DB London | British | Director | 53112500002 | |||||
LIEBMAN, Leon Herschel | Geschäftsführer | 2 Neville Terrace SW7 3AT London | American | Consultant | 7399140001 | |||||
MALLER, Steve | Geschäftsführer | 14 Medway Avenue RG23 7DP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | I T Manager | 106577990001 | ||||
MANDER, Michael Stuart | Geschäftsführer | 41 Rivermill Grosvenor Road SW1V 3TN London | England | British | Director | 118843520001 | ||||
MATTEY, David Gary | Geschäftsführer | 10 Royal Avenue SW3 4QF London | England | British | Director | 7199250004 | ||||
MEERS, Jeffrey | Geschäftsführer | Clarence House Herons Corft Old Avenue KT13 0PL Weybridge Surrey | British | Company Director | 77696390001 | |||||
MOLLE, Jason Brooks | Geschäftsführer | 6225 Wakefalls Drive 27587 Wakeforest North Carolina Usa | British | Director | 54932190001 | |||||
MORTON, Ciaran Gregory | Geschäftsführer | 2 Hungerford Road Holloway N7 9LX London | British | Company Director | 58520380001 | |||||
NASH, Bill | Geschäftsführer | 4342 Redwood Avenue 212 Marina Del Ray 90929 California Usa | British | Company Director | 22461030003 | |||||
NASH, Daniel | Geschäftsführer | 87 Blandford Street W1U 8AE London | United Kingdom | Usa | Senior Corporate Adviser | 103470240001 | ||||
SHARP, Anthony Christopher John | Geschäftsführer | Flat 2 105 Oxford Street W1R 1TF London | United Kingdom | British | Company Director | 37199800001 | ||||
SHIPLEY, Marck Alan | Geschäftsführer | 337 Willow Road Menlo Park California 94025 FOREIGN Usa | Usa | Director | 55711240001 | |||||
SMITH, Derek Brian | Geschäftsführer | 83 High Street BA9 9JZ Wincanton Somerset | British | Company Director | 47865160001 | |||||
SOMMERS, Patrick Charles | Geschäftsführer | 3117 Sheridan Road Evanston Illinois 60202 Usa | American | Director | 71479620001 | |||||
SWANK, Richard | Geschäftsführer | 23 Sanford Town Road Redding 06896 Usa | American | Director | 63424980002 | |||||
TEICHMAN, Thomas Alfred | Geschäftsführer | 120 Pavillion Road SW1X 0AX London | England | British | Merchant Banker | 70634260003 | ||||
THOMAS, Allen Lloyd | Geschäftsführer | 3 Chester Street SW1X 7BB London | American | Company Director | 34543780002 | |||||
WAGNER, Daniel Maurice | Geschäftsführer | Flat 1 15 Wedderburn Road NW3 5QS London | United Kingdom | British | Company Director | 15049110003 | ||||
WAGNER, John Reuben | Geschäftsführer | 300 East 56 Street Apartment 19e New York Ny10022 Usa | British | Company Director | 14560990001 |
Hat SLG REALISATIONS PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Erstellt am 12. Juni 2001 Geliefert am 21. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including the bridge facility letter agreement between the company and the chargee of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 17. Aug. 2000 Geliefert am 25. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Initial deposit of £5,000,000 credited to account no.10066883 With the bank and any addition thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 20. Juli 2000 Geliefert am 04. Aug. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the premises known as west wing, latour house, chertsey boulevard, hanworth lane, chertsey, surrey | |
Kurze Angaben A deposit of £75,600 in an interest-bearing deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Nov. 1997 Geliefert am 21. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as M.A.I.d PLC) or any other group company as defined therein to the chargee as defined in the debenture (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of keyman life policies (the "deed") | Erstellt am 13. Nov. 1997 Geliefert am 21. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as M.A.I.D. PLC) 0R any group company as defined therein to the chargee as defined in the deed (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben Full title guarantee unto the security agent the policies and all monies including bonuses.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over accounts | Erstellt am 13. Nov. 1997 Geliefert am 21. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to chase manhattan international limited (as security agent for the security beneficiaries), whether or not the security beneficiaries shall have been an original party to the reelevant transaction, under the terms of this charge over accounts | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all their right title and interest in the charged accounts with the repayment and satisfaction when due of all the secured obligations. Charged accounts-the royal bank of scotland PLC london belgravia branch 24 grosvenor place london SW1X 7HP, sort code-16-00-16, account nos: 1246668; 12466684;91000024; 10036801; maidsyst-USD1; maidsyst-USD12; and maidpro-USD1.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Aug. 1991 Geliefert am 28. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 25. Feb. 1991 Geliefert am 05. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 25-2-91 | |
Kurze Angaben 18 dufferin street l/b islington. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Mai 1990 Geliefert am 04. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £25,000 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Nov. 1985 Geliefert am 04. Dez. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SLG REALISATIONS PLC Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0