UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED

UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameUNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01890289
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    364-366 Kensington High Street
    W14 8NS London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SANCTUARY ARTIST SERVICES LIMITED12. Nov. 200112. Nov. 2001
    SANCTUARY SERVICES LIMITED13. Dez. 199413. Dez. 1994
    THE SANCTUARY GROUP PLC04. Juli 198804. Juli 1988
    SMALLWOOD TAYLOR GROUP PLC17. Juni 198517. Juni 1985
    ORDERWORTH LIMITED27. Feb. 198527. Feb. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 15. Nov. 2016

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 15/11/2016
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    20 SeitenAA

    legacy

    105 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Beendigung der Bestellung von Boyd Johnston Muir als Geschäftsführer am 31. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 23. Juni 2016

    • Kapital: GBP 500,001
    SH01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    11 SeitenAA

    legacy

    135 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 22. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 500,001
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 19. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 500,001
    SH01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    11 SeitenAA

    legacy

    140 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    10 SeitenAA

    legacy

    143 SeitenPARENT_ACC

    Wer sind die Geschäftsführer von UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ABIOYE, Abolanle
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Sekretär
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    British88802330001
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritish163199590001
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United KingdomBritish43836310003
    JOY, Matthew Robert
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    British115905420001
    MILLER, Michael David
    76 Marsworth Avenue
    HA5 4TT Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    76 Marsworth Avenue
    HA5 4TT Pinner
    Middlesex
    British44250870001
    STANDING, Sarah Elizabeth Anne
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    Sekretär
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    British41378870002
    CITY GROUP PLC
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    Sekretär
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    35794270001
    ARLON, Deke
    7 Victoria Grove
    W8 5RW London
    Geschäftsführer
    7 Victoria Grove
    W8 5RW London
    British50584250001
    ASHURST, William Anthony
    Flat 6 Richardsons Mews
    W1T 6BS London
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Flat 6 Richardsons Mews
    W1T 6BS London
    Middlesex
    United KingdomBritish123516100001
    CALDER, Chire Ian
    165-167 High Road
    Willesden
    NW10 2SG London
    Geschäftsführer
    165-167 High Road
    Willesden
    NW10 2SG London
    British16549280001
    CASS, Michael Trevor
    63 Evelyn Drive
    HA5 4RL Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    63 Evelyn Drive
    HA5 4RL Pinner
    Middlesex
    British2320620002
    FRUIN, John Ralph
    41 Court Drive
    UB10 0BN Hillingdon
    Middlesex
    Geschäftsführer
    41 Court Drive
    UB10 0BN Hillingdon
    Middlesex
    British4836400001
    GOODCHILD, Martin Roy
    Spinneymead
    Forest Road East Horsley
    KT24 5DJ Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Spinneymead
    Forest Road East Horsley
    KT24 5DJ Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish29589040001
    HOWE, Duncan Nicholas
    Willowhayne 37 Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Willowhayne 37 Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish4537830001
    MILLER, Michael David
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish44250870002
    MUIR, Boyd Johnston
    Colorado Avenue
    CA 90404 Santa Monica
    2220
    Usa
    Geschäftsführer
    Colorado Avenue
    CA 90404 Santa Monica
    2220
    Usa
    United StatesBritish172824510001
    NAJEEB, Aky
    Darbys
    Church Road Cookham
    SL6 9PR Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Darbys
    Church Road Cookham
    SL6 9PR Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish10689380008
    SMALLWOOD, Roderick Charles
    Courtenay Beach
    Courtenay Terrace
    BN3 2WF Hove
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Courtenay Beach
    Courtenay Terrace
    BN3 2WF Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish43907530003
    TAYLOR, Andrew John
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish54448520001
    WALLACE, Paul Frederick
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    EnglandBritish76655520001

    Hat UNIVERSAL SRG ARTIST SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juni 2002
    Geliefert am 27. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 (the "deed")
    Erstellt am 11. Aug. 2000
    Geliefert am 30. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred to the chargee under the mezzanine documents by any charging company (as defined)
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 45-53 sinclair road, hammersmith, london t/no BGL14049 together with all buildings, fixtures and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998
    Erstellt am 01. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the mezzanine documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All its f/h and l/h interest in the properties being the l/h property k/a 45-53 sinclair road,hammersmith,london t/no BGL14049 together with all buildings,fixtures (excluding in the case of l/h property landlord's fixtures but including other trade fixtures and excluding in the case of f/h property and l/h property which is let or sub-let to a third party,tenant's and trade fixtures and fittings of such third party) and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Okt. 1998
    Geliefert am 17. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Okt. 1998
    Geliefert am 06. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture originally dated 3RD september 1997
    Erstellt am 03. Juli 1998
    Geliefert am 21. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from sanctuary enterprises PLC (borrower) to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 21. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 3 september 1997
    Erstellt am 20. Mai 1998
    Geliefert am 06. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies which are as at 20 may 1998 due or to become due from sanctuary enterprises PLC (the "borrower") to the chargee under the mezzanine loan agreement dated 3 september 1997 whether pursuant to the guarantee as therein defined) or otherwise and all other sums payable pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 06. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Sept. 1997
    Geliefert am 19. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the sanctuary group PLC to the chargeeon any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policies
    Erstellt am 13. Dez. 1991
    Geliefert am 03. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The moneys payable under various life policies (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Dez. 1991
    Geliefert am 03. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • A.J. Taylor and R.C. Smallwood
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Aug. 1989
    Geliefert am 23. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. Feb. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 31. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Dez. 1988
    Geliefert am 15. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Zomba Corporation
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1988Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 31. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 18. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 31.3.88 and/or this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Zomba Corporation
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Apr. 1988Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 11. Feb. 1987
    Geliefert am 26. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The non-appearance cancellation and abandonment insurance policies issued or to be issued pursuant to cover notes issued by stafford knight & co. Limited together with all benefits moneys and advantages that may become payable thereunder or under any substituted policy or policies or under any new policy effected under the provisions thereof. (Please see doc M11/27 feb /ln for full details).
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    Single debenture
    Erstellt am 29. Aug. 1985
    Geliefert am 10. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares securities, patents patent applications trade marks trade names designs, copyrights licences and ancillary and connected rights. (See doc M17 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1985Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0