JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01891395 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | P.O. Box 14, 65 Chartwell Drive Wigston LE18 1AT Leicester Leicestershire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MAXPLY LIMITED | 01. März 1985 | 01. März 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Geänderte Konten für ein ruhendes Unternehmen erstellt bis 31. Dez. 2018 | 3 Seiten | AAMD | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Ernennung von Corporation Service Company (Uk) Limited als Sekretär am 15. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP04 | ||
Beendigung der Bestellung von Horace Vincent Draa Iii als Sekretär am 15. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr. Neil Lawrence Jowsey als Direktor am 07. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ronald Ernst Baarslag als Geschäftsführer am 07. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Ronald Ernst Baarslag als Direktor am 16. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael Kerins als Geschäftsführer am 02. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr. Horace Vincent Draa Iii als Direktor am 01. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Joseph Stanukinas als Sekretär am 31. Juli 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr. Horace Vincent Draa Iii als Sekretär am 01. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Joseph Stanukinas als Geschäftsführer am 31. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr. Paul Joseph Stanukinas als Sekretär am 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Timothy Ladbrooke als Sekretär am 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von David Lee Rawlinson Ii als Geschäftsführer am 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||
Wer sind die Geschäftsführer von JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATION SERVICE COMPANY (UK) LIMITED | Sekretär | Level 37 Canary Wharf E14 5LQ London 25 Canada Square England |
| 216788570001 | ||||||||||
DRAA III, Horace Vincent, Mr. | Geschäftsführer | P.O. Box 14, 65 Chartwell Drive Wigston LE18 1AT Leicester Leicestershire | United States | American | Business Executive | 236558680001 | ||||||||
JOWSEY, Neil Lawrence, Mr. | Geschäftsführer | P.O. Box 14, 65 Chartwell Drive Wigston LE18 1AT Leicester Leicestershire | England | British | Business Executive | 250475600001 | ||||||||
COOPER, John Gregor | Sekretär | 84 Barrs Road B64 7HH Cradley Heath West Midlands | British | Accountant | 76637230001 | |||||||||
DRAA III, Horace Vincent, Mr. | Sekretär | P.O. Box 14, 65 Chartwell Drive Wigston LE18 1AT Leicester Leicestershire | 236556220001 | |||||||||||
LADBROOKE, Timothy | Sekretär | 8 Cleveland Avenue Long Eaton NG10 2BT Nottingham Nottinghamshire | British | 27305480002 | ||||||||||
SLOCOMBE, Martyn | Sekretär | Abbotsmead 3 Avenue Road WR14 3AG Malvern | British | Solicitor | 18188720002 | |||||||||
SNOWDON, James Muirhead | Sekretär | 141 Bedford Road B75 6DB Sutton Coldfield West Midlands | British | 1735980001 | ||||||||||
STANUKINAS, Paul Joseph, Mr. | Sekretär | P.O. Box 14, 65 Chartwell Drive Wigston LE18 1AT Leicester Leicestershire | 221922740001 | |||||||||||
BAARSLAG, Ronald Ernst | Geschäftsführer | Zevenheuvelenweg 44 5048 An Tilburg Fabory Netherlands | Netherlands | Dutch | Business Executive | 239092020001 | ||||||||
BLEE, John Dominic | Geschäftsführer | Swallow Barn Uphampton WR9 0JS Ombersley Worcestershire | United Kingdom | British | Managing Director | 16792110004 | ||||||||
CURTIS, Peter Eric | Geschäftsführer | 18 Hallam Grange Crescent S10 4BA Sheffield South Yorkshire | England | British | Director | 52931710001 | ||||||||
GREGORY, Michael | Geschäftsführer | Rutland Manor Belton-In-Rutland LE15 9LD Leicestershire | England | British | Director | 152024330001 | ||||||||
KERINS, Michael | Geschäftsführer | 1 Millstream Grange DE72 3TP Borrowash Derbyshire | United Kingdom | British | Director | 68388990005 | ||||||||
NEESON, Brian | Geschäftsführer | 8 Helenslee Court G82 4HT Dumbarton Dunbartonshire | British | Director | 357640001 | |||||||||
NOONAN, James Joseph Michael | Geschäftsführer | 19 Brancaster Close Amington Fields B77 3QD Tamworth Staffordshire | British | Director | 20316600002 | |||||||||
RAWLINSON II, David Lee | Geschäftsführer | P.O. Box 14, 65 Chartwell Drive Wigston LE18 1AT Leicester Leicestershire | England | American | Director | 200641150002 | ||||||||
STANUKINAS, Paul Joseph | Geschäftsführer | P.O. Box 14, 65 Chartwell Drive Wigston LE18 1AT Leicester Leicestershire | Netherlands | American | Director | 205944640001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex Industrial Limited | 19. Mai 2016 | James Street Righead Industrial Estate ML43JY ML4 3JY Belshill Gorman House Lanarkshire Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Erstellt am 28. Juni 2004 Geliefert am 09. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed equitable charge on all discounted debts and other debts and a floating charge on the proceeds of other debts | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 27. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed equitable charge all discounted debts and the other debts and by way of floating charge such of the moneys which the company may receive in respect of the other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 06. Mai 1998 Geliefert am 22. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a unit 17 rowleys green industrial estate rowleys green lane coventry west midlands t/no: WM491234 the goodwill of the business and all licences; floating charge over the present and future. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 06. Mai 1998 Geliefert am 20. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property being l/h land k/a units 1 2 & 3 the middleway industrial estate moseley road highgate t/nos WM440385-WM4450647-WM638185. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 06. Mai 1998 Geliefert am 20. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property being l/h land & buildings k/a unit 6 spring road industrial estate ettingshall wolverhampton t/n WM515346. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 28. Apr. 1995 Geliefert am 04. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 1 middleway industrial estate moseley highgate t/no WM440385 with the goodwill of the business & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 28. Apr. 1995 Geliefert am 04. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 2 middleway industrial estate moseley road highgate t/no WM450647 with the goodwill of the business & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 28. Apr. 1995 Geliefert am 04. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 6 spring road industrial estate ettingshall wolverhampton west midlands t/no WM515346 with the goodwill of the business & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Sept. 1990 Geliefert am 03. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 6 spring road industrial estate, spring road lanesfield wolverhampton west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Okt. 1988 Geliefert am 13. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2, middleway industrial estate, moseley road, highgate birmingham w midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Mai 1988 Geliefert am 11. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 1 middleway industrial estate moseley road highgate birmingham west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Mai 1987 Geliefert am 15. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 13. Juni 1985 Geliefert am 24. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or proceeds of sale fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat JOHN BLEE (TOOLS) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0