HUNTSWORTH (CB) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HUNTSWORTH (CB) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01895906 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HUNTSWORTH (CB) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HUNTSWORTH (CB) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8th Floor, Holborn Gate, 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HUNTSWORTH (CB) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CAPITALBRIDGE LTD. | 02. Aug. 2005 | 02. Aug. 2005 |
CITIGATE JAPAN LIMITED | 17. Juni 2003 | 17. Juni 2003 |
DEWE ROGERSON ASIA LIMITED | 11. Apr. 1995 | 11. Apr. 1995 |
DEWE ROGERSON INTERNATIONAL LIMITED | 15. März 1985 | 15. März 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HUNTSWORTH (CB) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HUNTSWORTH (CB) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 14 Seiten | AA | ||
legacy | 132 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 11 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 115 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 11 Seiten | AA | ||
legacy | 134 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 4 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Neil Garth Jones als Direktor am 01. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Rebecca Adele Horne als Geschäftsführer am 01. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY zum 8th Floor, Holborn Gate, 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN am 21. Juli 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 10 Seiten | AA | ||
legacy | 103 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von HUNTSWORTH (CB) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Neil Garth | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate, England | England | British | Finance Director | 204774750001 | ||||
MORROW, Martin | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate, England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 167225950001 | ||||
BUTTERWORTH, Michael Guy | Sekretär | The Woodman, Howe Street, Great Waltham CM3 1BA Chelmsford | British | 76600500002 | ||||||
LEES, Jennifer Kathryn | Sekretär | 15-17 Huntsworth Mews NW1 6DD London | British | 24587010002 | ||||||
NICHOLS, Richard Stephen | Sekretär | 3a Devonshire Road AL5 4TJ Harpenden Hertfordshire | British | 54128690001 | ||||||
STEEDS, Kevin Barrie | Sekretär | 20 Fortismere Avenue Muswell Hill N10 3BL London | British | Company Director | 14119150003 | |||||
WALSH, Michael Anthony | Sekretär | 106 Lonsdale Drive EN2 7NA Enfield Middlesex | Irish | 7335170001 | ||||||
ADAMS, Colin Raymond | Geschäftsführer | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | England | British | Finance Director | 39245820011 | ||||
BROADHEAD, Tymon Piers | Geschäftsführer | Huntsworth Mews NW1 6DD London 15-17 | England | British | Accountant | 105342600002 | ||||
BUTTERWORTH, Michael Guy | Geschäftsführer | The Woodman, Howe Street, Great Waltham CM3 1BA Chelmsford | England | British | Chartered Accountant | 76600500002 | ||||
CLARKE, Alison Jane | Geschäftsführer | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | England | British | Company Director | 197314680001 | ||||
COLTON, Maurice | Geschäftsführer | 52 Princess Court Queensway W2 4RD London | British | Public Relations Consultant | 43624180001 | |||||
DEWE, Roderick Corrie | Geschäftsführer | 55 Duncan Terrace N1 8AG London | British | Public Relations Consultant | 35733810001 | |||||
HORNE, Rebecca Adele | Geschäftsführer | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate, England | United Kingdom | British | Accountant | 188956200001 | ||||
NICHOLS, Richard Stephen | Geschäftsführer | 15a Rothamsted Avenue AL5 2DD Harpenden Hertfordshire | England | British | Company Director | 54128690003 | ||||
ROGERSON, Nicolas | Geschäftsführer | 4 Redfield Lane SW5 0RG London | England | British | Public Relations Consultant | 14482390002 | ||||
SELMAN, Roger Malcolm | Geschäftsführer | 5 Vineries Bank Milespit Hill Mill Hill NW7 2RP London | United Kingdom | British | Finance Director | 10691510002 | ||||
STEEDS, Kevin Barrie | Geschäftsführer | 20 Fortismere Avenue Muswell Hill N10 3BL London | British | Company Director | 14119150003 | |||||
WALSH, Michael Anthony | Geschäftsführer | 106 Lonsdale Drive EN2 7NA Enfield Middlesex | Irish | Finance Director | 7335170001 | |||||
WITHEY, Sally-Ann Patricia | Geschäftsführer | Huntsworth Mews NW1 6DD London 15-17 | England | British | Chief Operating Officer | 109428260052 | ||||
WRIGHT, David Ernest | Geschäftsführer | The Priory 23 Matham Road KT8 0SX East Molesey Surrey | British | Company Director | 14119160001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HUNTSWORTH (CB) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewe Rogerson Group Limited | 06. Apr. 2016 | 3 London Wall Buildings London Wall EC2M 5SY London 3rd Floor, England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat HUNTSWORTH (CB) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and | Erstellt am 12. Aug. 2005 Geliefert am 26. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and | Erstellt am 27. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as citigate japan limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Okt. 1998 Geliefert am 05. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0