CREST PACKAGING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCREST PACKAGING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01896204
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CREST PACKAGING LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich CREST PACKAGING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Baker Street
    London
    W1U 3LL
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CREST PACKAGING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ELDONGRANT LIMITED18. März 198518. März 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CREST PACKAGING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für CREST PACKAGING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Mitteilung über die Aufhebung des Verwaltungsbeschlusses

    4 Seiten2.19

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    legacy

    2 Seiten403b

    Mitteilung über das Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23

    Vorschlag des Administrators

    37 Seiten2.21

    legacy

    1 Seiten287

    Verwaltungsbeschluss

    4 Seiten2.7

    Mitteilung über den Verwaltungsbeschluss

    1 Seiten2.6

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von CREST PACKAGING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBINSON, David Thomas
    59 Lancaster Drive
    RH19 3XJ East Grinstead
    West Sussex
    Sekretär
    59 Lancaster Drive
    RH19 3XJ East Grinstead
    West Sussex
    British60804830003
    BULLIVANT, Philip
    11 Rivermead
    St Marys Island
    ME4 3JR Chatham
    Kent
    Geschäftsführer
    11 Rivermead
    St Marys Island
    ME4 3JR Chatham
    Kent
    British80893940001
    WEBB, Rodney Anson John
    Angley House Angley Park
    TN17 2PN Cranbrook
    Kent
    Geschäftsführer
    Angley House Angley Park
    TN17 2PN Cranbrook
    Kent
    British2444280002
    BRANCH, Donald Matthew
    79 Chaffes Lane
    ME9 7BG Upchurch
    Kent
    Sekretär
    79 Chaffes Lane
    ME9 7BG Upchurch
    Kent
    British44453330001
    KENNY, Edward Michael
    Boo House West Heath
    Limpsfield Common
    RH8 0QS Oxted
    Surrey
    Sekretär
    Boo House West Heath
    Limpsfield Common
    RH8 0QS Oxted
    Surrey
    Irish47290840001
    LAWTON, Christopher Erskine
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    Sekretär
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    British44540640001
    SUGDEN, Martin Leslie
    23 Station Road
    WD7 8JY Radlett
    Hertfordshire
    Sekretär
    23 Station Road
    WD7 8JY Radlett
    Hertfordshire
    British63057200001
    WEBB, Rodney Anson John
    Angley House Angley Park
    TN17 2PN Cranbrook
    Kent
    Sekretär
    Angley House Angley Park
    TN17 2PN Cranbrook
    Kent
    British2444280002
    WEBB, Rodney Anson John
    Spitzbrook House
    Collier Street
    TN12 9RH Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    Spitzbrook House
    Collier Street
    TN12 9RH Tonbridge
    Kent
    British2444280001
    BOWEN, Bertram Joseph
    1 The Birches
    Iffin Lane
    CT4 7BD Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    1 The Birches
    Iffin Lane
    CT4 7BD Canterbury
    Kent
    British28964390001
    COOK, Roy Joseph
    The Cottage
    The Street, Hartlip
    ME9 7TL Sittingbourne
    Kent
    Geschäftsführer
    The Cottage
    The Street, Hartlip
    ME9 7TL Sittingbourne
    Kent
    British20121740002
    HARMAN, Albert George
    Valley View
    Primrose Lane South Street
    ME9 7QP Stockbury Sittingbourne
    Kent
    Geschäftsführer
    Valley View
    Primrose Lane South Street
    ME9 7QP Stockbury Sittingbourne
    Kent
    British5418190002
    KENNY, Edward Michael
    Boo House West Heath
    Limpsfield Common
    RH8 0QS Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Boo House West Heath
    Limpsfield Common
    RH8 0QS Oxted
    Surrey
    EnglandIrish47290840001
    LAWTON, Christopher Erskine
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    Geschäftsführer
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    British44540640001
    POULTER, John William
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    British4333730002
    STEWART, Ian
    Ross Cottage Common Lane
    Hemmingford Abbots
    PE18 9AN Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Ross Cottage Common Lane
    Hemmingford Abbots
    PE18 9AN Huntingdon
    Cambridgeshire
    British37746850001
    SUGDEN, Martin Leslie
    23 Station Road
    WD7 8JY Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    23 Station Road
    WD7 8JY Radlett
    Hertfordshire
    British63057200001
    TEGNER, Ian Nicol
    44 Norland Square
    W11 4PZ London
    Geschäftsführer
    44 Norland Square
    W11 4PZ London
    United KingdomBritish14223250001
    WEBB, Angela Delys
    Spitzbrook Lodge
    Collier Street
    TN12 9RH Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Spitzbrook Lodge
    Collier Street
    TN12 9RH Tonbridge
    Kent
    British20121730001

    Hat CREST PACKAGING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 30. Mai 2002
    Geliefert am 12. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated bus inv a/c and numbered 06226590 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 05. Nov. 2001
    Geliefert am 15. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Account number: barclays bank PLC re crest packaging limited, sor code: 20-54-11, account number: 30001430. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 05. Nov. 2001
    Geliefert am 15. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Account name: barclays bank PLC re crest packaging limited, sor code: 20-54-11, account number: 30001430. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Dez. 1999
    Geliefert am 15. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company and any group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever pursuant to clause 2.1 of the debenture
    Kurze Angaben
    Land on the east side of hoath lane gillingham kent t/no: K101469 medway skill centre courtenay road gillingham kent t/no: K689661 and land and buildings on the south side of irthlingborough road wellingborough t/no: NN87085 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Macash Limited
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Medway skill centre courteney road gillingham kent t/n K689861.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First guarantee and debenture
    Erstellt am 01. Dez. 1998
    Geliefert am 15. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Apr. 1997
    Geliefert am 10. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the south side of irthlingborough road wellingborough northants.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 15. Dez. 1992
    Geliefert am 29. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See doc ref M1027C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 1992
    Geliefert am 10. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings to the east side of courteney road gillingham kent title no. K101469.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 1987
    Geliefert am 01. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to barclays bank PLC under the terms of a loan facility letter dated 3/9/87.
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the east side of courteney road gillingham kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Mai 1985
    Geliefert am 30. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at courteney road gillingham kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Mai 1985
    Geliefert am 30. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at courteney road gillingham kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 10. Mai 1985
    Geliefert am 21. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or crest flexible packaging limited and/or crest cartons limited to the chargees under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Mercantile Credit Company Limited
    • Barclays Mercantile Industrial Finance Limited
    • Mercantile Leasing Company Limited
    Transaktionen
    • 21. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Mai 1985
    Geliefert am 17. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    • 06. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 10. Mai 1985
    Geliefert am 15. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and/or crest flexible packaging limited and/or crest cartons limited to the chargee under the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    A specific charge on uncalled capital f/hold and l/hold property buildings fixtures plant and machinery and book debts and a floating charge on undertaking and goodwill.
    Berechtigte Personen
    • Bowater Packaging LTD.
    Transaktionen
    • 15. Mai 1985Registrierung einer Belastung

    Hat CREST PACKAGING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Feb. 2003Beginn der Verwaltung
    09. Aug. 2007Verwaltung entlassen
    Verwaltungsordnung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stanley Michaels
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praktiker
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Praktiker
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    2
    DatumTyp
    18. Feb. 2010Abschluss der Liquidation
    25. Juni 2007Antragsdatum
    09. Aug. 2007Beginn der Liquidation
    24. Mai 2010Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon James Michaels
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praktiker
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0