KIDDEM LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKIDDEM LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01896960
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KIDDEM LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich KIDDEM LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KIDDEM LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für KIDDEM LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Christopher James Giles als Geschäftsführer am 05. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Francis Muller als Direktor am 05. Sept. 2011

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Sept. 2011

    Kapitalaufstellung am 07. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 6
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Patricia Kennerley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Aylward als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Christopher James Giles als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    12 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 10. März 2009 bis 31. März 2009

    1 SeitenAA01

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 10. März 2008

    22 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von KIDDEM LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Sekretär
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150375870001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritishSolicitor52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritishDirector63620010002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    BritishDirector63620010002
    WALKER, Thomas George
    Endwood House
    Roman Road
    B74 3AQ Little Aston Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    Endwood House
    Roman Road
    B74 3AQ Little Aston Sutton Coldfield
    West Midlands
    British81332330001
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    Geschäftsführer
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    United KingdomBritishBusiness Development Director59741430002
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritishAccountant149729660001
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Geschäftsführer
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritishPharmacist110727230002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector63620010002
    SPURGIN, Gareth Elphick, Dr
    Heath Farm
    Harvest Close Stoke Heath
    B60 3QS Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Heath Farm
    Harvest Close Stoke Heath
    B60 3QS Bromsgrove
    Worcestershire
    British77956380001
    WALKER, Thomas George
    Endwood House
    Roman Road
    B74 3AQ Little Aston Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Endwood House
    Roman Road
    B74 3AQ Little Aston Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishPharmacist81332330001

    Hat KIDDEM LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 06. Apr. 2006
    Geliefert am 25. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 2006
    Geliefert am 11. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as perry lane pharmacy perry lane bromsgrove t/n HW72557,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 2006
    Geliefert am 11. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as wall heath pharmacy 14 albion parade wall heath kingswinford t/n WM744820,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2001
    Geliefert am 21. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 21 lordwood rd,harbourne,birmingham,west midlands with all plant machinery utensils furniture and equipment thereon.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Mai 2001
    Geliefert am 18. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Nov. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Juni 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 2001
    Geliefert am 03. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property 14 albion parade wall heath kingswinford west midlands together with all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 2000
    Geliefert am 02. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as lillington pharmacy 100 cubbington road lillington leamington spa all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Nov. 2000
    Geliefert am 02. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 325 tettenhall road wolverhampton west midlands t/NSF99731 together with all plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Okt. 2000
    Geliefert am 07. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including perry lane pharmacy bromsgrove,325 tettenhall rd,wolverhampton,1 bromsgrove st,kidderminster,audnan lodge amblecote,stourbridge,79A teme st,tenbury wells,79A turners lane,brierley hill and 25 farren rd,coventry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Nov. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 19. März 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Juni 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Jan. 2000
    Geliefert am 07. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    25 farren road coventry together with all plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time and thereafter.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Apr. 1999
    Geliefert am 15. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7-9 teme street tenbury wells worcestershire. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 1999
    Geliefert am 15. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 7-9 teme street tenbury wells worcestershire, the l/h property k/a audnam pharmacy audnam lodge amblecote stourbridge, the l/h property k/a glade pharmacy 1 bromsgrove street kidderminster (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Nov. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 19. März 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Juni 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Aug. 1998
    Geliefert am 20. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 3 and 4,675 turners lane withymoor village brierley hill west midlands; t/nos WM539864 and WM433437; the goodwill of business and benefit of the licence; any compensation payable; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juni 1995
    Geliefert am 30. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a perry lane pharmacy, perry lane, bromsgrove, hereford and worcester t/no: hw 72557. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Juni 1995
    Geliefert am 30. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Nov. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 19. März 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Juni 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juni 1995
    Geliefert am 30. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a glade pharmacy, 1 bromsgrove street, kidderminster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juni 1995
    Geliefert am 30. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a audnam pharmacy, audnam, wordsley, stourbridge west midlands t/no: WM548738. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on goodwill
    Erstellt am 26. Okt. 1990
    Geliefert am 07. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the goodwill of the business all the beneficial right, title and interest of the company. All licences, trading names, patent trademark copyright or otherwise. Please see form 395 (ref m 20) for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 12. Juni 1989
    Geliefert am 15. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all book and other debts. Floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Juni 1989
    Geliefert am 15. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & premises at perry lane pharmacy, perry lane, bromsgrove, worcestershire title no hw 27040.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1989
    Geliefert am 10. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from albany supplies to the chargee on any account whatsoever and fro the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land and premises perry lane pharmacy, perry lane, bromsgrove, hereford & worcester t/no hw 27040.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Nov. 1987
    Geliefert am 03. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land/pharmacy buildings at perry lane, bromsgrove, worcestershire; t/no.hw 27040 and the procedds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 19. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0