SKI INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSKI INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01898047
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SKI INVESTMENTS LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    15 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 24 Bruton Place London W1J 6NE zum 25 Farringdon Street London EC4A 4AB am 29. Juni 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 23. Dez. 2014

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    13. Jan. 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 17. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    13. Jan. 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    12 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Company business 21/12/2012
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    13. Jan. 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Aron Heller am 18. Okt. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    15 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Carlton House 22a St James's Square London SW1Y 4JH* am 23. Apr. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    13. Jan. 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Michael Stevens als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Stevens als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Ms Heather Anne Curtis als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    13. Jan. 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    13 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Amendment agreement 22/06/2010
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    13. Jan. 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Wer sind die Geschäftsführer von SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CURTIS, Heather Anne
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Sekretär
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    159674600001
    CORRY, Robert John
    Windlesham Mead
    Hatton Hill
    GU20 6AB Windlesham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Windlesham Mead
    Hatton Hill
    GU20 6AB Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish78731860001
    HELLER, John Alexander
    1 Clorane Gardens
    NW3 7PR London
    Geschäftsführer
    1 Clorane Gardens
    NW3 7PR London
    United KingdomBritish72581650001
    HELLER, Michael Aron, Sir
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Geschäftsführer
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    United KingdomBritish44677700001
    GORDON, Ian Alfred
    Apartment 5
    12-18 Hill Street
    W1J 5NH London
    Sekretär
    Apartment 5
    12-18 Hill Street
    W1J 5NH London
    British115651430001
    RATCLIFFE, Alan George
    74 Chancery Lane
    WC2A 1AD London
    Sekretär
    74 Chancery Lane
    WC2A 1AD London
    British78329300001
    STEVENS, Michael Cecil
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    Sekretär
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    British14672850001
    GORDON, Lorraine Denise
    326 Euro Towers
    Block 4 Euro Port Road
    FOREIGN Gibraltar
    Geschäftsführer
    326 Euro Towers
    Block 4 Euro Port Road
    FOREIGN Gibraltar
    British9892200002
    LENNARD, Sharon Gail
    15 Flood Street
    SW3 4PW London
    Geschäftsführer
    15 Flood Street
    SW3 4PW London
    British37034830002
    STEVENS, Michael Cecil
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    Great BritainBritish14672850001

    Hat SKI INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. Sept. 2006
    Geliefert am 26. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 2003
    Geliefert am 30. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Phelps cottage and gateway arcade, 355-357 upper street, islington t/n 238293. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Sept. 2003
    Geliefert am 16. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 35 silver street taunton street somerset title number ST158937. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.Lc.
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Sept. 2003
    Geliefert am 16. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 33 silver street taunton somerset title number ST150618. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 05. Dez. 2000
    Geliefert am 18. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, cgnu PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assigned by way of charge all the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of:38-44 (even nos) middlesex street tower hamlets t/no.LN186341. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 2000
    Geliefert am 18. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, cgnu PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a 38-44 (even nos) middlesex street l/b of tower hamlets t/no.LN186341 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 2000
    Geliefert am 16. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Gateway arcade 355/356/357 upper street islington london t/no;-238293 all buildings fixtures (including trade fixtures), fixed plant and machinery from time to time thereon and all improvements and additions thereto all rental monies togethher with floating charge over undertaking all property and assets of the company not charged by way of fixed charge above.
    Berechtigte Personen
    • Arbuthnot Latham & Co. Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 01. Aug. 1996
    Geliefert am 10. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 38-44 middlesex street london E1 t/n LN186341 with all buildings fixtures fixed plant and machinery the gross rents and licences fees and by way of floating charge all undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Arbuthnot Latham & Co Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 01. Aug. 1996
    Geliefert am 10. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a former public library corporation street taunton somerset including trade fixtures fixed plant and machinery with all gross rents and licence fees and by way of floating charge all undetaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Arbuthnot Latham & Co Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Nov. 1994
    Geliefert am 29. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal mortgage
    Kurze Angaben
    F/H-400 and 402 coldharbour lane brixton t/n-tgl 46674 and assigns the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks, P.L.C.
    • Aib Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral charge
    Erstellt am 31. März 1993
    Geliefert am 15. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £252,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 22 february 1990
    Kurze Angaben
    355,356 and 357 upper street islington. T/n-238293.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over deposits
    Erstellt am 15. Jan. 1991
    Geliefert am 19. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £22 deposited or to be depositetd by the company in the companys account no. 86898/02.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Feb. 1990
    Geliefert am 27. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £188,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Kurze Angaben
    L/H unit 6 chieftain business park, wellingborough, northamptonshire.
    Berechtigte Personen
    • Commercial Union Life Assurance Company LTD
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1990
    Geliefert am 14. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £252,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    Underleasehold premises at 18 and 19 cronin courtyard,corby,northamptonshire.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transaktionen
    • 14. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Nov. 1989
    Geliefert am 22. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31 carlton crescent southampton hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks. PLC.
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Nov. 1989
    Geliefert am 21. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £461,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee, under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H - 31 carlton crescent, southampton hampshire title no hp 195851.
    Berechtigte Personen
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transaktionen
    • 21. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juni 1989
    Geliefert am 20. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Piece or parcel of land k/a units 18/19 cronin courtyard weldon south industrial estate corby northants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Riggs a P Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 1989
    Geliefert am 03. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 31 carlton crescent southampton hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Riggs a P Bank
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 1989
    Geliefert am 03. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 38-44 (even nos) middlesex street, london E1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Riggs a P Bank
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 24. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 1989
    Geliefert am 03. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies from time to time standing to the credit of any current deposit or other account.
    Berechtigte Personen
    • Riggs A.P. Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Feb. 1988
    Geliefert am 25. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on south east side of packhouse road, gerrards cross in the county of buckinghamshire all, stocks, shares, securities. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 24. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Feb. 1988
    Geliefert am 25. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H - 47 high street, tooting london SW17 all, stocks, shares, securities. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1988Registrierung einer Belastung

    Hat SKI INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Dez. 2014Beginn der Liquidation
    21. März 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Karen Ann Spears
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0