INOCO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINOCO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01902327
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INOCO LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich INOCO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INOCO LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INOCO PUBLIC LIMITED COMPANY03. Apr. 198503. Apr. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INOCO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für INOCO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Yvonne Kelsey als Sekretär am 26. Nov. 2021

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 Duke Street C/O Blackfish Capital Ltd, 1st Floor London SW1Y 6BN England zum 2 Duke Street St James's, 1st Floor London SW1Y 6BN am 29. Apr. 2020

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    5 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Savile Row London W1S 3PB zum 2 Duke Street C/O Blackfish Capital Ltd, 1st Floor London SW1Y 6BN am 16. Aug. 2018

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 13. Mai 2016

    • Kapital: GBP 20,651,520
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Harley James Rowland als Geschäftsführer am 31. März 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Mai 2015

    • Kapital: GBP 20,651,520
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 20,651,520
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Blackfish Services 5 Savile Row London W1S 3PB United Kingdom* am 14. Apr. 2014

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von INOCO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBESON, Graham John
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    Geschäftsführer
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    United KingdomBritish147389920001
    BAYLEY, Kate
    143 Erskine Crescent
    N17 9PS London
    Sekretär
    143 Erskine Crescent
    N17 9PS London
    British79510000001
    CAUSTON, Richard Ian
    Shelton
    Rohais, St. Peter Port
    GY1 1YW Guernsey
    Channel Islands
    Sekretär
    Shelton
    Rohais, St. Peter Port
    GY1 1YW Guernsey
    Channel Islands
    British97060270001
    KELSEY, Yvonne
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    Sekretär
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    185118270001
    MILLER, David
    1 Chiltern Road
    SG4 9PL Hitchin
    Hertfordshire
    Sekretär
    1 Chiltern Road
    SG4 9PL Hitchin
    Hertfordshire
    British59650030005
    MILLER, David
    17 Isbets Dale
    Taverham
    NR8 6XA Norwich
    Sekretär
    17 Isbets Dale
    Taverham
    NR8 6XA Norwich
    British59650030002
    SMITH, Michael David Langford
    Flat 10
    77 Clapham Common Southside
    SW4 9DG London
    Sekretär
    Flat 10
    77 Clapham Common Southside
    SW4 9DG London
    South African66613940002
    WOOLRICH, Kevin
    7 Turner Close
    NR18 0NP Wymondham
    Norfolk
    Sekretär
    7 Turner Close
    NR18 0NP Wymondham
    Norfolk
    British47103250002
    YUILL, Andrew
    c/o Blackfish Services
    Savile Row
    W1S 3PB London
    5
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Blackfish Services
    Savile Row
    W1S 3PB London
    5
    United Kingdom
    Other135815640001
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Geschäftsführer
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritish26032950002
    JAMES, Jeremy Edward
    Gaiters Bishops Walk
    Shirley Hills
    CR0 5BA Addington
    Surrey
    Geschäftsführer
    Gaiters Bishops Walk
    Shirley Hills
    CR0 5BA Addington
    Surrey
    British35230430001
    LEAN, Venetia Monique
    Warboys House
    Warboys Road
    KT2 7LS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Warboys House
    Warboys Road
    KT2 7LS Kingston Upon Thames
    Surrey
    LuxembourgBritish121698060001
    MORAN, Derek Joseph
    Dorrien Lodge March Road
    KT13 8XA Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Dorrien Lodge March Road
    KT13 8XA Weybridge
    Surrey
    EnglandCanadian5332280002
    ROBESON, Graham John
    The Old Vicarage
    NR12 9HN East Ruston
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    NR12 9HN East Ruston
    Norfolk
    United KingdomBritish147389920001
    ROWLAND, David John
    3 Zenobia Mansions
    Queens Club Gardens
    W14 9TD London
    Geschäftsführer
    3 Zenobia Mansions
    Queens Club Gardens
    W14 9TD London
    British53183700002
    ROWLAND, David John
    49 Avenue De L Annonciade
    MC98000 Monte-Carlo
    Monaco
    Geschäftsführer
    49 Avenue De L Annonciade
    MC98000 Monte-Carlo
    Monaco
    British53183700001
    ROWLAND, Harley James
    Savile Row
    W1S 3PB London
    5
    England
    Geschäftsführer
    Savile Row
    W1S 3PB London
    5
    England
    LuxembourgBritish125919200005
    ROWLAND, Jonathan David
    24 Lattimer Place
    W4 2UB London
    Geschäftsführer
    24 Lattimer Place
    W4 2UB London
    British55523310001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INOCO LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr David John Rowland
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    06. Apr. 2016
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Guernsey
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat INOCO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Erstellt am 28. Nov. 1995
    Geliefert am 12. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects comprising 65-71 (odd numbers) south bridge street airdrie t/n LAN48752.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1995
    Geliefert am 24. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 923 stockport road levenshulme manchester. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 1995
    Geliefert am 21. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a units 1 & 2 howdenshire way howden humberside. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 11 the walk rochdale greater manchester. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 45 oxford street, ripley derbyshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1 high street leominster hereford and worcester. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the south west side of new road attelborough norfolk (now K.a units 1A and 1B haverscroft industrial estate attelborough norfolk). Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the south eas side of henry lane, bardney lincolnshire (now k/a units 1A, 1B and 2A-e alma martin way industrial estate bardney). Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a units 1A, and 1B and 2A to 2D ruskington small business centre fen road, ruskington, lincolnshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 310 coventry road, small heath birmingham west midlands. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 3 ye market selsdon road croydon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a units 1, 2A, 2B and 5 greenfield park industrial estate willowburn avenue, alnwick northumberland. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 1994
    Geliefert am 20. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 winchley square preston.
    Berechtigte Personen
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 1994
    Geliefert am 20. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 dale street liverpool.
    Berechtigte Personen
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of memorandum of terms of deposit
    Erstellt am 02. Juni 1994
    Geliefert am 07. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All or any sums for the time being deposited by the company to the credit opf the account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transaktionen
    • 07. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 14. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5/7 wellgate rotherham west yorkshire t/no.SYK291226.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 14. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    267 high street sutton l/b of sutton t/no.SGL538728.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 14. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14-18 carlton street castleford west yorkshire t/no.WYK468430.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 14. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 1A-e, 2 & 3 faraday road business park littleport cambs t/no.CB133016.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 14. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    39 euston road morecambe lancs t/no. LA576994.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 14. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5A-e and 6A-d heather road skegness lincs.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 14. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 4A & b and 5A & b fleet road holbeach lincs.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rent
    Erstellt am 07. Dez. 1993
    Geliefert am 21. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a standard security and a floating charge both dated 24TH may 1988
    Kurze Angaben
    All rents and other sums payable under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of rents
    Erstellt am 15. Nov. 1993
    Geliefert am 03. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rents, licences fees and other like sums payable under each and all of the leases underleases and licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Nov. 1993
    Geliefert am 11. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a land and buildings at rink road ryde isle of wight t/nos. IW11248 and IW20145.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0