WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01913362 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TREASURE SEEKER LIMITED | 11. Okt. 1985 | 11. Okt. 1985 |
| LINKTELL LIMITED | 14. Mai 1985 | 14. Mai 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Dez. 2021 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 15. Dez. 2020
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 10 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cornwall Court 19 Cornwall Street Birmingham United Kingdom B3 2DT zum 1 Chamberlain Square Cs Birmingham B3 3AX am 13. März 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Wfw Legal Services Limited als Sekretär am 15. Okt. 2019 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Appold Street London EC2A 2HB zum Cornwall Court 19 Cornwall Street Birmingham United Kingdom B3 2DT am 23. Okt. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mrs Alexis Anne Hay als Direktor am 02. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Michael Walls als Geschäftsführer am 24. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr David Michael Walls als Direktor am 28. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Kenneth Clyne als Geschäftsführer am 29. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAY, Alexis Anne | Geschäftsführer | Kingswells Causeway AB15 8PU Prime Four Business Park Deepwater House Kingswells, Aberdeen Scotland | Scotland | British | 243346130001 | |||||||||
| MARTIN, Ross | Geschäftsführer | Kingswells Causeway Prime Four Business Park AB15 8PU Kingswells Deepwater House Aberdeen United Kingdom | Scotland | British | 166940180001 | |||||||||
| MELDRUM, Colin Campbell Mitchell | Geschäftsführer | Kingswells Causeway, Prime Four Business Park Kingswells AB15 8PU Aberdeen Deepwater House Scotland | Scotland | British | 190331680001 | |||||||||
| ALLAN, Garry Robert | Sekretär | The Cottage, 85 Bridge Street DD10 8AF Montrose Angus | British | 121876430001 | ||||||||||
| BOE, Ketil Eilev | Sekretär | 15 Pine Grove Lake Road SW19 7HD London | British | 66942570001 | ||||||||||
| HERTWIG EIDSHEIM, Linn | Sekretär | Flat 3 49 Netherhall Gardens NW3 5RJ London | Norwegian | 98850230001 | ||||||||||
| JONES, Roger Shelley | Sekretär | 70 Angusfield Avenue AB15 6AT Aberdeen Aberdeenshire | British | 74071600001 | ||||||||||
| MJAALAND, Beate | Sekretär | 33 South Hill Park NW3 2ST London | Norwegian | 85941080002 | ||||||||||
| MONRAD, Anders | Sekretär | 3 West Heath Lodge Branch Hill NW3 7LU London | British | 68078950002 | ||||||||||
| REIN, Toril | Sekretär | Volstadveien 47 Stavanger FOREIGN N-4025 Norway | British | 44868390001 | ||||||||||
| RODSAETHER, Christine | Sekretär | 41 Nansen Road SW11 5NS London | British | 45208540001 | ||||||||||
| SOLBERG HANSEN, Kai | Sekretär | Badehusgaten 9b FOREIGN 1440 Drobak Norway | Norwegian | 40747830001 | ||||||||||
| WFW LEGAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Appold Street EC2A 2HB London 15 United Kingdom |
| 18093320001 | ||||||||||
| BERG, Tore Oddmund | Geschäftsführer | Hovik Veien 86 Bekkestua 1340 Norway | Norwegian | 14296660001 | ||||||||||
| BROWN, Eric Berton | Geschäftsführer | 5822 Woodland Falls Drive Kingwood Texas 77345 United States | American | 79752200001 | ||||||||||
| CAHUZAC, Jean Paul | Geschäftsführer | 6425 Brompton Houston Texas Tx 77005 United States | French | 86624540001 | ||||||||||
| CAMERON, Barry Nicholas | Geschäftsführer | Huntly Street AB10 1SH Aberdeen Langlands House United Kingdom | Scotland | British | 56449460004 | |||||||||
| CAUTHEN, Gregory Lynn | Geschäftsführer | 4528 Maple Street Ballaire Texas 77401 Usa | American | 86622450005 | ||||||||||
| CLYNE, Neil Kenneth | Geschäftsführer | Kingswells Causeway, Prime Four Business Park Kingswells AB15 8PU Aberdeen Deepwater House United Kingdom | United Kingdom | British | 164985600001 | |||||||||
| COLE, Jon Christopher | Geschäftsführer | 5 West Oak Drive Houston Texas 77056 FOREIGN Usa | American | 76189440001 | ||||||||||
| GALTUNG, Sjur | Geschäftsführer | Ankervn 77 FOREIGN N - 0765 Oslo Norway | Norwegian | 64835200001 | ||||||||||
| GLOERSEN, Erik | Geschäftsführer | PO BOX 126 Gjokbakken 6 N 393 Voksenlia Oslo Norway | Norwegian | 44871740001 | ||||||||||
| GULVIK, Per Arne | Geschäftsführer | Haahammerbrautene 100 FOREIGN 4045 Hafrsfjord Norway | Norwegian | 14296680001 | ||||||||||
| HALKETT, Douglas William | Geschäftsführer | 10 Queens Grove AB15 8HE Aberdeen Aberdeenshire Scotland | British | 95348400002 | ||||||||||
| JONES, Roger Shelley | Geschäftsführer | 70 Angusfield Avenue AB15 6AT Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 74071600001 | |||||||||
| KING, Paul Arthur | Geschäftsführer | Huntly Street AB10 1SH Aberdeen Langlands House United Kingdom | Scotland | British | 132951950004 | |||||||||
| LONG, Robert Laverne | Geschäftsführer | 14731 Oak Bend Drive Houston Texas 77079 FOREIGN Usa | American | 72969130001 | ||||||||||
| LUND, Reidar | Geschäftsführer | Melingsiden 26 N-4056 N-4056 Tananger Norway | Norweigian | 5325810001 | ||||||||||
| MCEWEN, David | Geschäftsführer | 12 Campsie Place AB15 6HL Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 36334220001 | |||||||||
| MOLSTAD, Niels Johan | Geschäftsführer | Kyrres Vei 27 FOREIGN Stabekk 1320 Norway | Norwegian | 14554520001 | ||||||||||
| NESS, Christopher Leonard | Geschäftsführer | 36 Hazledene Road AB15 8LD Aberdeen | Scotland | British | 82383670004 | |||||||||
| ROSE, Adrian Paul | Geschäftsführer | Kingswells Causeway Prime Four Business Park AB15 8PU Kingswells Deepwater House Aberdeen United Kingdom | Scotland | British | 163505080001 | |||||||||
| STEENBUCH, Frederik | Geschäftsführer | Dalsveien 57 Oslo 0387 Norway | Norwegian | 32064430001 | ||||||||||
| TARANGER, Henning | Geschäftsführer | Kongshavn 50 FOREIGN 1335 Snaroya Norway | Norwegian | 29702760001 | ||||||||||
| TVETERAAS, Jan Erik | Geschäftsführer | Moringveren 5 4056 Tananger Norway | Norwegian | 112783830001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transocean Ltd. | 06. Apr. 2016 | Turmstrasse CH6300 Zug 30 Switzerland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of insurance | Erstellt am 23. März 1994 Geliefert am 08. Apr. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The obligations of wilrig as under the indenture dated 15TH march 1994 and under the notes (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of covenants of even date and the indenture | |
Kurze Angaben (I) all the company's right title and interest in and to all policies and contracts of insurance taken out in respect of the semi-submersible drilling rig "treasure seeker" registered as a ship under the british flag with official no. 701179 (the rig), its freights and disbursements, profits or otherwise and all the benefits and proceeds thereof, including all claims and returns of premiums; and (ii) all monies or other compensation payable by reason of requisition of title to, seizure of or forfeiture of the rig.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenants | Erstellt am 23. März 1994 Geliefert am 08. Apr. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The obligations of wilrig as under the indenture dated 15TH march 1994 and under the notes (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed of covenants and the other security documents (as defined) | |
Kurze Angaben 64/64 shares in the semi-submersible drilling rig "treasure seeker" registered as a ship under the british flag with official no. 701179 (the rig). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority british statutory ship mortgage | Erstellt am 23. März 1994 Geliefert am 08. Apr. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The obligations of wilrig as under the indenture dated 15TH march 1994 and under the notes (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee under a deed of covenants of even date and the other security documents (as defined) | |
Kurze Angaben 64/64 shares in the semi-submersible drilling rig "treasure seeker" registered as a ship under the british flag with official no. 701179. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenants | Erstellt am 29. Mai 1992 Geliefert am 17. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee dated 29TH may 1992 as may be amended,supplemented,varied or novated | |
Kurze Angaben Assignment of all rights,title and interest in compensation,insurances and earnings (see doc ref M59C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 29. Mai 1992 Geliefert am 17. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee dated 29TH may 1992 | |
Kurze Angaben Sixty-fourths shares in the semi-submersible drilling rig known as the "treasure seeker" official no:701179 and her boats and appurtenances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Ship mortgage | Erstellt am 29. Jan. 1992 Geliefert am 05. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (acting as trustee for the beneficiaries as defined therein) on any account current under the terms of a guarantee dated 8TH august 1990 as amended by the 1990 letter agreements (as defined therein) and the 1992 letter agreement (as defined therein) as may be further amended, supplemented, varied or novated | |
Kurze Angaben Sixty-four sixty-fourths shares of the semi-submersible drilling rig known as the treasure seeker official no.701179 See form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter agreement | Erstellt am 27. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to citibank, N.A. (acting as trustee on behalf of the beneficiaries as defined therein) under the terms of a guarantee dated 8TH august 1990 as amended by the 1990 letter agreements (as defined therein) and the 1992 letter agreement (as defined therein) as may be further amended, supplemented, varied or novated | |
Kurze Angaben All of the company's right title and interest in and to any requisition compensation,all the insurances.the earnings.see form 395 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second priority deed of covenants | Erstellt am 08. Aug. 1990 Geliefert am 22. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the guarantee agreement dated 8/8/90 and this charge. | |
Kurze Angaben Subject to the rights of the prior mortgage all of the owners right title and interest in and to any requisition compensensation insurance and earnings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Statutory ship mortgage | Erstellt am 08. Aug. 1990 Geliefert am 17. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in its capacity as trustee on behalf of the beneficiaries (as defined under the terms of the guarantee agreement dated 8/8/90. | |
Kurze Angaben 64/64TH shares of the semi-submersible drilling rig "treasure seeker" registered in the rigister of british ships at the port of aberdeen official on 701179. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Statutory mortgage | Erstellt am 05. Aug. 1986 Geliefert am 18. Aug. 1986 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant dated 5/8/86. | |
Kurze Angaben 64/64TH shares of and in M.V. treasure seeker registered in the name of the company at the port of aberdeen under official number 701179. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenant | Erstellt am 05. Aug. 1986 Geliefert am 14. Aug. 1986 | Ausstehend | Gesicherter Betrag $23,950,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 5/8/86 and the deed of covenant of even date. | |
Kurze Angaben All the company's right title and benefits present and future M.V. "treasure seeker" official no: 701179. (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Statutory british ship mortgage | Erstellt am 29. Okt. 1985 Geliefert am 10. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a loan agreement dated 6/6/84 and the deed of covenant. | |
Kurze Angaben 64 64TH shares in the semi-submersible drilling rig k/a treasure seeker official no. 701179. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of earnings and insurance | Erstellt am 29. Okt. 1985 Geliefert am 10. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 6/6/84 and the charge. | |
Kurze Angaben The companys right title and interest of the semi-submersible drilling rig "treasure seeker" (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A second priority statutory mortgage | Erstellt am 29. Okt. 1985 Geliefert am 04. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a memorandum of agreement dated 9/10/85 and a deed of covenants dated 29/10/85. | |
Kurze Angaben 64/64TH shares of and in the semi-submersible drilling rig treasure seeker registered in the name of the company at the port of aberdeen official no 701179. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenant | Erstellt am 29. Okt. 1985 Geliefert am 01. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag $40,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a statutory mortgage dated 29/10/85 and the charge. | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and under a) the semi-submersible drilling rig "treasure seekar" registered at the port of aberdeen under official no. 701179 (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WILRIG OFFSHORE (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0