VODAFONE-CENTRAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VODAFONE-CENTRAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01913537 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VODAFONE-CENTRAL LIMITED?
- Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich VODAFONE-CENTRAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VODAFONE-CENTRAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CENTRAL TELECOM UK LIMITED | 06. März 1998 | 06. März 1998 |
| T.E. HOLDINGS LIMITED | 07. Juni 1991 | 07. Juni 1991 |
| CENTRAL TELECOM UK LIMITED | 18. Nov. 1988 | 18. Nov. 1988 |
| SELSDON LIMITED | 14. Mai 1985 | 14. Mai 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VODAFONE-CENTRAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VODAFONE-CENTRAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Ernennung von Mr Prashant Bhagania als Direktor am 23. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Janine Butler als Geschäftsführer am 23. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2020 | 7 Seiten | AA | ||
legacy | 276 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Ernennung von Mrs Janine Butler als Direktor am 23. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Nigel Evans als Geschäftsführer am 23. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 256 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||
Kapitalaufstellung am 06. Juni 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||
Wer sind die Geschäftsführer von VODAFONE-CENTRAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| BHAGANIA, Prashant | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | Indian | 307138650001 | |||||||||
| YORSTON, Andrew Michael | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 257275320001 | |||||||||
| CAMERON, Michael Graeme Stuart | Sekretär | Cound Mill Cound SY5 6AP Shrewsbury Shropshire | British | 87829750001 | ||||||||||
| DAWE-LANE, Patrick John Beachim | Sekretär | Marsh Lane Rowde SN10 1RE Devizes Upper Foxhangers Farm Wiltshire England | Other | 130771170001 | ||||||||||
| MCDOUGALL, Andrew David | Sekretär | The Croft Victoria Street, Yoxall DE13 8NG Burton On Trent Staffordshire | British | 79129420001 | ||||||||||
| SIMPSON-SMITH, John Victor | Sekretär | 28 Mill End Lane Alrewas DE13 7BX Burton On Trent Staffordshire | British | 78027380002 | ||||||||||
| BRAGG, Nicholas Christopher John | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 135817980001 | |||||||||
| BUTLER, Janine | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | England | British | 277534960001 | |||||||||
| CAMERON, Michael Graeme Stuart | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | England | British | 87829750001 | |||||||||
| EVANS, David Nigel | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||||||
| HARRIS, Brian Athol | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | Australian | 135937300001 | |||||||||
| HOPKINS, Curtis Daniel | Geschäftsführer | Hermitage Lane SL4 4AZ Windsor Beech House Berkshire | England | British | 135690710001 | |||||||||
| KELLY, Peter John Anthony | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 135004330001 | |||||||||
| MCDOUGALL, Andrew David | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | British | 79129420001 | ||||||||||
| MCDOUGALL, David William | Geschäftsführer | Fauld Manor, Fauld Lane Fauld, Tutbury DE13 9HS Burton On Trent Staffordshire | British | 7590910002 | ||||||||||
| MCDOUGALL, Pamela Jayne | Geschäftsführer | Fauld Manor Fauld Lane Fauld, Tutbury DE13 9HS Burton On Trent Staffordshire | British | 23450600002 | ||||||||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||||||
| PURKESS, Martin John | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | England | British | 139360020001 | |||||||||
| SCHA*FER, Richard Wolfgang Henry | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 150941520001 | |||||||||
| SIMPSON-SMITH, John | Geschäftsführer | West Cottage Mill End Lane Alrewas DE13 7BX Burton On Trent Staffordshire | British | 78027380001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VODAFONE-CENTRAL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Communications Group Limited | 06. Apr. 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat VODAFONE-CENTRAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 18. Okt. 2006 Geliefert am 27. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 21. März 2003 Geliefert am 04. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from either the company or hsl 136 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. März 2003 Geliefert am 04. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 31. Aug. 1989 Geliefert am 01. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying on the north side of civic way swadlincote derbyshire by way of asignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 26. Juli 1989 Geliefert am 02. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 3, lyttleton court, halesowen west midlands assigns goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. Feb. 1989 Geliefert am 09. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2A, thornborough road coalville, leicestershire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 04. Juni 1987 Geliefert am 12. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0