PROVALIS HEALTHCARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PROVALIS HEALTHCARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01916352 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROVALIS HEALTHCARE LIMITED?
- (5146) /
Wo befindet sich PROVALIS HEALTHCARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Newtech Square Deeside Industrial Park CH5 2NT Deeside Flintshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PROVALIS HEALTHCARE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CORTECS HEALTHCARE LIMITED | 23. März 1998 | 23. März 1998 |
| CANCOR LIMITED | 26. Nov. 1997 | 26. Nov. 1997 |
| ORATOL LIMITED | 28. Mai 1997 | 28. Mai 1997 |
| CORTECS HEALTHCARE LIMITED | 30. Juni 1992 | 30. Juni 1992 |
| CORTECS (CGL) LIMITED | 16. Juni 1989 | 16. Juni 1989 |
| TIL (CGL) LIMITED | 06. Feb. 1987 | 06. Feb. 1987 |
| NEILSON PHARMACEUTICALS LIMITED | 16. Aug. 1985 | 16. Aug. 1985 |
| ASTONEAST LIMITED | 24. Mai 1985 | 24. Mai 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROVALIS HEALTHCARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2005 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROVALIS HEALTHCARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2005 | 17 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2004 | 15 Seiten | AA | ||
legacy | 11 Seiten | 395 | ||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2003 | 14 Seiten | AA | ||
legacy | 9 Seiten | 395 | ||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PROVALIS HEALTHCARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENBURY, Lee | Sekretär | 16 Wakes Meadow Bunbury CW6 9SH Tarporley Cheshire | British | 61478920002 | ||||||
| GREENBURY, Lee | Geschäftsführer | 16 Wakes Meadow Bunbury CW6 9SH Tarporley Cheshire | England | British | 61478920002 | |||||
| NEWCOMB, Peter J | Sekretär | 22 Stoneydeep Twickenham Road TW11 8BL Teddington Middlesex | British | 15907530002 | ||||||
| POCKSON, Jonathan Richard Hayward Hastings | Sekretär | 30 Clare Hill KT10 9NB Esher Surrey | British | 36473670004 | ||||||
| WALKER, Denise Irene | Sekretär | 2c Kings Building King Street CH1 2AJ Chester Cheshire | British | 59174430001 | ||||||
| RB SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 38862050001 | |||||||
| BREAM, Peter Edward | Geschäftsführer | 50 Carrwood Road SK9 5DN Wilmslow Cheshire | England | British | 77236000001 | |||||
| DUFF, James Matthew Nicholson | Geschäftsführer | 167 Burton Road BN21 2RU Eastbourne East Sussex | British | 89111480001 | ||||||
| FLYNN, Michael John, Dr | Geschäftsführer | Dinton Hatherley Road TW9 3LH Richmond Surrey | United Kingdom | British | 66533320001 | |||||
| GOULD, Philip Leon, Dr | Geschäftsführer | Evergreen Benty Heath Lane Willaston CH64 1RZ Neston Cheshire | England | British | 61731570001 | |||||
| HILL, Geoffrey William Roebuck | Geschäftsführer | 7 Shotwick House Shotwick Park, Saughall CH1 6BJ Chester Cheshire | British | 75923490001 | ||||||
| KEELING, David Mark William | Geschäftsführer | 1 Henlle Gardens Gobowen SY11 3NU Oswestry Salop | United Kingdom | British | 66206810001 | |||||
| KIRKBY, Neil Robert Ernest | Geschäftsführer | 5 Dashwood Close Grappenhall WA4 3JA Warrington Cheshire | England | British | 51438040006 | |||||
| LONG, James Martin | Geschäftsführer | 78 Kings Road TW10 6EE Richmond Surrey | England | British | 9729710002 | |||||
| MCAULIFFE, David | Geschäftsführer | 28 New Kings Road Parsons Green SW6 4ST London | Australian | 55330710001 | ||||||
| MILLAR, David Ivor George | Geschäftsführer | Argoed Lodge Alltami Road, Alltami CH7 6RW Mold Clwyd | British | 66206890001 | ||||||
| TRAVERS, Glen Nicholas | Geschäftsführer | Olb Blue School Lower Square TW7 6RL Isleworth Middlesex | Australian | 56201570001 |
Hat PROVALIS HEALTHCARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 05. Apr. 2005 Geliefert am 07. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 22. Feb. 2004 Geliefert am 04. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Okt. 2001 Geliefert am 01. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever) of the chargor to the chargee from time to time under the deed and relevant agreements | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0