ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED

ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01917732
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    • Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen

    Wo befindet sich ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    West Point
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HAYVERN LIMITED27. Juli 198727. Juli 1987
    HAYVERN CONSTRUCTION LIMITED30. Mai 198530. Mai 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2013
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2014
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Dez. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juni 2016

    11 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juni 2015

    9 Seiten4.68

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX zum West Point Old Trafford Manchester M16 9HU am 18. Juli 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Juni 2014

    LRESSP

    Ernennung von Mr Andrew Michael Eastwood als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul Birch als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Nelson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Melvyn Ewell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 11. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 441,001
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2012

    12 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Ernennung von Sherard Secretariat Services Limited als Sekretär

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Paul Birch als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David Foster als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Melvyn Ewell als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Andrew Latham Nelson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ian Fraser als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Arnold als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von John Flood als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Sekretär
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    Geschäftsführer
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    EnglandBritish76116640003
    EASTWOOD, Andrew Michael
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    Geschäftsführer
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    EnglandBritish160883820001
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Sekretär
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    DUNN, Brian
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    British27826460002
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    British36153790001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181213200001
    ATHERTON, Paul Taylor
    44 Molyneux Road
    BL5 3HP Westhoughton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    44 Molyneux Road
    BL5 3HP Westhoughton
    Lancashire
    United KingdomBritish82322300001
    BILLINGTON, David
    55 Molyneux Road
    Westhoughton
    BL5 3UJ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    55 Molyneux Road
    Westhoughton
    BL5 3UJ Bolton
    Lancashire
    British27826470001
    BIRCH, Iain Harvey
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish116126370001
    COLLINS, John
    Copse Haven
    Roundhill Road
    DL2 1QD Hurworth
    County Durham
    Geschäftsführer
    Copse Haven
    Roundhill Road
    DL2 1QD Hurworth
    County Durham
    British95036480001
    DUNN, Brian
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish27826460002
    DUNN, Lorraine
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    British27826490001
    DUNN, Philip
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    British27826480001
    ENTWISTLE, Keith Roy
    2 Cobden Street
    Egerton
    BL7 9SX Bolton
    Geschäftsführer
    2 Cobden Street
    Egerton
    BL7 9SX Bolton
    British51587490001
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Geschäftsführer
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish61515760002
    FLOOD, John Joseph
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish73695830003
    FOSTER, David Neil
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish79227590003
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUk28393850006
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish36153790001
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish36153790001
    JOYCE, Martin John
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish72254420003
    KEOGH, Sean
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish123405900001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish51438040006
    LAVERY, Kevin Gregory
    Old Colony House
    6, South King Street
    M2 6DQ Manchester
    Geschäftsführer
    Old Colony House
    6, South King Street
    M2 6DQ Manchester
    United KingdomBritish115961810003
    MALONEY, John Gerard
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Irish96964980001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish96596920001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Lancaster House
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Lancaster House
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancashire
    United KingdomBritish17129800004
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Geschäftsführer
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritish36191090003
    NEWSOME, William
    36 Burghley Drive
    Bradley Fold
    M26 3XY Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    36 Burghley Drive
    Bradley Fold
    M26 3XY Bolton
    Lancashire
    British84941580001
    O'MALLEY, Desmond Francis
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    British55097840001
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Geschäftsführer
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British25364820002
    PARKER, Gary
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish50372730001
    ROULSTONE, Graham Frank
    Cedar Farm Stone Lane
    Burringham
    DN17 3ND Scunthorpe
    North Lincs
    Geschäftsführer
    Cedar Farm Stone Lane
    Burringham
    DN17 3ND Scunthorpe
    North Lincs
    EnglandBritish112257690001

    Hat ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 18. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 (the "debenture deed of accession")
    Erstellt am 01. Nov. 2001
    Geliefert am 02. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficaries (As Each Termis Defined in the Debenture Deed of Accession)
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 06. März 2000
    Geliefert am 08. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises at queen street/ gas street farnworth bolton greater manchester. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Commercial property security deed
    Erstellt am 05. Mai 1999
    Geliefert am 12. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H- queen street,farnworth,bolton and land and buildings on the west side of gas street farnworth bolton greater manchester.t/nos GM686096 and GM265102.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge deed
    Erstellt am 10. Juli 1990
    Geliefert am 19. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The performance of the companies obligations to robert heyworth group limited under the agreement dated 28/6/90 and in the charge deed.
    Kurze Angaben
    The sum of fifty thousand pounds placed on deposit at national westminster bank 46 market street chorley lancs.
    Berechtigte Personen
    • Robert Heyworth Group Limited
    Transaktionen
    • 19. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 11. Feb. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Sept. 1988
    Geliefert am 15. Sept. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Stocks shares other securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tsb England & Wales PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Juni 2014Beginn der Liquidation
    11. Jan. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Praktiker
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0