MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED

MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01925390
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?

    • Andere Reinigungsdienste (81299) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ground Floor Suite River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MORRIS HOLDINGS (U.K.) LIMITED24. Okt. 200224. Okt. 2002
    PHIL'S CLEAN-UP SERVICES & SUPPLIES LIMITED24. Juni 198524. Juni 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 019253900015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    8 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    8 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    13 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Eintragung der Belastung 019253900015, erstellt am 30. Aug. 2016

    46 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 06. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 350,000
    SH01

    Ernennung von Mr Simon Kenneth Giles als Sekretär am 28. Sept. 2015

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Jonathan Stephen Levine als Direktor am 28. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Ian Saunders als Geschäftsführer am 28. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Saunders als Sekretär am 28. Sept. 2015

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Simon Kenneth Giles als Direktor am 09. März 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Scott Dudley als Geschäftsführer am 12. Feb. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 350,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 25. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 350,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Sekretär
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    201339500001
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Geschäftsführer
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish196768780001
    LEVINE, Jonathan Stephen
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Geschäftsführer
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish19162600001
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    British88908400002
    MCGIVERN, James Patrick
    The Ridge
    CH60 6SP Wirral
    3
    Merseyside
    United Kingdom
    Sekretär
    The Ridge
    CH60 6SP Wirral
    3
    Merseyside
    United Kingdom
    British120346770002
    MORRIS, Gwendoline
    Grange Cottage
    8 Hindford Whittington
    SY11 4NR Oswestry
    Shropshire
    Sekretär
    Grange Cottage
    8 Hindford Whittington
    SY11 4NR Oswestry
    Shropshire
    British19627140001
    SAUNDERS, Mark
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Sekretär
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    167359780001
    SCOBIE, James Martin
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    Sekretär
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    149576740001
    STRATFORD, Frederick
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Sekretär
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    162167240001
    ALSWORTH, Michael Charles
    Highfield House
    Highfield Road, Highfield
    LL11 4US Wrexham
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Highfield House
    Highfield Road, Highfield
    LL11 4US Wrexham
    Clwyd
    British90167570001
    BOYLE, Eugene
    Teach Ban
    Parkside Drive Whittle Le Woods
    PR6 7PL Chorley
    Geschäftsführer
    Teach Ban
    Parkside Drive Whittle Le Woods
    PR6 7PL Chorley
    EnglandBritish106717430001
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish88908400002
    DUDLEY, Scott
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish166551090001
    HARDY-WILSON, Nigel Andrew
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Geschäftsführer
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    EnglandBritish149590930001
    HOWROYD, David Rowan
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    British72333480002
    KNOTT, Henry Robert
    39 Bridgewater Grange
    Preston Brook Runcorn
    WA7 3AL Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    39 Bridgewater Grange
    Preston Brook Runcorn
    WA7 3AL Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish90167500001
    MCGIVERN, James Patrick
    The Ridge
    CH60 6SP Wirral
    3
    Merseyside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Ridge
    CH60 6SP Wirral
    3
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish120346770002
    MORRIS, Gwendoline
    Grange Cottage
    8 Hindford Whittington
    SY11 4NR Oswestry
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Grange Cottage
    8 Hindford Whittington
    SY11 4NR Oswestry
    Shropshire
    British19627140001
    MORRIS, Philip Ivor
    Grange Cottage
    8 Hindford Whittington
    SY11 4NR Oswestry
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Grange Cottage
    8 Hindford Whittington
    SY11 4NR Oswestry
    Shropshire
    British36167620001
    MORRIS, Stephen
    Grange Cottage 8 Hindford
    Whittington
    SY11 4NR Oswestry
    Salop
    Geschäftsführer
    Grange Cottage 8 Hindford
    Whittington
    SY11 4NR Oswestry
    Salop
    British61241190001
    PICKUP, James
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    British35926750001
    READ, Phil
    The Oaks
    Rushden
    SG9 0SN Buntingford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Oaks
    Rushden
    SG9 0SN Buntingford
    Hertfordshire
    British63466290001
    ROSS, John
    4 Gawsworth Close, Eccleston
    St Helens
    WA10 5RF Merseyside
    Geschäftsführer
    4 Gawsworth Close, Eccleston
    St Helens
    WA10 5RF Merseyside
    United KingdomBritish85410970001
    SAUNDERS, Mark Ian
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish139588670003
    SCOBIE, James Martin
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    United KingdomBritish73982880001
    STRATFORD, Frederick Anthony
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Geschäftsführer
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    United KingdomBritish151871680001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Simon Giles
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06. Apr. 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr David Mundell
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06. Apr. 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Jonathan Stephen Levine
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06. Apr. 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Roger Leonard Burdett
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06. Apr. 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 30. Aug. 2016
    Geliefert am 01. Sept. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Feb. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 05. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Capital Partners LLP
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 04. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 04. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Juli 2007
    Geliefert am 17. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2007
    Geliefert am 17. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 20. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as morris holdings (UK) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 2003
    Geliefert am 16. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1,265 square metres approx of land at mile oak industrial estate, maesbury road, oswestry. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 2003
    Geliefert am 16. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the freehold land and the buildings thereon situate at mile oak industrial estate maesbury road oswestry shropshire title numbers SL35598 SL83433. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First fixed charge & floating charge
    Erstellt am 20. Mai 1996
    Geliefert am 23. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all book debts and other debts as are not sold to and bought by the chargee under an agreement dated 20 may 1996 and floating charge on all proceeds of book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transaktionen
    • 23. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Mai 1996
    Geliefert am 18. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Juni 1992
    Geliefert am 18. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Jan. 1991
    Geliefert am 05. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 17. Dez. 1987
    Geliefert am 31. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or phi's janitemal suppliers limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 09. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. März 1986
    Geliefert am 14. März 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1986Registrierung einer Belastung
    • 09. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0