MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01925390 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?
- Andere Reinigungsdienste (81299) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ground Floor Suite River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Kent |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MORRIS HOLDINGS (U.K.) LIMITED | 24. Okt. 2002 | 24. Okt. 2002 |
| PHIL'S CLEAN-UP SERVICES & SUPPLIES LIMITED | 24. Juni 1985 | 24. Juni 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 019253900015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 019253900015, erstellt am 30. Aug. 2016 | 46 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Kenneth Giles als Sekretär am 28. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Stephen Levine als Direktor am 28. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ian Saunders als Geschäftsführer am 28. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Saunders als Sekretär am 28. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Kenneth Giles als Direktor am 09. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Dudley als Geschäftsführer am 12. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILES, Simon Kenneth | Sekretär | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | 201339500001 | |||||||
| GILES, Simon Kenneth | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | England | British | 196768780001 | |||||
| LEVINE, Jonathan Stephen | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | England | British | 19162600001 | |||||
| DOWE, Stephen William | Sekretär | 10 Breary Lane East Bramhope LS16 9BJ Leeds West Yorkshire | British | 88908400002 | ||||||
| MCGIVERN, James Patrick | Sekretär | The Ridge CH60 6SP Wirral 3 Merseyside United Kingdom | British | 120346770002 | ||||||
| MORRIS, Gwendoline | Sekretär | Grange Cottage 8 Hindford Whittington SY11 4NR Oswestry Shropshire | British | 19627140001 | ||||||
| SAUNDERS, Mark | Sekretär | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | 167359780001 | |||||||
| SCOBIE, James Martin | Sekretär | Eastcote BR6 0AU Orpington 1 Kent England | 149576740001 | |||||||
| STRATFORD, Frederick | Sekretär | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | 162167240001 | |||||||
| ALSWORTH, Michael Charles | Geschäftsführer | Highfield House Highfield Road, Highfield LL11 4US Wrexham Clwyd | British | 90167570001 | ||||||
| BOYLE, Eugene | Geschäftsführer | Teach Ban Parkside Drive Whittle Le Woods PR6 7PL Chorley | England | British | 106717430001 | |||||
| DOWE, Stephen William | Geschäftsführer | 10 Breary Lane East Bramhope LS16 9BJ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 88908400002 | |||||
| DUDLEY, Scott | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | England | British | 166551090001 | |||||
| HARDY-WILSON, Nigel Andrew | Geschäftsführer | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | England | British | 149590930001 | |||||
| HOWROYD, David Rowan | Geschäftsführer | Bay Tree House East Street TN20 6TY Mayfield East Sussex | British | 72333480002 | ||||||
| KNOTT, Henry Robert | Geschäftsführer | 39 Bridgewater Grange Preston Brook Runcorn WA7 3AL Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 90167500001 | |||||
| MCGIVERN, James Patrick | Geschäftsführer | The Ridge CH60 6SP Wirral 3 Merseyside United Kingdom | England | British | 120346770002 | |||||
| MORRIS, Gwendoline | Geschäftsführer | Grange Cottage 8 Hindford Whittington SY11 4NR Oswestry Shropshire | British | 19627140001 | ||||||
| MORRIS, Philip Ivor | Geschäftsführer | Grange Cottage 8 Hindford Whittington SY11 4NR Oswestry Shropshire | British | 36167620001 | ||||||
| MORRIS, Stephen | Geschäftsführer | Grange Cottage 8 Hindford Whittington SY11 4NR Oswestry Salop | British | 61241190001 | ||||||
| PICKUP, James | Geschäftsführer | Crooklands Farm Goosnargh Lane Goosnargh PR3 2JU Preston Lancashire | British | 35926750001 | ||||||
| READ, Phil | Geschäftsführer | The Oaks Rushden SG9 0SN Buntingford Hertfordshire | British | 63466290001 | ||||||
| ROSS, John | Geschäftsführer | 4 Gawsworth Close, Eccleston St Helens WA10 5RF Merseyside | United Kingdom | British | 85410970001 | |||||
| SAUNDERS, Mark Ian | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | England | British | 139588670003 | |||||
| SCOBIE, James Martin | Geschäftsführer | 1 Eastcote BR6 0AU Orpington Kent | United Kingdom | British | 73982880001 | |||||
| STRATFORD, Frederick Anthony | Geschäftsführer | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | United Kingdom | British | 151871680001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Simon Giles | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr David Mundell | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Jonathan Stephen Levine | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Roger Leonard Burdett | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat MORRIS CONTRACT CLEANING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 30. Aug. 2016 Geliefert am 01. Sept. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 05. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed & floating charge | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 04. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 04. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 13. Juli 2007 Geliefert am 17. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juli 2007 Geliefert am 17. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Nov. 2005 Geliefert am 20. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as morris holdings (UK) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 2003 Geliefert am 16. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1,265 square metres approx of land at mile oak industrial estate, maesbury road, oswestry. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 2003 Geliefert am 16. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the freehold land and the buildings thereon situate at mile oak industrial estate maesbury road oswestry shropshire title numbers SL35598 SL83433. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First fixed charge & floating charge | Erstellt am 20. Mai 1996 Geliefert am 23. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben First fixed charge on all book debts and other debts as are not sold to and bought by the chargee under an agreement dated 20 may 1996 and floating charge on all proceeds of book and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Mai 1996 Geliefert am 18. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 12. Juni 1992 Geliefert am 18. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Jan. 1991 Geliefert am 05. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 17. Dez. 1987 Geliefert am 31. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or phi's janitemal suppliers limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. März 1986 Geliefert am 14. März 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0