MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01925737 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Homelife House 26/32 Oxford Road BH8 8EZ Bournemouth Dorset |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MCCARTHY & STONE (GROUP SERVICES) LIMITED | 02. Okt. 1986 | 02. Okt. 1986 |
| MCCARTHY & STONE CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 25. Juni 1985 | 25. Juni 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gary Neil Day am 11. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael John Jennings am 19. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed mccarthy & stone (group services) LIMITED\certificate issued on 14/05/09 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2006 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2005 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2004 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN, Trevor Lindsay | Sekretär | Foxhill 31 Avon Castle Drive BH24 2BB Ringwood Hampshire | British | 981540001 | ||||||
| BALL, Michael David | Geschäftsführer | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 58961410002 | |||||
| DAY, Gary Neil | Geschäftsführer | Chine View Mansions 2 Mckinley Road West Overcliff BH4 8AQ Bournemouth 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 10857490004 | |||||
| JENNINGS, Michael John | Geschäftsführer | 51 Chaddesley Glen Sandbanks BH13 7RE Poole Chameleon Dorset United Kingdom | England | British | 8586280013 | |||||
| PHILLIPS, Howard Peter Stewart | Geschäftsführer | Flamstone Park Bishopstone SP5 4DB Salisbury Wiltshire | England | British | 72535940003 | |||||
| FIELD, Derek Anthony | Geschäftsführer | Autumn Chase Beach Road Upton BH16 5NA Poole Dorset | British | 50673980001 | ||||||
| GRAY, John | Geschäftsführer | Crosstrees Sway Road SO41 8LR Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 34578290001 | |||||
| HARRISON, Rodney Michael | Geschäftsführer | Amberwell Toms Lane Linwood BH24 3QU Ringwood Hants | England | British | 6583720001 | |||||
| LOVELOCK, Keith | Geschäftsführer | Toogoods House Moorside DT10 1HQ Sturminster Newton Dorset | British | 6219340001 | ||||||
| MCCARTHY, John Sidney | Geschäftsführer | Squalls Estate Squalls Lane Tisbury SP3 6RX Salisbury Wiltshire | England | British | 31054720002 | |||||
| THORNE, Matthew Wadman John | Geschäftsführer | The Mount Bannerdown Road Batheaston BA1 8EG Bath Avon | United Kingdom | British | 8469850001 | |||||
| TOWERS, Martin George | Geschäftsführer | Linton House Avenue Des Hirondelles Pool In Wharfedale LS21 1EY Otley West Yorkshire | British | 36252860002 | ||||||
| TUFTS, Dean Stuart | Geschäftsführer | 1 Browning Road GU13 0YJ Fleet Hampshire | British | 74298850001 |
Hat MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1994 Geliefert am 20. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee pursuant to the terms of each finance document (as defined) and to the ancillary bank (as defined) under each ancillary document (as defined) to which any obligor is a party | |
Kurze Angaben First floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Dez. 1992 Geliefert am 23. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from each obligor to the chargee (as agent), the banks (or any of them) and the chargee (in this capacity the"ancillary bank") on any account whatsoever under the terms of the finance documents to which such obligor is a party | |
Kurze Angaben (For full details see form 395 tc ref: M46). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft mortgage | Erstellt am 16. Aug. 1988 Geliefert am 18. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £831,980 due forom the company to forward trust limited or any account whatsoever | |
Kurze Angaben One - cessna 550 citation ii aircraft reg. Marks g-jetb serial no 550-0288 and equipped with JT15D/4 (two) engines serial no's 70844 and 70852. all spare engines, parts, components and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft mortgage | Erstellt am 23. Jan. 1987 Geliefert am 26. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £501,300 | |
Kurze Angaben One used as 355FI ecurevil helicopter reg marks g - cnet serial no:- 5120 and aquipped with alison 250 C20F (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0