KARSONS 2016 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KARSONS 2016 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | 01928109 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KARSONS 2016 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich KARSONS 2016 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Angel Square M60 0AG Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KARSONS 2016 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KARSONS PHARMACY LIMITED | 03. Juli 1985 | 03. Juli 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KARSONS 2016 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 11. Jan. 2019 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 11. Okt. 2019 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 11. Jan. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KARSONS 2016 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Form b to convert to rs | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Cws (No.1) Limited als Direktor am 06. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Branson Nuttall als Geschäftsführer am 06. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Anthony Philip James Crossland als Direktor am 06. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony John Smith als Geschäftsführer am 06. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KARSONS 2016 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLERS, Caroline Jane | Sekretär | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | 150146440001 | |||||||||||
| CROSSLAND, Anthony Philip James | Geschäftsführer | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 125492370001 | |||||||||
| CWS (NO.1) LIMITED | Geschäftsführer | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom |
| 130695310001 | ||||||||||
| ELDRIDGE, Katherine Elizabeth | Sekretär | 5 Stanley Avenue Hazel Grove SK7 4ED Stockport | British | 110230860001 | ||||||||||
| JONES, Philip Robert | Sekretär | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | English | 43686960001 | ||||||||||
| MEASURIA, Daksha | Sekretär | 66 Mottram Old Road SK15 2TE Stalybridge Cheshire | British | 31974160001 | ||||||||||
| MEASURIA, Haresh | Sekretär | 201 Mossley Road OL6 6LX Ashton Under Lyne Lancashire | British | 26898740001 | ||||||||||
| UCL SECRETARY LIMITED | Sekretär | United Co Operatives Limited Sandbrook Park Sandbrook Way OL11 1RY Rochdale Lancashire | 111685670001 | |||||||||||
| BATTY, Peter David | Geschäftsführer | Church Hill Ingham LN1 2YE Lincoln 2 Lincolnshire United Kingdom | England | British | 140380300001 | |||||||||
| BEAUMONT, Martin Dudley | Geschäftsführer | Hand Green House Hand Green CW6 9SN Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 10084840001 | |||||||||
| BROCKLEHURST, Jonathan David | Geschäftsführer | Larch House 29 Keele Road ST5 2JT Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 49108820004 | ||||||||||
| CHALMERS, Arthur | Geschäftsführer | 39 Catterick Road Didsbury M20 6HF Manchester | British | 59818810001 | ||||||||||
| FARQUHAR, Gordon Hillocks | Geschäftsführer | 3 Apsley Grove Dorridge B93 8QP Solihull | United Kingdom | British | 125645380001 | |||||||||
| KEW, Philip Anthony | Geschäftsführer | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | England | British | 84868550001 | |||||||||
| MEASURIA, Haresh | Geschäftsführer | 66 Mottram Old Road SK15 2TE Stalybridge Cheshire | British | 26898740002 | ||||||||||
| MEASURIA, Karsanbhai Vithalbhai | Geschäftsführer | 201 Mossley Road OL6 6LX Ashton Under Lyne Lancashire | British | 26898750001 | ||||||||||
| MEASURIA, Karsanbhai Vithalbhai | Geschäftsführer | 201 Mossley Road OL6 6LX Ashton Under Lyne Lancashire | British | 26898750001 | ||||||||||
| NUTTALL, John Branson | Geschäftsführer | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 44967060002 | |||||||||
| NUTTALL, John Branson | Geschäftsführer | The Old Post Office Whitchurch Road Broomhall CW5 8BZ Nantwich Cheshire | British | 44967060001 | ||||||||||
| RICHMAN, Jonathan Max | Geschäftsführer | 17 Ravensway Prestwich M25 0EU Manchester | England | British | 54694490001 | |||||||||
| SILVER, Steven Russell | Geschäftsführer | Farr Royd House 72 Sun Lane LS29 7LT Burley In Wharfedale West Yorkshire | England | British | 182256460001 | |||||||||
| SMITH, Anthony John | Geschäftsführer | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | England | British | 137558680001 | |||||||||
| THOMPSON, Christopher Howard Gould | Geschäftsführer | 1 Norfolk Road HG2 8DA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 38632440001 | |||||||||
| WATES, Martyn James | Geschäftsführer | 3 Aylesby Close WA16 8AE Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 60114700001 | |||||||||
| UCL DIRECTOR 1 LIMITED | Geschäftsführer | United Co-Operatives Limited Sandbrook Park OL11 1RY Rochdale | 110868260001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für KARSONS 2016 LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 31. Juli 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat KARSONS 2016 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Sept. 1993 Geliefert am 28. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 26 reddish road stockport and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Sept. 1993 Geliefert am 28. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 286 gorton road reddish stockport and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Sept. 1993 Geliefert am 28. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 153 block lane chadderton and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Sept. 1993 Geliefert am 28. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 139 droylsden road newton heath manchester and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Sept. 1993 Geliefert am 28. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 35 wellington road south stockport and/or the proceeds of sale and assigns goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 03. März 1989 Geliefert am 08. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Apr. 1987 Geliefert am 29. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 64 cornwall street, oldham greater manchester and/or the proceeds of sale thereof title no ol 2065.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Aug. 1985 Geliefert am 12. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold 5 alderford parade cheetham greater manchester. And the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0