WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED

WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01929291
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5th Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ROTCH PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED18. Mai 198818. Mai 1988
    RESTPLACE LIMITED09. Juli 198509. Juli 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2017

    10 SeitenAA

    Ernennung von Mr Michael David Watson als Direktor am 13. Nov. 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2016

    9 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Vincent Aziz Tchenguiz am 01. Juli 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 01. Juni 2016

    • Kapital: GBP 2,465,773
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2015

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 04. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2,465,773
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2014

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 12. Juni 2014

    • Kapital: GBP 2,465,773
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013

    9 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Vincent Aziz Tchenguiz am 08. Okt. 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Michael Ingham als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011

    9 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor Leconfield House Curzon Street London W1J 5JA* am 09. Feb. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2010

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TCHENGUIZ, Robert
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    Geschäftsführer
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    EnglandBritish74322720004
    TCHENGUIZ, Vincent Aziz
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    Geschäftsführer
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    United KingdomBritish,71890500005
    WATSON, Michael David
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    Geschäftsführer
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    EnglandBritish63440350001
    FITZPATRICK, Antony Simon
    15 The Orchard Yoeman Lane
    Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Sekretär
    15 The Orchard Yoeman Lane
    Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    British104975630002
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Sekretär
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    BUTTON, Geoffrey Allan
    The Mill House
    Chicksgrove Tisbury
    SP3 6LY Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Mill House
    Chicksgrove Tisbury
    SP3 6LY Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish54100730001
    COOPER, Lionel Martin
    4 Ridge Lane
    WD1 3TD Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    4 Ridge Lane
    WD1 3TD Watford
    Hertfordshire
    British1970500001
    HOWARD, Martin John
    Friary Cottage
    Witham Friary
    BA11 5HD Frome
    Somerset
    Geschäftsführer
    Friary Cottage
    Witham Friary
    BA11 5HD Frome
    Somerset
    United KingdomBritish467110001
    ROSEWELL, Peter William
    Ridgeway House
    Penn Lane Hardington Mandeville
    BA22 9PQ Yeovil
    Somerset
    Geschäftsführer
    Ridgeway House
    Penn Lane Hardington Mandeville
    BA22 9PQ Yeovil
    Somerset
    British34582580001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Rotch Properties Limited
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th Floor, Leconfield House
    England
    06. Apr. 2016
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th Floor, Leconfield House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer02384071
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat WYN-RO PROPERTY INVESTMENTS (SEA CONTAINERS HOUSE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignment of rental income and other rights
    Erstellt am 24. März 2000
    Geliefert am 27. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Right, title and interest of the company in and to the bhf rent, the bhf sale proceeds, the bhf service charges and value added tax in respect of the property
    Kurze Angaben
    Right, title and interest of the company in and to the bhf rent, the bhf sale proceeds, the bhf service charges and value added tax in respect of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Citibank, N.A.
    Transaktionen
    • 27. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and debenture
    Erstellt am 24. März 2000
    Geliefert am 27. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a fountain house, great cornbow, halesowen, west midlands. T/no. WM647723. And the proceeds of sale thereof. Floating charge the whole of the company's undertaking and all its property rights and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Citibank, N.A.
    Transaktionen
    • 27. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined) under or in connection with the agreement dated 8 february 1999 or any security document (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag(The "Agent" (as Defined))
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 1998
    Geliefert am 21. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H premises k/a fountain house great cornbow halesowen west midlands t/n WM179355 with all buildings fixtures fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Commercial Exporters Limited
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 05. Sept. 1996
    Geliefert am 19. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from rotch financial limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of rotch property group limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited, the norwich union life insurance society and any other company which is a subsidiary of eith of those companies which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("the lender") or for or in respect of which any group member may be liable to the lender on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies due owing or incurred to the company under the occupational lease(s).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Sept. 1996
    Geliefert am 19. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from rotch financial limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of rotch property group limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited, the norwich union life insurance society and any other company which is a subsidiary of eith of those companies which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("the lender") or for or in respect of which any group member may be liable to the lender on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fountain house, great cornbow, halesowen, dudley, west midlands t/no. WM179355. Floating charge all the company's property assets rights and revenues present and future including the uncalled capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1996
    Geliefert am 02. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (as defined) on any account whatsoever pursuant to the guarantee (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wyndham Investments Limited, as Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1989
    Geliefert am 04. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as trustee for the banks (as defined in the loan agreement) under the terms of the loan agreement dated 29.3.89 and this deed.
    Kurze Angaben
    F/Hold sea containers house, upper ground blackfriars. Title no sgl 184368 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Sanwa Bank Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 15. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Mai 1986
    Geliefert am 09. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from rotch developments (UK) limited under any facility letters or agreements supplemental to it to the chargee.
    Kurze Angaben
    Agreement dated 26/7/85 rlating to land at cadby hall, hammersmith road, in the london borough of hammersmith and fulham and the benefit of the covenant on the part of cadby hall developments limited to construct the blythe road diversion see doc M8 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Guiness Mahon and Company Limited
    Transaktionen
    • 09. Juni 1986Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0