IMEX SPACES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIMEX SPACES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01931478
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IMEX SPACES LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich IMEX SPACES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IMEX SPACES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    I-MEX PROPERTIES LTD23. Mai 198923. Mai 1989
    DOVEARCH LIMITED18. Juli 198518. Juli 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IMEX SPACES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für IMEX SPACES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE am 11. Okt. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. Sept. 2010

    LRESSP

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beendigung der Bestellung von Philip Warner als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    12 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    12 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    18 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Wer sind die Geschäftsführer von IMEX SPACES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Sekretär
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Geschäftsführer
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Geschäftsführer
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    British45345090004
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Sekretär
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    NORRIS, Patricia Pamela
    Flat 6 Broadlands Lodge
    Broadlands Road Highgate
    N6 4AW London
    Sekretär
    Flat 6 Broadlands Lodge
    Broadlands Road Highgate
    N6 4AW London
    British4318800001
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    Sekretär
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    British78391680002
    ARONSOHN, Norman Edward
    1 Ardwick Road
    NW2 2BX London
    Geschäftsführer
    1 Ardwick Road
    NW2 2BX London
    United KingdomBritish6647720001
    BETTS, David Richard
    Apartment 58
    Ragged Staff Wharf
    Queensway
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Apartment 58
    Ragged Staff Wharf
    Queensway
    Gibraltar
    SpainBritish80803300001
    CHAPMAN, Robert William Thomas
    16 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    16 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish32652350001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    CRAN, William Michael
    16 Ashleigh Dale
    Birkby
    HD2 2DL Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Ashleigh Dale
    Birkby
    HD2 2DL Huddersfield
    West Yorkshire
    British5206400002
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Geschäftsführer
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritish78151560001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish45345090004
    GLEGHORN, Keith William
    Royd Top Broad Lane
    Upperthong Holmfirth
    HD7 1LS Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Royd Top Broad Lane
    Upperthong Holmfirth
    HD7 1LS Huddersfield
    West Yorkshire
    British43071440002
    GOULD, Bernard David
    76 Woodhill Crescent
    Kenton
    HA3 0LZ Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    76 Woodhill Crescent
    Kenton
    HA3 0LZ Harrow
    Middlesex
    British4021030001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    Geschäftsführer
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    British85468580002
    HERRITTY, Jayne
    17 Paradise Lane
    Hall Green
    B28 0DY Birmingham
    Geschäftsführer
    17 Paradise Lane
    Hall Green
    B28 0DY Birmingham
    British45641090001
    HINE, Derek Leslie
    8 Showell Close
    Westwood Court
    WR9 8UQ Droitwich
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    8 Showell Close
    Westwood Court
    WR9 8UQ Droitwich
    Worcestershire
    British29871470001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    KIRKWOOD, Stuart Watson
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    British76937270002
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    EnglandBritish5785520001
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    SALMON, Steven Kenneth
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    British66565200002
    SHERRATT, Peter John
    23 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LD Birmingham
    Geschäftsführer
    23 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LD Birmingham
    British52526530002
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    Geschäftsführer
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritish32981540001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    STEVENSON, Roland
    24 Miranda Drive
    Heathcote
    CV34 6FE Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    24 Miranda Drive
    Heathcote
    CV34 6FE Warwick
    Warwickshire
    British1160500003
    STOKES, Thomas Mcnair
    17 Arran View
    Stewarton
    KA3 5EX Kilmarnock
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    17 Arran View
    Stewarton
    KA3 5EX Kilmarnock
    Ayrshire
    British854380001
    TAYLOR, Margaret
    15 Capesthorne Close
    Holmes Chapel
    CW4 7EN Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    15 Capesthorne Close
    Holmes Chapel
    CW4 7EN Crewe
    Cheshire
    British64610720001
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    Geschäftsführer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    British78391680002
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001

    Hat IMEX SPACES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 22. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Colville business centre, goliath way, hermitage estate, colville t/n LT300425 south side of waingate, lower clough, linthwaite, hudderfield t/n WYK187697 land lying to the south of waingate, lower clough, linthwaite, hudderfield t/n WYK591854. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mezzanine security agreement
    Erstellt am 22. Juli 2005
    Geliefert am 01. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage, all estates or interest in any real property being colville business centre, goliath way, hermitage estate for further property charged please refer to the form 395 by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Warner Estate, Limited
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 2004
    Geliefert am 07. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Gresley road, south western industrial estate, peterlee t/no DU191311 (f/h); site 1, glenfield business park, philips road, blackburn, lancashire t/nos LA524845 LA562580 (l/h) spring hall mills, mile cross road, halifax t/no WYK51717 (f/h) for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a and forming traction house situated on the south side of hamilton road motherwell t/no LAN26055.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a and forming motherwell business centre lying to the southwest side of dalziel street the southeast side of coursington road and northwest side of albert street motherwell t/no LAN136913.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a and forming block 3 greenhill industrial estate coltswood road coatbridge t/no LAN53581.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects on the south side of main street coatbridge t/nos LAN74818 and LAN45798.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known formerly as plot 10 and now as imex spaces business centre broadleys business park stirling t/no stg 39416.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that plot or area of ground k/a and forming plot 2 carnegie campus dunfermline in the county of fife t/no ffe 44170.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 30 september 2002 and
    Erstellt am 24. Sept. 2002
    Geliefert am 18. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects on the south side of hamilton road, motherwell and registered in the land register of scotland under t/no. Lan 26055.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 30 september 2002 and
    Erstellt am 24. Sept. 2002
    Geliefert am 18. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects extending to seventy six decimal or one hundredth parts of a hectare (0.76 hectares) or thereby at carnegie campus, dunfermline registered in the land registry of scotland under t/no. Ffe 44170.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2002
    Geliefert am 01. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee for Each of the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2000
    Geliefert am 13. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly, severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the company or by some other person) of the obligors (as defined) to the chargee (as trustee for the beneficiaries under (and as defined in) the trust agreement (as defined)) (or any of them) under each of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the mortgage property (as defined), assigns all right title and interest to in and under all present and future collateral agreements to real property, licences granted to the company in respect of the real property, insurance policies and all proceeds paid or payable thereunder, first fixed charge all present and future assets, first floating charge all that heritable property of the company physically situated on the real property in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second ranking debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2000
    Geliefert am 13. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly, severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the company or by some other person) of the obligors (as defined) to the chargee (as trustee for the beneficiaries under (and as defined in) the trust agreement (as defined)) (or any of them) under each of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of second legal mortgage the mortgage property (as defined), assigns all right title and interest to in and under all present and future collateral agreements to real property, licences granted to the company in respect of the real property, insurance policies and all proceeds paid or payable thereunder, second fixed charge all present and future assets, second floating charge all that heritable property of the company physically situated on the real property in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the farfield road unit factory development 2/18 hillfort road , 92/98 hoyland road sheffield t/no;-SYK385540.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a wilsons park manchester t/no;-GM46446.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the cricket inn cricket inn road maltravers road derwent street sheffield t/no;-SYK394754.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H propertry k/a royd mill business park brighouse t/no;-WYK505418.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the hoyland road factory development 30/80 hoyland road sheffield SYK88618.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the hillford unit factory development hoyland road sheffield t/no;-SYK394671.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a londesborough street hull t/no;-HS186745.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a atlas business centre oxgate lane staples corner london t/no;-NGL498102.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a marsh mill luck lane marsh huddersfield t/no;-WYK377723.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1999
    Geliefert am 25. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a black rock mills linthwaite huddersfield t/no's;-WYK591854, WYK525399, WYK187697 and WYK561310.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat IMEX SPACES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Nov. 2011Aufgelöst am
    28. Sept. 2010Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Praktiker
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0