BARTRAM WALKER LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BARTRAM WALKER LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01931877 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BARTRAM WALKER LIMITED?
- Instandhaltung und Reparatur anderer Ausrüstungen (33190) / Verarbeitendes Gewerbe
- Elektroinstallation (43210) / Bauwesen
Wo befindet sich BARTRAM WALKER LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O ROBSON SCOTT ASSOCIATES 49 Duke Street DL3 7SD Darlington County Durham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BARTRAM WALKER LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BARTRAM ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED | 09. Mai 1990 | 09. Mai 1990 |
BARTRAM (H. & V.) LIMITED | 18. Juli 1985 | 18. Juli 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BARTRAM WALKER LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2018 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2019 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für BARTRAM WALKER LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Feb. 2020 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 21. Feb. 2020 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Feb. 2019 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für BARTRAM WALKER LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2024 | 28 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2023 | 23 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2023 | 23 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2022 | 24 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2021 | 25 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2020 | 18 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 019318770005 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Rmt Gosforth Park Avenue Gosforth Tyne & Wear NE12 8EG United Kingdom zum 49 Duke Street Darlington County Durham DL3 7SD am 11. Apr. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 9 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Ae Walker Holdings Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2018 | 4 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Esh House Bowburn North Industrial Estate Bowburn Durham DH6 5PF zum Rmt Gosforth Park Avenue Gosforth Tyne & Wear NE12 8EG am 09. Jan. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Notification of Ae Walker Holdings Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Esh Holdings Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Sowerby als Sekretär am 21. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Andrew Sowerby als Geschäftsführer am 21. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Edward Radcliffe als Geschäftsführer am 21. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Susan Alexandra Walker als Sekretär am 21. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 019318770004 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 019318770005, erstellt am 19. Dez. 2018 | 53 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Manning als Geschäftsführer am 28. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BARTRAM WALKER LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALKER, Susan Alexandra | Sekretär | Duke Street DL3 7SD Darlington 49 County Durham | 254042630001 | |||||||
WALKER, Keith William | Geschäftsführer | Duke Street DL3 7SD Darlington 49 County Durham | England | British | Business Development Manager | 125362310001 | ||||
PICKETT, Andrew Russell | Sekretär | 30 Trecastell Ingleby Barwick TS17 5HA Stockton On Tees Cleveland | British | Director | 41677650002 | |||||
RADCLIFFE, Andrew Edward | Sekretär | Esh House Bowburn North Industrial Estate DH6 5PF Bowburn Durham | 155424040001 | |||||||
ROSENTHAL, Laurence | Sekretär | 35 Burnside NE36 0LS East Boldon Tyne & Wear | British | 1665450001 | ||||||
SOWERBY, Mark | Sekretär | Esh House Bowburn North Industrial Estate DH6 5PF Bowburn Durham | 242608820001 | |||||||
BARCLAY, Kirk David | Geschäftsführer | 7 Burnland Terrace NE46 3JT Hexham Northumberland | England | British | Operations Manager | 102298400001 | ||||
BLICK, Andrew David | Geschäftsführer | 12 Manor Court TS22 5LS Wolviston | British | Director | 124607270001 | |||||
CHAPMAN, Sheila | Geschäftsführer | 12 Moorfield Gardens SR6 7TP Sunderland Tyne & Wear | British | Administrator | 65506470001 | |||||
CHAPMAN, Sheila | Geschäftsführer | 12 Moorfield Gardens SR6 7TP Sunderland Tyne & Wear | British | Administration Director | 65506470001 | |||||
CRAGGS, Leonard | Geschäftsführer | 7 Sycamore Grove Springwell Village NE9 7SE Gateshead Tyne & Wear | British | Electrical Engineer | 39498500001 | |||||
GREEN, William Thomas | Geschäftsführer | 36 Hawes Court SR6 8NU Sunderland Tyne & Wear | British | Electrical Contractor | 18802360001 | |||||
HALFACRE, David John | Geschäftsführer | 5 Jasper Grove Stillington TS21 1NU Stockton On Tees | England | British | Director | 84120730002 | ||||
HOPPER, Malcolm Bell | Geschäftsführer | 2 Hillside Dunston NE11 9QR Gateshead Tyne & Wear | Uk | British | Director | 123322000001 | ||||
LAW, Alistair | Geschäftsführer | 15 Trevine Gardens Ingleby Barwick TS17 5HD Stockton On Tees Cleveland | United Kingdom | British | Accountant | 113270200001 | ||||
MANNING, Brian | Geschäftsführer | Esh House Bowburn North Industrial Estate DH6 5PF Bowburn Durham | United Kingdom | British | Company Director | 129464640001 | ||||
MCANDREW, Brian Peter | Geschäftsführer | 6 Barrowburn Place Seghill NE23 7HB Cramlington Northumberland | British | Director | 85090310001 | |||||
MCLAUGHLIN, Thomas Dominic | Geschäftsführer | 22 Chelsea Gardens TS20 1RZ Stockton On Tees Cleveland | British | Director | 70216980001 | |||||
PICKETT, Andrew Russell | Geschäftsführer | 30 Trecastell Ingleby Barwick TS17 5HA Stockton On Tees Cleveland | United Kingdom | British | Director | 41677650002 | ||||
RADCLIFFE, Andrew Edward | Geschäftsführer | Esh House Bowburn North Industrial Estate DH6 5PF Bowburn Durham | United Kingdom | British | Director | 155424860001 | ||||
ROSENTHAL, Laurence | Geschäftsführer | 35 Burnside NE36 0LS East Boldon Tyne & Wear | British | Managing Director | 1665450001 | |||||
ROSENTHAL, Laurence | Geschäftsführer | 35 Burnside NE36 0LS East Boldon Tyne & Wear | British | Company Director | 1665450001 | |||||
SOWERBY, Mark Andrew | Geschäftsführer | Esh House Bowburn North Industrial Estate DH6 5PF Bowburn Durham | England | British | Director | 242174300001 | ||||
TWEDDLE, David | Geschäftsführer | 56 Wimpole Road Fairfield TS19 7LP Stockton | British | Director | 98886360001 | |||||
WALKER, Keith William | Geschäftsführer | 36 Meldon Avenue DH6 1JX Sherburn Village County Durham | England | British | Director | 125362310001 | ||||
WATT, Charles Peter | Geschäftsführer | 14 Leazes Park NE46 3AX Hexham Northumberland | England | British | Commercial Director | 153632430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BARTRAM WALKER LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ae Walker Holdings Limited | 21. Dez. 2018 | Gosforth Park Avenue NE12 8EG Gosforth Rmt Tyne & Wear United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Esh Holdings Limited | 07. Okt. 2016 | Bowburn North Industrial Estate Bowburn DH6 5PF Durham Esh House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat BARTRAM WALKER LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 19. Dez. 2018 Geliefert am 24. Dez. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (ad defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01).. In the debenture "land" means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant's fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 04. Dez. 2015 Geliefert am 09. Dez. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Aug. 2003 Geliefert am 14. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 29. Juni 2000 Geliefert am 04. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 31. Juli 1992 Geliefert am 11. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat BARTRAM WALKER LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0