FOCUS NO.1 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFOCUS NO.1 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01932765
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FOCUS NO.1 LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich FOCUS NO.1 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FOCUS NO.1 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FOCUS WICKES LIMITED23. Okt. 200223. Okt. 2002
    FOCUS WICKES PLC23. Mai 200223. Mai 2002
    FOCUS WICKES LIMITED18. Apr. 200218. Apr. 2002
    FOCUS GROUP LIMITED07. Juni 200107. Juni 2001
    FOCUS DO IT ALL GROUP LIMITED17. März 199917. März 1999
    FOCUS RETAIL GROUP LIMITED12. Dez. 198812. Dez. 1988
    CHOICE GROUP LIMITED03. Dez. 198603. Dez. 1986
    CHORUSBRIDGE LIMITED23. Juli 198523. Juli 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOCUS NO.1 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis21. Feb. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für FOCUS NO.1 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    7 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Gawsworth House Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6XB am 24. Aug. 2011

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Aug. 2011

    LRESEX

    Änderung der Details des Direktors für Mr William Grimsey am 13. Mai 2011

    3 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Brian Robbins als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Änderung der Details des Sekretärs für Dawn Michelle Wilkinson am 11. Okt. 2010

    3 SeitenCH03

    Beendigung der Bestellung von Richard Bird als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Thomas Christopher Morgan am 11. Okt. 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Patrick Gladwin am 11. Okt. 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Brian Keith Robbins am 11. Okt. 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 21. Feb. 2010

    15 SeitenAA

    Ernennung von Brian Keith Robbins als Direktor

    3 SeitenAP01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 06. Juli 2010

    2 Seiten1.3

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    3 Seiten1.4

    Ernennung von Thomas Christopher Morgan als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Unitt als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Juni 2010

    Kapitalaufstellung am 25. Juni 2010

    • Kapital: GBP 20,310,049.4
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Penelope Teale als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 22. Feb. 2009

    16 SeitenAA

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    12 Seiten1.1

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von FOCUS NO.1 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILKINSON, Dawn Michelle
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United Kingdom
    British105435010001
    GLADWIN, Robert Patrick
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomBritish130288970001
    GRIMSEY, William
    9 The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Tall Timbers
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    9 The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Tall Timbers
    Hertfordshire
    United KingdomBritish50647840004
    MORGAN, Thomas Christopher
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomBritish152428250002
    HOSKINS, William
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    Sekretär
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    British121893830001
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    WILLIAMS, David Robert
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    Sekretär
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    British157062220001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Sekretär
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BIRD, Richard Sidney
    80 Wolsey Road
    HA6 2EH Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    80 Wolsey Road
    HA6 2EH Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish111500210002
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Geschäftsführer
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    CHEEK, Giles Ashley
    37 Yester Road
    BR7 5HN Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    37 Yester Road
    BR7 5HN Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish77027280001
    HARTNALL, Michael James
    Monkswood Priors Hatch Lane
    Hurtmore
    GU7 2RJ Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Monkswood Priors Hatch Lane
    Hurtmore
    GU7 2RJ Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish10075180002
    HOSKINS, William
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    British121893830001
    JOHNSON, Stephen Richard
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    EnglandBritish87398750001
    LEBUS, Timothy Andrew
    70 Ellerby Street
    SW6 6EZ London
    Geschäftsführer
    70 Ellerby Street
    SW6 6EZ London
    British6855830001
    LEE, Graham William
    25 Devereux Lane
    SW13 8DB London
    Geschäftsführer
    25 Devereux Lane
    SW13 8DB London
    United KingdomBritish3014660002
    LOWE, James Mcdonald
    17 Denewood Court
    Victoria Road
    SK9 5HP Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    17 Denewood Court
    Victoria Road
    SK9 5HP Wilmslow
    Cheshire
    British86976330001
    MARKS, Kenneth Anthony
    279 Dover House Road
    Roehampton
    SW15 5BP London
    Geschäftsführer
    279 Dover House Road
    Roehampton
    SW15 5BP London
    British16920310001
    MCALEER, Andrew
    14 Manor Gardens
    CW5 5UZ Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    14 Manor Gardens
    CW5 5UZ Nantwich
    Cheshire
    British15170420002
    MCDOUGAL, Robert Hugh
    41 Tensing Close Great Sankey
    WA5 5AN Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    41 Tensing Close Great Sankey
    WA5 5AN Warrington
    Cheshire
    British15170390002
    NORRIS, Barrington Michael John
    The Old Manor West End Lane
    West End Nailsea
    BS48 4DF Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    The Old Manor West End Lane
    West End Nailsea
    BS48 4DF Bristol
    Avon
    British27570100001
    PEARSON, David Peter
    Peckforton House
    Peckforton Hall Lane
    CW6 9TH Peckforton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Peckforton House
    Peckforton Hall Lane
    CW6 9TH Peckforton
    Cheshire
    United KingdomBritish173695630001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Geschäftsführer
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    ROBBINS, Brian Keith
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomAmerican153559370002
    ROGERS, John Leonard
    The Old House
    The Square
    NN6 9SD Hannington
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Old House
    The Square
    NN6 9SD Hannington
    Northamptonshire
    United KingdomBritish19597130001
    SCOTT, Robert Avisson
    36 St Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    36 St Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomAustralian1226660002
    STANLEY, Gregory Alexander
    349 Chelsea Cloisters
    Sloane Avenue
    SW3 3DW London
    Geschäftsführer
    349 Chelsea Cloisters
    Sloane Avenue
    SW3 3DW London
    British55200780003
    TEALE, Penelope Jane
    1 Weldon Rise
    Off Pitcher Lane
    MK5 8BW Loughton
    Milton Keynes
    Geschäftsführer
    1 Weldon Rise
    Off Pitcher Lane
    MK5 8BW Loughton
    Milton Keynes
    United KingdomBritish126053080001
    TERRAS, Duncan Crichton
    8 Saint Andrews Drive
    North Featherstone
    WF7 6NE Pontefract
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Saint Andrews Drive
    North Featherstone
    WF7 6NE Pontefract
    West Yorkshire
    British75100200001
    THOMAS, Shelley Frances
    Everest Road
    SK14 4DX Hyde
    Woodside Farm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Everest Road
    SK14 4DX Hyde
    Woodside Farm
    Cheshire
    United KingdomBritish133244600001
    UNITT, Andrew Vaughan
    64 Main Street
    LE74 4UU Cossington
    Hollycroft
    Leicester
    Geschäftsführer
    64 Main Street
    LE74 4UU Cossington
    Hollycroft
    Leicester
    EnglandBritish182500750001
    WEST, Gary James
    Merlewood House
    Russell Road
    TW17 8JS Shepperton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Merlewood House
    Russell Road
    TW17 8JS Shepperton
    Middlesex
    EnglandBritish127476430001
    WILLIAMS, David Robert
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    Geschäftsführer
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritish157062220001

    Hat FOCUS NO.1 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mezzanine debenture
    Erstellt am 03. März 2005
    Geliefert am 10. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Feb. 2005
    Geliefert am 25. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V., London Branch (Security Agent)
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Subordinated debenture
    Erstellt am 16. Feb. 2005
    Geliefert am 25. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V., London Branch (Security Agent)
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A mezzanine debenture
    Erstellt am 28. Juli 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Senior security accession deed
    Erstellt am 29. Jan. 2003
    Geliefert am 13. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Parkinson way,waterloo rd,blackpool; LA694265; unit 1 malvern retail park,madresfield,malvern,hereford and worcester; HW161067. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordinated security accession deed
    Erstellt am 29. Jan. 2003
    Geliefert am 13. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) blackpool,parkinson way,waterloo rd,malvern; LA694265; (ii) unit 1,malvern retail park,madresfield,hereford and worcester; HW161067. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 2000
    Geliefert am 09. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 2000
    Geliefert am 09. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between the company,as parent,the companies listed therein and ing bank N.V.,london branch as security agent
    Erstellt am 26. Sept. 2000
    Geliefert am 09. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Erstellt am 15. Jan. 1999
    Geliefert am 23. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) under or pursuant to the banking documents (as defined) or the mezzanine loan agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    Life policy no.2728708LF on the life of william ernest archer for the sum assured of £500,000 with general accident life and all monies including bonuses which may accrue. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Aug. 1998
    Geliefert am 03. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any group company (as therein defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries, as therein defined) under the banking documents and the mezzanine loan agreement (both as therein defined) whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise and in each case under the working capital facility letter
    Kurze Angaben
    F/H property known as bonehill road tamworth t/n SF319160, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman life policy in respect of william archer
    Erstellt am 31. Juli 1997
    Geliefert am 11. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All of the assigner's right title and interest in and to the policy (no 2728708LF) with general accident life in respect of the life of william ernest archer (the "policy") including all new amended and substituted policy or policies relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Juli 1997
    Geliefert am 11. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 25. Aug. 1995
    Geliefert am 26. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Okt. 1992
    Geliefert am 28. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of an indemnity dated 27/9/91
    Kurze Angaben
    L/H property being land at blackpool, lancashire containing 1 hectare 2,758 square metres and building thereon situate off parkinson way off waterloo road, blackpool.
    Berechtigte Personen
    • Credit and Guarantee Insurance Company PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Erstellt am 23. Apr. 1992
    Geliefert am 11. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £116118-40 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurances. (See 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 11. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Apr. 1988
    Geliefert am 29. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 28. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Apr. 1988
    Geliefert am 25. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan note of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all the company's assets.
    Berechtigte Personen
    • Railway Pension Investments Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 08. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Apr. 1988
    Geliefert am 25. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan note of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all the company's assets.
    Berechtigte Personen
    • Cin Industrial Investments Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 08. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Apr. 1988
    Geliefert am 25. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan note of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all the company's assets.
    Berechtigte Personen
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 08. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Apr. 1988
    Geliefert am 25. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan note of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all the companys assets.
    Berechtigte Personen
    • Phildrew Nominees Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 08. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Apr. 1988
    Geliefert am 25. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan note of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all the companys assets.
    Berechtigte Personen
    • Hambro Group Investments Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 08. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1985
    Geliefert am 31. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    • 26. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FOCUS NO.1 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Aug. 2009Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    13. Juli 2010Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    DatumTyp
    17. Jan. 2013Aufgelöst am
    09. Aug. 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0