PARAMOUNT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePARAMOUNT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01934366
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PARAMOUNT LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich PARAMOUNT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PARAMOUNT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PARAMOUNT P.L.C.22. Feb. 198922. Feb. 1989
    SILVER BEAR P.L.C.29. Juli 198529. Juli 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARAMOUNT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis02. Jan. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für PARAMOUNT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Nov. 2013

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 13. Nov. 2013

    17 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Apr. 2013

    16 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Okt. 2012

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Mai 2012

    39 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    61 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH am 05. Dez. 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte vollständige Konten erstellt bis 02. Jan. 2011

    14 SeitenAAMD

    legacy

    10 SeitenMG01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2011

    7 SeitenAA

    Ernennung von Mr Stephen Rushworth Smith als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von William Rollason als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Juni 2011

    Kapitalaufstellung am 24. Juni 2011

    • Kapital: GBP 4,157,690.4
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Emerson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr William Rollason als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Simon George Rowe als Direktor

    2 SeitenAP01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 29. Juni 2010 bis 29. Dez. 2010

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Mark Phillips als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Matthew Charles Emerson als Direktor

    3 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von PARAMOUNT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROWE, Simon George
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish68119020002
    SMITH, Stephen Rushworth
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    Geschäftsführer
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    United KingdomBritish6894950002
    DANGERFIELD, John
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    Sekretär
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    British117743550001
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Sekretär
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    British148079910001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Sekretär
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    British130983750001
    JACKSON, Graham Michael, Dr
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    Sekretär
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    British20761790001
    PINCUS, Barry Martin
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    Sekretär
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    British46444010002
    BARBOUR, Anthony George
    Bolesworth Castle
    Tattenhall
    CH3 9HQ Chester
    Geschäftsführer
    Bolesworth Castle
    Tattenhall
    CH3 9HQ Chester
    British1448620001
    BASING, Nicholas Andrew
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    Geschäftsführer
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    EnglandBritish140766360001
    BRAMLEY, Michael Lloyd
    53 Spring Lane
    Burn Bridge
    HG3 1NP Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    53 Spring Lane
    Burn Bridge
    HG3 1NP Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish46914100003
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish106840540001
    DANGERFIELD, John
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    British117743550001
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Geschäftsführer
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish148079910001
    DAVIES, Paul
    Greenacres
    Tamarix Close,Gedling
    NG4 4AJ Nottingham
    Geschäftsführer
    Greenacres
    Tamarix Close,Gedling
    NG4 4AJ Nottingham
    British5020990002
    DICKSON, Leslie Cranstoun
    10 Uplands Delamere Park
    Cuddington
    CW8 2XL Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    10 Uplands Delamere Park
    Cuddington
    CW8 2XL Northwich
    Cheshire
    British25070870001
    ELMAN, Ralph
    1 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 6BP London
    Geschäftsführer
    1 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 6BP London
    British80068050001
    EMERSON, Matthew Charles
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8
    Geschäftsführer
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8
    EnglandBritish61777750002
    FRYER, John Malcolm
    Old Stores 34a
    Ribchester Road
    BB1 9HU Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Old Stores 34a
    Ribchester Road
    BB1 9HU Blackburn
    Lancashire
    British44961580001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Geschäftsführer
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    EnglandBritish130983750001
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Geschäftsführer
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritish26032950002
    JONES, Leonard Edward
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    British76599820001
    KING, William James
    Springwood House
    Birch Heath Lane, Christleton
    CH3 7AP Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Springwood House
    Birch Heath Lane, Christleton
    CH3 7AP Chester
    Cheshire
    British64187110004
    LAWSON, Carole Mary
    34 Moss Bank Road
    WA11 7DE St Helens
    Merseyside
    Geschäftsführer
    34 Moss Bank Road
    WA11 7DE St Helens
    Merseyside
    British48885070001
    LUNN, George Michael
    Fairmount
    17 Ledcameroch Road
    G61 4AB Bearsden Glasgow
    Dunbartonshire
    Geschäftsführer
    Fairmount
    17 Ledcameroch Road
    G61 4AB Bearsden Glasgow
    Dunbartonshire
    United KingdomBritish194960002
    MEARNS, Alexander
    1 Windsor Road
    Crosby
    L23 7TR Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    1 Windsor Road
    Crosby
    L23 7TR Liverpool
    Merseyside
    British35737020002
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Geschäftsführer
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    EnglandBritish35557050001
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Geschäftsführer
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    EnglandBritish35557050001
    MORTON, Brian George
    37 Meadow Vale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    37 Meadow Vale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    British22731400001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Geschäftsführer
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    NEILL, Ian Smeeton
    22 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    22 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish6744750002
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80508130001
    PRICE, Robert Dennis
    Otters Bank Farm
    Fishpool Lane Delamere
    CW8 2HP Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Otters Bank Farm
    Fishpool Lane Delamere
    CW8 2HP Tarporley
    Cheshire
    British22672440001
    ROE, Neil Clifford
    Wind Hill Church Road
    Thornton In Craven
    BD23 3TN Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Wind Hill Church Road
    Thornton In Craven
    BD23 3TN Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish100873710001
    ROLLASON, William
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Geschäftsführer
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    United KingdomBritish140347580001
    STANDING, Peter Heaton
    16 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NQ Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    16 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NQ Warrington
    Cheshire
    British23728590001

    Hat PARAMOUNT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A supplemental security, accession and confirmation deed
    Erstellt am 22. Sept. 2011
    Geliefert am 28. Sept. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor, with full title guarantee, in favour of the security trustee (as trustee for the finance parties), hereby respectively charged on the terms set out in the relevant charging clause of the relevant security documents its assets as more specifically referred to in the relevant security documents, the secured liabilities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 2009
    Geliefert am 27. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each security provider to the senior finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Starlight Investments Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 27. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Apr. 2003
    Geliefert am 29. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Nov. 1998
    Geliefert am 17. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (I) afon goch inn,flintshire;wa 642065;(ii) anchor inn,north shropshire; sl 55332;(iii) aston arms,vale royal,cheshire; ch 348040 plus 104 other properties listed on schedule;all plant,machinery,fixtures/fittings,furniture,equipment,etc thereon; the goodwill of business and proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Nov. 1998
    Geliefert am 17. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 07. Jan. 1997
    Geliefert am 23. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement and any of the "security documents" (as defined in the assignment)
    Kurze Angaben
    The policy numbered jgn 13988 dated 7TH january 1997 in an amount of £250,000 on the life of paul davies issued through J.D.bassett and others and all monies (including claims profits and bonuses ) payable thereunder and all other rights of the company therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 1996
    Geliefert am 10. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the bogie steamliner 81 salisbury street liverpool t/n MS355754 and by way of fixed charge all buildings and other structures any goodwill all plant machinery and other chattels the rental sums the proceeds of any claim under any insurance policy and by way of floating charge all unattached plant machinery and chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over sale proceeds account
    Erstellt am 02. März 1995
    Geliefert am 21. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    The sale proceeds account no.01539664 Opened in the books of the bank of scotland and all monies constituting the balance to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent for the Banks (as Defined)
    Transaktionen
    • 21. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 14. Feb. 1995
    Geliefert am 17. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The spiral staircase old hall street liverpool together with any proceeds of insurance & all rents the benefit of all securities & guarantees & all interest due in respect thereof.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    Bleak house 127, 129, 131 & 133 park hill road & 87, 89, 91 & 93 cockburn street liverpool with the proceeds of any sale the rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The derby arms 365/367 mill street liverpool with the proceeds of any insurance the rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The new inn peasley cross lane st helens lancs and the proceeds of any insurance the rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    Mount vernon 1 irvine street liverpool with the proceeds of any insurance the rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The poste house 23 cumberland street liverpool with the proceeds of any insurance all rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The globe inn 44 park road liverpool with the proceeds of any insurance all rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The leasowe castle 1 demesne street seacombe wallasey wirral merseyside with any proceeds of insurance all rents & the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The salvation 199 walton road liverpool with the proceeds of any insurance the benefit of all guarantees all rents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The sun inn 43/45 mill lane macclesfield cheshire and the proceeds of any insurance all rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The smithfield 1062 ashton old road openshaw manchester with the proceeds of any insurance all rents & the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    Owd kitts 14 glodwick oldham gtr manchester with any proceeds of any insurance the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 23. Nov. 1994
    Geliefert am 08. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £96,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The rubber duck 5 strand road bootle liverpool.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1994
    Geliefert am 15. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £55,200 due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement dated 24TH may 1994
    Kurze Angaben
    The welcome inn 58 north john street st. Helens merseyside.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent)
    Transaktionen
    • 15. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PARAMOUNT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Nov. 2011Beginn der Verwaltung
    13. Nov. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Praktiker
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0