PARAMOUNT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PARAMOUNT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01934366 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PARAMOUNT LIMITED?
- (9305) /
Wo befindet sich PARAMOUNT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PARAMOUNT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PARAMOUNT P.L.C. | 22. Feb. 1989 | 22. Feb. 1989 |
| SILVER BEAR P.L.C. | 29. Juli 1985 | 29. Juli 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARAMOUNT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Jan. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PARAMOUNT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Nov. 2013 | 17 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 13. Nov. 2013 | 17 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Apr. 2013 | 16 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Okt. 2012 | 17 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Mai 2012 | 39 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 61 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 6 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Geänderte vollständige Konten erstellt bis 02. Jan. 2011 | 14 Seiten | AAMD | ||||||||||
legacy | 10 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Rushworth Smith als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Rollason als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Emerson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Rollason als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon George Rowe als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 29. Juni 2010 bis 29. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Phillips als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Matthew Charles Emerson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PARAMOUNT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROWE, Simon George | Geschäftsführer | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | British | 68119020002 | |||||
| SMITH, Stephen Rushworth | Geschäftsführer | Hatton Garden EC1N 8LE London 63-66 | United Kingdom | British | 6894950002 | |||||
| DANGERFIELD, John | Sekretär | Pulford Place Wrexham Road CH4 9DG Pulford Cheshire | British | 117743550001 | ||||||
| DARWIN, Richard James | Sekretär | 25 Meadow Road KT10 0RZ Claygate Surrey | British | 148079910001 | ||||||
| HILL, Peter Martin | Sekretär | Silver Crescent W4 5SE London 8a | British | 130983750001 | ||||||
| JACKSON, Graham Michael, Dr | Sekretär | Maesmor Hall Maerdy LL21 0NS Corwen Clwyd | British | 20761790001 | ||||||
| PINCUS, Barry Martin | Sekretär | 19 Willifield Way NW11 7XU London | British | 46444010002 | ||||||
| BARBOUR, Anthony George | Geschäftsführer | Bolesworth Castle Tattenhall CH3 9HQ Chester | British | 1448620001 | ||||||
| BASING, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | John Watkin Close KT19 7LW Epsom 4 Surrey | England | British | 140766360001 | |||||
| BRAMLEY, Michael Lloyd | Geschäftsführer | 53 Spring Lane Burn Bridge HG3 1NP Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 46914100003 | |||||
| D'ARCY, Lynne | Geschäftsführer | 5 Winwick Park Avenue WA2 8XB Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 106840540001 | |||||
| DANGERFIELD, John | Geschäftsführer | Pulford Place Wrexham Road CH4 9DG Pulford Cheshire | British | 117743550001 | ||||||
| DARWIN, Richard James | Geschäftsführer | 25 Meadow Road KT10 0RZ Claygate Surrey | United Kingdom | British | 148079910001 | |||||
| DAVIES, Paul | Geschäftsführer | Greenacres Tamarix Close,Gedling NG4 4AJ Nottingham | British | 5020990002 | ||||||
| DICKSON, Leslie Cranstoun | Geschäftsführer | 10 Uplands Delamere Park Cuddington CW8 2XL Northwich Cheshire | British | 25070870001 | ||||||
| ELMAN, Ralph | Geschäftsführer | 1 Bickenhall Mansions Bickenhall Street W1U 6BP London | British | 80068050001 | ||||||
| EMERSON, Matthew Charles | Geschäftsführer | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8 | England | British | 61777750002 | |||||
| FRYER, John Malcolm | Geschäftsführer | Old Stores 34a Ribchester Road BB1 9HU Blackburn Lancashire | British | 44961580001 | ||||||
| HILL, Peter Martin | Geschäftsführer | Silver Crescent W4 5SE London 8a | England | British | 130983750001 | |||||
| HUDD, David Leslie | Geschäftsführer | 97 Gunterstone Road W14 9BT London | England | British | 26032950002 | |||||
| JONES, Leonard Edward | Geschäftsführer | 82 Royal Arch Apartments The Mailbox B1 1RB Birmingham West Midlands | British | 76599820001 | ||||||
| KING, William James | Geschäftsführer | Springwood House Birch Heath Lane, Christleton CH3 7AP Chester Cheshire | British | 64187110004 | ||||||
| LAWSON, Carole Mary | Geschäftsführer | 34 Moss Bank Road WA11 7DE St Helens Merseyside | British | 48885070001 | ||||||
| LUNN, George Michael | Geschäftsführer | Fairmount 17 Ledcameroch Road G61 4AB Bearsden Glasgow Dunbartonshire | United Kingdom | British | 194960002 | |||||
| MEARNS, Alexander | Geschäftsführer | 1 Windsor Road Crosby L23 7TR Liverpool Merseyside | British | 35737020002 | ||||||
| MILLS, Christopher Harwood Bernard | Geschäftsführer | Cliveden Place SW1W 8LA London 10 | England | British | 35557050001 | |||||
| MILLS, Christopher Harwood Bernard | Geschäftsführer | Cliveden Place SW1W 8LA London 10 | England | British | 35557050001 | |||||
| MORTON, Brian George | Geschäftsführer | 37 Meadow Vale Outwood WF1 3TD Wakefield West Yorkshire | British | 22731400001 | ||||||
| NAGGAR, Guy Anthony | Geschäftsführer | Avenue Road NW8 6HR London 61 | United Kingdom | Italian | 1496660001 | |||||
| NEILL, Ian Smeeton | Geschäftsführer | 22 Boxgrove Avenue GU1 1XG Guildford Surrey | United Kingdom | British | 6744750002 | |||||
| PHILLIPS, Mark Randall | Geschäftsführer | Scotts Cottage Scots Lane MK18 2HX Adstock Buckinghamshire | United Kingdom | British | 80508130001 | |||||
| PRICE, Robert Dennis | Geschäftsführer | Otters Bank Farm Fishpool Lane Delamere CW8 2HP Tarporley Cheshire | British | 22672440001 | ||||||
| ROE, Neil Clifford | Geschäftsführer | Wind Hill Church Road Thornton In Craven BD23 3TN Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | 100873710001 | |||||
| ROLLASON, William | Geschäftsführer | 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH | United Kingdom | British | 140347580001 | |||||
| STANDING, Peter Heaton | Geschäftsführer | 16 Hob Hey Lane Culcheth WA3 4NQ Warrington Cheshire | British | 23728590001 |
Hat PARAMOUNT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A supplemental security, accession and confirmation deed | Erstellt am 22. Sept. 2011 Geliefert am 28. Sept. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor, with full title guarantee, in favour of the security trustee (as trustee for the finance parties), hereby respectively charged on the terms set out in the relevant charging clause of the relevant security documents its assets as more specifically referred to in the relevant security documents, the secured liabilities see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 2009 Geliefert am 27. Juli 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Sept. 2006 Geliefert am 05. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each security provider to the senior finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Aug. 2005 Geliefert am 02. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2005 Geliefert am 27. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2003 Geliefert am 29. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Nov. 1998 Geliefert am 17. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (I) afon goch inn,flintshire;wa 642065;(ii) anchor inn,north shropshire; sl 55332;(iii) aston arms,vale royal,cheshire; ch 348040 plus 104 other properties listed on schedule;all plant,machinery,fixtures/fittings,furniture,equipment,etc thereon; the goodwill of business and proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Nov. 1998 Geliefert am 17. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of life policy | Erstellt am 07. Jan. 1997 Geliefert am 23. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement and any of the "security documents" (as defined in the assignment) | |
Kurze Angaben The policy numbered jgn 13988 dated 7TH january 1997 in an amount of £250,000 on the life of paul davies issued through J.D.bassett and others and all monies (including claims profits and bonuses ) payable thereunder and all other rights of the company therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Feb. 1996 Geliefert am 10. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H the bogie steamliner 81 salisbury street liverpool t/n MS355754 and by way of fixed charge all buildings and other structures any goodwill all plant machinery and other chattels the rental sums the proceeds of any claim under any insurance policy and by way of floating charge all unattached plant machinery and chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over sale proceeds account | Erstellt am 02. März 1995 Geliefert am 21. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement (as defined) | |
Kurze Angaben The sale proceeds account no.01539664 Opened in the books of the bank of scotland and all monies constituting the balance to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 14. Feb. 1995 Geliefert am 17. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee secured by any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The spiral staircase old hall street liverpool together with any proceeds of insurance & all rents the benefit of all securities & guarantees & all interest due in respect thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben Bleak house 127, 129, 131 & 133 park hill road & 87, 89, 91 & 93 cockburn street liverpool with the proceeds of any sale the rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The derby arms 365/367 mill street liverpool with the proceeds of any insurance the rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The new inn peasley cross lane st helens lancs and the proceeds of any insurance the rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben Mount vernon 1 irvine street liverpool with the proceeds of any insurance the rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The poste house 23 cumberland street liverpool with the proceeds of any insurance all rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The globe inn 44 park road liverpool with the proceeds of any insurance all rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The leasowe castle 1 demesne street seacombe wallasey wirral merseyside with any proceeds of insurance all rents & the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The salvation 199 walton road liverpool with the proceeds of any insurance the benefit of all guarantees all rents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The sun inn 43/45 mill lane macclesfield cheshire and the proceeds of any insurance all rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The smithfield 1062 ashton old road openshaw manchester with the proceeds of any insurance all rents & the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 06. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben Owd kitts 14 glodwick oldham gtr manchester with any proceeds of any insurance the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 23. Nov. 1994 Geliefert am 08. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £96,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The rubber duck 5 strand road bootle liverpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Nov. 1994 Geliefert am 15. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £55,200 due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement dated 24TH may 1994 | |
Kurze Angaben The welcome inn 58 north john street st. Helens merseyside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PARAMOUNT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0