FOUR SEASONS (DFK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFOUR SEASONS (DFK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01938282
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED
    156 Great Charles Street Quuensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BETTERCARE U.K. LIMITED13. März 200013. März 2000
    EXTENDICARE (UK) LIMITED16. Nov. 199416. Nov. 1994
    INTERNATIONAL CARE SERVICES LIMITED22. Nov. 198522. Nov. 1985
    SWIFT 349 LIMITED13. Aug. 198513. Aug. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    26 SeitenAM23

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN zum 156 Great Charles Street Quuensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 07. Sept. 2021

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Four Brindleyplace Birmingham B1 2HZ zum 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 28. Juni 2021

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    23 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    22 SeitenAM10

    Beendigung der Bestellung von Benjamin Robert Taberner als Geschäftsführer am 30. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    17 SeitenAM02

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    41 SeitenAM06

    Beendigung der Bestellung von Maureen Claire Royston als Geschäftsführer am 30. Apr. 2020

    1 SeitenTM01

    Vorschlag des Verwalters

    40 SeitenAM03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Norcliffe House Station Road Wilmslow SK9 1BU zum Four Brindleyplace Birmingham B1 2HZ am 16. Apr. 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Beendigung der Bestellung von Martin William Oliver Healy als Geschäftsführer am 30. Jan. 2020

    1 SeitenTM01

    Notification of Mericourt Limited as a person with significant control on 16. Juli 2019

    2 SeitenPSC02

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Martin William Oliver Healy als Direktor am 18. Nov. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Richard William Hammond als Geschäftsführer am 18. Nov. 2019

    1 SeitenTM01

    Cessation of Elli Finance (Uk) Plc as a person with significant control on 30. Apr. 2019

    1 SeitenPSC07

    Change of details for Elli Finance (Uk) Plc as a person with significant control on 17. Mai 2019

    2 SeitenPSC05

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    28 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    24 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Sekretär
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188568040001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Sekretär
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    MURPHY, Marc
    39 Cranmore Park
    BT9 6JF Belfast
    Sekretär
    39 Cranmore Park
    BT9 6JF Belfast
    Irish88620540001
    PALMER, Martin Trevor Digby
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British79436600001
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Sekretär
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    British65359270002
    RIDGWELL, David William
    4 Browns Lane
    Hastoe
    HP23 6LX Tring
    Hertfordshire
    Sekretär
    4 Browns Lane
    Hastoe
    HP23 6LX Tring
    Hertfordshire
    British1691410001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    CALDWELL, Charles Anthony
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Geschäftsführer
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandBritish65779460001
    CALKIN, Joy Durfee, Dr
    Suite 915,
    610 Bullock Drive
    L3R 0G1 Unionville
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    Suite 915,
    610 Bullock Drive
    L3R 0G1 Unionville
    Ontario
    Canada
    Canadian55624300001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CARTER, James Wesley
    28 Teddington Park Avenue
    Toronto
    M4N 2C3 Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    28 Teddington Park Avenue
    Toronto
    M4N 2C3 Ontario
    Canada
    Canadian48953740001
    GEARY, Michael
    20 Castlehill Road
    BT4 3GL Belfast
    Geschäftsführer
    20 Castlehill Road
    BT4 3GL Belfast
    British143518040001
    HAMMOND, Timothy Richard William
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Geschäftsführer
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    EnglandBritish205777760001
    HARRIS, Douglas James
    14 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    14 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Canadian39267910003
    HEALY, Martin William Oliver
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Geschäftsführer
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomIrish134003120002
    HEHIR, Anthony Patrick
    Scolty Lodge 12 Oldfield Road
    Heswall
    CH60 6SE Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Scolty Lodge 12 Oldfield Road
    Heswall
    CH60 6SE Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish111038070001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Geschäftsführer
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    HOW, Alistair Maxwell
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Geschäftsführer
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish169139000001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    LADLY, Frederick Bernard
    11 Friars Lane
    Islington
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    11 Friars Lane
    Islington
    Ontario
    Canada
    Canadian33893980002
    LAMBERT, Richard Edwards
    31 Hogback Wood Road
    HP9 1JT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    31 Hogback Wood Road
    HP9 1JT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    UkBritish149807760001
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Geschäftsführer
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    British77781180001
    MCLAUGHLIN, John Gordon
    38 Linden Crescent
    FOREIGN Brampton Ontario L6s 3az Canada
    Geschäftsführer
    38 Linden Crescent
    FOREIGN Brampton Ontario L6s 3az Canada
    Canadian44356870001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    NEALE, Charles Christopher Anthony
    62 Scarsdale Villas
    W8 6PP London
    Geschäftsführer
    62 Scarsdale Villas
    W8 6PP London
    British24748590001
    O'REILLY, Michael Patrick
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Geschäftsführer
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish40241900001
    ORESCHNICK, Robert
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    American82179080001
    PATTERSON, Gordon
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Geschäftsführer
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern IrelandBritish65359330001
    PATTERSON, Gordon
    No 5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    No 5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern Ireland
    British66574310004
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish65359270002
    RHINELANDER, Melvin Gilbert
    19 Aylesbury Road
    Toronto
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    19 Aylesbury Road
    Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian66168700001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindleyplace
    Geschäftsführer
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindleyplace
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Geschäftsführer
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    SMITH, Michael John
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    Geschäftsführer
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    EnglandBritish641150001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    16. Juli 2019
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03633551
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Suite 3 Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    C/O Alvarez & Marsal Europe Llp
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Suite 3 Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    C/O Alvarez & Marsal Europe Llp
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer08094161
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03863850
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat FOUR SEASONS (DFK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A security deed
    Erstellt am 30. Okt. 2006
    Geliefert am 17. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse London Branch
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 23. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1999
    Geliefert am 16. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Aug. 1998
    Geliefert am 14. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south side of springfield road elburton t/no: DN56894. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 1998
    Geliefert am 09. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south west of cherrys road and to the south of rotherhsm rpad cundy cross barnsley t/n SK154952 SYK344991 SYK354662. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 1998
    Geliefert am 09. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The elms nursing home and dwellinghouse known as le mar elm drive louth lincolnshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 1998
    Geliefert am 09. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the east side of north road berwick upon tweed t/n ND60893. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 1998
    Geliefert am 09. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the west side of fordcombe road fordcombe kent t/n K610202. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Sept. 1995
    Geliefert am 12. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a hilltop manor nursing home, high lane t/no. SF349920. Fixed charge over all buildings and other structures fixed to the property. Fixed charge over any goodwill relating to the property. Fixed charge over all plant machinery and other chattels attached to the property. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property. Assignment of the rental sums. Fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to any of the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 1995
    Geliefert am 14. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the f/h property k/a bickleigh down care centre t/no dn 237139. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 1995
    Geliefert am 14. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the f/h property k/a meadowbrook nursing home t/no SL83650. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1993
    Geliefert am 11. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property cherry tree nursing home barnsley t/n syk 317417.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1993
    Geliefert am 11. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a berwick nursing home berwick-upon-thames.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 1993
    Geliefert am 26. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or cherry tree homeslimited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property k/a cherry tree nursing home cherrys road cundy cross barnsley.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 1993
    Geliefert am 26. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or nursing home estates limited on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the freehold property k/a cherry tree nursing home cherry road cundy cross barnsley.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 1991
    Geliefert am 26. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Maple lodge nursing home scotton, catterick garrison north yorkshire t/no:- nyk 67936.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 1991
    Geliefert am 01. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to north east of perry road west scunthorpe t/n hs 174511.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FOUR SEASONS (DFK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. März 2020Beginn der Verwaltung
    29. Sept. 2021Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0