SPARTEK ENGINEERING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSPARTEK ENGINEERING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01946067
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SPARTEK ENGINEERING LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich SPARTEK ENGINEERING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SPARTEK ENGINEERING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SPEEDCO LIMITED21. Nov. 200021. Nov. 2000
    PRIMO (U.K.) LIMITED10. Dez. 199310. Dez. 1993
    MARLEY PRIMO LIMITED24. Jan. 198924. Jan. 1989
    SCANORAMA LIMITED15. Nov. 198515. Nov. 1985
    SHONECLICK LIMITED10. Sept. 198510. Sept. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPARTEK ENGINEERING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für SPARTEK ENGINEERING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Dez. 2011

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Juni 2011

    Kapitalaufstellung am 15. Juni 2011

    • Kapital: GBP 3,450,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    1 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    1 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Egerton Darling am 28. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für John Mcfaull am 28. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Karen Roberts am 27. Sept. 2010

    2 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 16 Stanier Way Wyvern Business Park Derby Derbyshire DE21 6BF England am 27. Sept. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Egerton Darling am 13. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für John Mcfaull am 13. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Karen Roberts am 13. Jan. 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    1 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    1 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von SPARTEK ENGINEERING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Sekretär
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish13813980005
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British83628430003
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Sekretär
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    JONES, Louis Philip
    36 Tavistock Close
    Walderslade
    ME5 9HU Chatham
    Kent
    Sekretär
    36 Tavistock Close
    Walderslade
    ME5 9HU Chatham
    Kent
    British27726950001
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    MADSEN, Kim
    Kinkelves 30
    6823 Ansager
    FOREIGN Denmark
    Sekretär
    Kinkelves 30
    6823 Ansager
    FOREIGN Denmark
    Danish44914770001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    RYAN, Marilyn
    Malibu
    Westcliff Drive
    ME12 2LR Minster
    Kent
    Sekretär
    Malibu
    Westcliff Drive
    ME12 2LR Minster
    Kent
    British123914210001
    RYAN, Marilyn
    Malibu
    Westcliff Drive
    ME12 2LR Minster
    Kent
    Sekretär
    Malibu
    Westcliff Drive
    ME12 2LR Minster
    Kent
    British123914210001
    SORENSEN, Phillip Alan
    Three Gables
    TN8 6AJ Edenbridge
    Kent
    Sekretär
    Three Gables
    TN8 6AJ Edenbridge
    Kent
    British806340001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    Sekretär
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    BORG, Helge Kjaer
    Grundtwigsvej 13
    Dk-6800
    Varde
    Denmark
    Geschäftsführer
    Grundtwigsvej 13
    Dk-6800
    Varde
    Denmark
    Danish29229280002
    BROWN, Roy Frederick
    Westmorland House Westmorland Road
    SL6 4HB Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Westmorland House Westmorland Road
    SL6 4HB Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish41549370002
    CHEESMAN, Christopher
    Copper Beeches Ox Lane
    St Michaels
    TN30 6PE Tenterden
    Kent
    Geschäftsführer
    Copper Beeches Ox Lane
    St Michaels
    TN30 6PE Tenterden
    Kent
    United KingdomBritish110649380001
    DAVIES, Michael Thomas
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    British50770000001
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Geschäftsführer
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritish56562210001
    GODDARD, David Peter
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish8828350002
    GRUNNET, Fleming
    Sondergade 4 6862
    Tistrup
    Denmark
    Geschäftsführer
    Sondergade 4 6862
    Tistrup
    Denmark
    Danish10858500001
    HANRAHAN, Shaun Patrick
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    Geschäftsführer
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    British49298590002
    JACKMAN, Peter Frederick
    78 The Moors
    OX5 2AG Kidlington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    78 The Moors
    OX5 2AG Kidlington
    Oxfordshire
    British49464170001
    LINDHARDT, Bent
    Jernbanegade 6
    FOREIGN Brorwd 6650
    Denmark
    Geschäftsführer
    Jernbanegade 6
    FOREIGN Brorwd 6650
    Denmark
    Danish10858510002
    NASH, Robert Leslie
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    United KingdomBritish83397580001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritish30958650001
    SIMPSON, Kenneth
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    British27376570002
    VEARONELLY, Alistair
    Caol Ila 9 Broad Oak
    Brenchley
    TN12 7NN Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Caol Ila 9 Broad Oak
    Brenchley
    TN12 7NN Tonbridge
    Kent
    British9872950001
    WAKELIN, Andrew Shaw
    6 Newton Road
    ME13 8DY Faversham
    Kent
    Geschäftsführer
    6 Newton Road
    ME13 8DY Faversham
    Kent
    British29229260001
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    Hat SPARTEK ENGINEERING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A guarantee and debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 25. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee (The Security Trustee) for the Securedparties
    Transaktionen
    • 25. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Erstellt am 22. Nov. 2000
    Geliefert am 08. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company (formerly known as primo (UK) limited) to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juni 1992
    Geliefert am 25. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SPARTEK ENGINEERING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Jan. 2013Aufgelöst am
    09. Dez. 2011Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0