ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01951290 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Victoria Street SW1E 5JL London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CLAYFORM DEVELOPMENTS LIMITED | 26. Nov. 1985 | 26. Nov. 1985 |
| CUTEDEL LIMITED | 30. Sept. 1985 | 30. Sept. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Development Securities Estates Limited als Geschäftsführer am 16. Feb. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Notification of Land Securities Spv’S Limited as a person with significant control on 12. Feb. 2024 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of U and I Exit Limited as a person with significant control on 12. Feb. 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Development Securities Estates Limited am 06. Okt. 2022 | 1 Seiten | CH02 | ||
Änderung der Details des Direktors für Development Securities Estates Plc am 04. Okt. 2019 | 1 Seiten | CH02 | ||
Change of details for U and I Exit Limited as a person with significant control on 06. Okt. 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 6 Seiten | AA | ||
Ernennung von U and I Company Secretaries Limited als Sekretär am 05. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP04 | ||
Beendigung der Bestellung von Ls Company Secretaries Limited als Sekretär am 05. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von U and I Director 2 Limited als Direktor am 05. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP02 | ||
Ernennung von U and I Director 1 Limited als Direktor am 05. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 7a Howick Place London SW1P 1DZ United Kingdom zum 100 Victoria Street London SW1E 5JL am 06. Okt. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr George Mark Richardson am 18. Aug. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard Upton als Geschäftsführer am 30. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jamie Graham Christmas als Geschäftsführer am 31. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Chris Barton als Sekretär am 17. Dez. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Ls Company Secretaries Limited als Sekretär am 17. Dez. 2021 | 2 Seiten | AP04 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 10 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Jamie Graham Christmas als Direktor am 31. Mai 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U AND I COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England |
| 301504670001 | ||||||||||
| RICHARDSON, George Mark | Geschäftsführer | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England | United Kingdom | British | 300754680001 | |||||||||
| U AND I DIRECTOR 1 LIMITED | Geschäftsführer | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England |
| 301323850001 | ||||||||||
| U AND I DIRECTOR 2 LIMITED | Geschäftsführer | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England |
| 301323930001 | ||||||||||
| BARTON, Chris | Sekretär | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | 193936360001 | |||||||||||
| BRAYSHAW, Martin John | Sekretär | 87 Main Street Lyddington LE15 9LS Oakham Leicestershire | British | 8606990001 | ||||||||||
| CROMPTON, Rita Mary | Sekretär | 36 Priory Avenue N8 7RN London | British | 4779150001 | ||||||||||
| LANES, Stephen Alec | Sekretär | Thorpe House 105 Mycenae Road Blackheath SE3 7RX London | British | 1266100003 | ||||||||||
| RATSEY, Helen Maria | Sekretär | Bressenden Place SW1E 5DS London Portland House England | British | 158443240001 | ||||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Sekretär | Bressenden Place SW1E 5DS London Portland House England England | 190689580001 | |||||||||||
| WARE, Robert Thomas Ernest | Sekretär | 3 Bayliss Road Wargrave RG10 8DR Reading Berkshire | British | 4779170001 | ||||||||||
| LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England England |
| 159674790001 | ||||||||||
| BODIE, Anthony Ellyah | Geschäftsführer | 112 Clifton Hill NW8 OJS London | British | 34902790002 | ||||||||||
| BURLETSON, Bryan Richard | Geschäftsführer | Farmhouse Templecombe RG9 3HP Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 57633110005 | |||||||||
| CHATTERJEE, Vivienne Teresa | Geschäftsführer | 18 Belsize Crescent NW3 5QU London | British | 9092320001 | ||||||||||
| CHRISTMAS, Jamie Graham | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 162910480002 | |||||||||
| CORDEREY, Neil Sinclair | Geschäftsführer | 5 Barton Road AL4 8QG Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 74024640001 | |||||||||
| DOWLING, Brian Sidney Preston | Geschäftsführer | Crest House Silver Street Goffs Oak EN7 5JE Cheshunt | British | 36851910001 | ||||||||||
| MARX, Michael Henry | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 35019090001 | |||||||||
| UPTON, Richard | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | England | British | 204950320001 | |||||||||
| VAUGHAN, Steven Mark | Geschäftsführer | 16 Kittiwake Close Woodley RG5 4UF Reading Berkshire | British | 9092330001 | ||||||||||
| WARE, Robert Thomas Ernest | Geschäftsführer | 3 Bayliss Road Wargrave RG10 8DR Reading Berkshire | British | 4779170001 | ||||||||||
| WEINER, Matthew Simon | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 72888710002 | |||||||||
| DEVELOPMENT SECURITIES ESTATES LIMITED | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England |
| 53858600004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Securities Spv’S Limited | 12. Feb. 2024 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| U And I Exit Limited | 24. Nov. 2020 | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Development Securities (Investments) Plc | 06. Apr. 2016 | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of release and substitution | Erstellt am 13. Okt. 1993 Geliefert am 18. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £20,000,000 11 percent. First mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben The capital sum of £3,050,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission | Erstellt am 05. Mai 1993 Geliefert am 12. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h & l/h property of the company both present and future including all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on any such property and all vendor's liens mortgages charges options agreements and rights titles and interests in or over land of whatever description both present and future (for full details see form 395 and contd sheets attached). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Apr. 1993 Geliefert am 30. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 19. Apr. 1993 Geliefert am 28. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 25. Nov. 1992 Geliefert am 30. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £20,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other monies intended to be secured by the deed and the existing deeds (as defined) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben The capital sum of £450,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Apr. 1992 Geliefert am 16. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of white lion road amersham bucks t/no.bm 117999. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 06. Apr. 1992 Geliefert am 08. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Principal and interest on £20,000,000 11% first mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other moneys intended to be secured by this deed and the existing deeds (as defined) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben Freehold property known as repton place white lion road amersham buckinghamshiresee form 395 ref M114. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 02. Sept. 1991 Geliefert am 20. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of loan agreements (as defined) and/or this charge | |
Kurze Angaben F/H repton place land and buildings on the north side of white lion road amersham, bucks t/no bm 117999. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Aug. 1990 Geliefert am 29. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Land & buildings on the north side of white lion road, amersham buckinghamshire title no:- bm 177999. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1990 Geliefert am 28. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and clayform properties to the chargee. | |
Kurze Angaben F/H convergent house white lion road amersham buckinghamshire t/no bm 117999. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Dez. 1988 Erworben am 31. März 1989 Geliefert am 20. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben Convergent house (formerly meteor house) white lion road, amersham chiltern, bucks t/no bm 117999. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First mortgage | Erstellt am 04. Feb. 1988 Erworben am 31. März 1989 Geliefert am 20. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben 75,77,79 morsey street tower hamlets london t/no ln 136773. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Feb. 1986 Geliefert am 19. März 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 56 and 58 middle street yeovil somerset. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Jan. 1986 Geliefert am 15. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 49-52 st johns square and 8 jerusalem passage l/b of islington title nos 309848 433334 ln 5306. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Dez. 1985 Geliefert am 02. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 77/77A high street, andover, hampshire t/n hp 197774. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0