BURNSIDE LODGE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBURNSIDE LODGE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01954944
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BURNSIDE LODGE LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich BURNSIDE LODGE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    No 1 Dorset Street
    Southampton
    SO15 2DP
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BURNSIDE LODGE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SWIFT 926 LIMITED05. Nov. 198505. Nov. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BURNSIDE LODGE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für BURNSIDE LODGE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Dez. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Juni 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Dez. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Juni 2009

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten288c

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Dez. 2008

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    9 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2005

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von BURNSIDE LODGE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LUCK, Richard Nigel
    North Street
    Winkfield
    SL4 4TE Windsor
    The Mouse House
    Berks
    Sekretär
    North Street
    Winkfield
    SL4 4TE Windsor
    The Mouse House
    Berks
    British61070930002
    KING, Christopher
    53 Kings Road
    TW10 6EG Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    53 Kings Road
    TW10 6EG Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish77423330002
    LUCK, Richard Nigel
    North Street
    Winkfield
    SL4 4TE Windsor
    The Mouse House
    Berks
    Geschäftsführer
    North Street
    Winkfield
    SL4 4TE Windsor
    The Mouse House
    Berks
    United KingdomBritish61070930002
    BURNS, Freda Robson
    100 Marine Avenue
    NE26 3LS Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Sekretär
    100 Marine Avenue
    NE26 3LS Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British11995240001
    ELLIOT, Colin David
    17 St Anns Terrace
    NW8 6PH London
    Sekretär
    17 St Anns Terrace
    NW8 6PH London
    British104177230001
    JOHN, Storey
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE3 5BX London
    Sekretär
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE3 5BX London
    British104826970001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1, 3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Sekretär
    Flat 1, 3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British96974070001
    MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    British73852970001
    BURNS, Freda Robson
    100 Marine Avenue
    NE26 3LS Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    100 Marine Avenue
    NE26 3LS Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British11995240001
    BURNS, Malcolm Joseph
    100 Marine Avenue
    NE26 3LS Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    100 Marine Avenue
    NE26 3LS Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British11995250001
    ELLIOT, Colin David
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    Geschäftsführer
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    British84492240002
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Geschäftsführer
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Geschäftsführer
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Geschäftsführer
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    SAVAGE, Andrew
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    Geschäftsführer
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    EnglandBritish117869550001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Geschäftsführer
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002
    STOREY, Roger Christopher
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish1663050001
    WALKER, Susan
    35 West Wynd
    Killingworth
    NE12 6FP Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    35 West Wynd
    Killingworth
    NE12 6FP Newcastle Upon Tyne
    British11995260002

    Hat BURNSIDE LODGE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 25. Aug. 2004
    Geliefert am 07. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a cleveland park nursing home cleveland road north shields tyne and wear t/nos TY316048, TY155738, TY11885, TY188761, TY160373 and TY188596. The f/h property k/a appleby care home military road north shields tyne and wear t/no TY342880.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General mortgage debenture
    Erstellt am 25. Aug. 2004
    Geliefert am 07. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 17. Juni 2004
    Geliefert am 02. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent to the trustee and the noteholders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being cleveland park nursing home cleveland south,north shields tyne and wear t/n's TY316048 TY160373 TY188596 TY11885 TY18876 TY155738 and the f/h property appleby care home military road north shields tyne and wear t/n TY342880,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Graphite Capital Management Limited as Trustee for Each of the Noteholders (The Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juni 2004
    Geliefert am 25. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 25. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 17. Juni 2004
    Geliefert am 25. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property being cleveland park nursing home at cleveland road north shields tyne and wear t/no TY316048, t/no TY160373, t/no TY188596, t/no TY11885, t/no T188761 & t/no TY155738 & f/h property known as appleby care home at military road north shields tyne and wear t/no TY342880.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 25. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Jan. 2001
    Geliefert am 20. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on military road north shields tyne and wear t/n TY342880. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Jan. 1996
    Geliefert am 17. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as allotment no 24 cleveland road north shields tyne & wear and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 02. Nov. 1995
    Geliefert am 13. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Nov. 1995
    Geliefert am 13. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as land at cleveland road north shields tyne & wear and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Dez. 1989
    Geliefert am 13. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 67 marine avenue whitley bay tyne & wear & the proceeds of sale thereof tog with a:-. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Apr. 1987
    Geliefert am 10. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Lomax court 5 east parade whitley bay tyne & wear T.no:- ty 165417 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Feb. 1986
    Geliefert am 11. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    27 north parade, whitley bay. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Jan. 1986
    Geliefert am 25. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    42, north parade, whitley bay and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Jan. 1986
    Geliefert am 25. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    St. Abbs 5, rockcliffe gardens, whitley bay and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Jan. 1986
    Geliefert am 25. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    29, north parade whitley bay. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 11. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Jan. 1986
    Geliefert am 21. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    69 to 73 marine avenue, whitley bay, tyne & wear. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BURNSIDE LODGE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Dez. 2007Beginn der Liquidation
    08. Juni 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Robert Whiteley Smith
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praktiker
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Andrew David Conquest
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praktiker
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0