TOMORROWS LEISURE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTOMORROWS LEISURE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01960179
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Grant Thorton Uk Llp
    Grant Thorton House
    NW1 2EP Melton Street Euston Square
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GAMEHOST LIMITED15. Nov. 198515. Nov. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2004

    Welche sind die letzten Einreichungen für TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Okt. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Apr. 2011

    5 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Richard Bingham als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Martin May als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Okt. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Apr. 2010

    5 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Gorman als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Apr. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Okt. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Okt. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Vermögensübersicht

    6 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRUCE, Andrew David
    57 Aragon Road
    KT2 5QB Kingston Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    57 Aragon Road
    KT2 5QB Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishSolicitor55572430002
    GEMMILL, Thomas Cochran
    North View North Road
    Ponteland
    NE20 0AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    North View North Road
    Ponteland
    NE20 0AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British14010350001
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Sekretär
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    INWOOD, Leslie George
    Poplar Cottage Rye Common
    RG29 1HT Odiham
    Hampshire
    Sekretär
    Poplar Cottage Rye Common
    RG29 1HT Odiham
    Hampshire
    British1569310001
    JONES, Michael Robert
    18 Meadowfield
    Red House Farm Estate
    NE25 9YD Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Sekretär
    18 Meadowfield
    Red House Farm Estate
    NE25 9YD Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British34824970001
    ANYSZ, Barry Aubrey
    10 Wigton Chase
    Wigton Lane
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Wigton Chase
    Wigton Lane
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector18679440001
    BINGHAM, Richard Keith
    34 Lyndhurst Drive
    TN13 2HQ Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    34 Lyndhurst Drive
    TN13 2HQ Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector76681420001
    BLAXALL, Christopher Stanley
    The Old School House
    Church Lane
    NE44 6AP Riding Mill
    Northumberland
    Geschäftsführer
    The Old School House
    Church Lane
    NE44 6AP Riding Mill
    Northumberland
    BritishManaging Director23769920002
    BRUCE, Andrew David
    22 Penrith Road
    KT3 3QS New Malden
    Surrey
    Geschäftsführer
    22 Penrith Road
    KT3 3QS New Malden
    Surrey
    BritishCompany Director55572430001
    DAWSON, Peter
    Hill Bank Batt House Road
    NE43 7RA Stocksfield
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Hill Bank Batt House Road
    NE43 7RA Stocksfield
    Northumberland
    BritishDirector38651710001
    EDWARDS, David James
    Greencroft 38 Dunbar Road
    EH41 3PJ Haddington
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Greencroft 38 Dunbar Road
    EH41 3PJ Haddington
    East Lothian
    BritishCompany Director9489100001
    FOSTER, Christopher Kenneth
    Springwood House The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Springwood House The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director36477980002
    GEMMILL, Thomas Cochran
    North View North Road
    Ponteland
    NE20 0AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    North View North Road
    Ponteland
    NE20 0AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishChartered Accountant/Director14010350001
    GODFREY, Nicholas Joseph
    Flat 3
    48 Red Lion Street
    WC1R 4PF London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    48 Red Lion Street
    WC1R 4PF London
    United KingdomBritishFinance Director89433450001
    INY, Oliver Oliver
    38 Upper Brook Street
    Mayfair
    W1Y 1PE London
    Geschäftsführer
    38 Upper Brook Street
    Mayfair
    W1Y 1PE London
    United KingdomBritishDeveloper8210140002
    LANSBURY, Geoffrey
    St Ivers Corner
    Doggett Wood Lane
    HP8 4TD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    St Ivers Corner
    Doggett Wood Lane
    HP8 4TD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishAccountant55614860001
    MAY, Martin Keith
    3 Caribou Close
    Off Butts Hill Road Woodley
    RG5 4RA Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    3 Caribou Close
    Off Butts Hill Road Woodley
    RG5 4RA Reading
    Berkshire
    BritishDirector90818620001
    POWELL, Malcolm
    23 Woodlands
    High Rickleton
    NE38 9HD Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    23 Woodlands
    High Rickleton
    NE38 9HD Washington
    Tyne & Wear
    BritishHotelier/Director48781890001
    REBEIRO, Paul Edward
    15 Barn Close
    AL8 6ST Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    15 Barn Close
    AL8 6ST Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishAccountant102840510001
    ROBERTS, Thomas John Blackburn
    Southwick Court
    Southwick
    BA14 9QB Trowbridge
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Southwick Court
    Southwick
    BA14 9QB Trowbridge
    Wiltshire
    BritishSolicitor/Director35567350001
    SANDERSON, John Taylor
    30 The Oval
    Forest Hall
    NE12 9PP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    30 The Oval
    Forest Hall
    NE12 9PP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector14010330001
    WILSON, Vincent
    94 John F Kennedy Estate
    NE38 7AL Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    94 John F Kennedy Estate
    NE38 7AL Washington
    Tyne & Wear
    BritishDirector30966780001

    Hat TOMORROWS LEISURE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 29. Aug. 2002
    Geliefert am 12. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from wiggins management services limited ("the principal debtor") and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and premises situate and k/a land and buildings lying to the south of cranwick avenue and land and buildings lying on the east side of london road, bracebridge heath t/no. LL114848 and all buildings fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Compania Financiera La Granja Sa
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Aug. 2002
    Geliefert am 11. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or wiggins group PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings lying to the south of canwick avenue and land and buildings lyig on the east side of london road bracebridge heath t/n LL114848 all fixtures fittings plant and machinery all rental or licence fees and any insurance.
    Berechtigte Personen
    • Siem Oceanic LTD
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Aug. 2002
    Geliefert am 11. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities on any account whatsoever due or to become due from the principal debtor and/or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land and premises known as land and buildings lying to the south of canwick avenue and land and buildings lying on the east side of london road,bracebridge heath; t/no ll 114848; all rights,powers,easements and liberties attached thereto and all buildings,fixtures,fittings,plant,machinery,apparatus,goods and materials thereon; all right title and interest in and to all the rental or licence fee income received thereunder and all payments in respect of services and insurance contributions receivable whatsoever; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldbridge Ventures Limited,Columbus Asset Management Limited and Jeffrey Vernon Wilkinson
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings lying to the south of canwick avenue and land and buildings lying on the east side of london road bracebridge heath north keverston county of lincolnshire t/n LL114848 all fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials by way of assignment the benefit of the landlord to and in the lease,all insurances in respect of the property,and agreements for sale,all existing and future easements,all shares rights benefits and advantages any copyrights of any plans in connection with the property,the benefit of bonds and licences the benefit of any guarantees by way of floating charge all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Okt. 1997
    Geliefert am 04. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £2,100,000.00 plus interest due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Premises and buildings at st johns park bracebridge heath lincoln on the south side of canwick avenue t/n ll 114848.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (being a principal sum of £3,000,000) to the chargee under the terms of a facility agreement of even date ("the facility agreement")
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Onroerdend Goed Maatschappij Kasteellei N.V.
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a fee agreement of even date ("the fee agreement")
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Compania Naviera El Sarten S.A.
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Mai 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a hellaby hall hellaby lane hellaby rotherham south yorkshire t/no's SYK102910 SYK296454 and SYK285611. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Mai 1995
    Geliefert am 10. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,200,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a sale agreement
    Kurze Angaben
    All that f/h proerty k/a hellaby hall hellaby lane hellaby rotherham south yorkshire t/no's SYK102910 syk 296454 and SYK285611 with all fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Family Assurance Friendly Society Limited
    Transaktionen
    • 10. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Convertible debenture
    Erstellt am 17. Feb. 1994
    Geliefert am 23. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • John Taylor Sanderson
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Convertible debenture
    Erstellt am 30. Juli 1993
    Geliefert am 16. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to the chargees under the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • David Goldman and Graham Wylie
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Dez. 1992
    Geliefert am 08. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property at appledore building northumbria way, killingworth, newcastle upon tyne and a floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment
    Erstellt am 08. Sept. 1992
    Geliefert am 23. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or norstead leisure limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All details of an agreement dated 10TH october 1991 re garden festival site,liverpool,merseyside and an assignment over all moneys under the agreement (see doc ref M589C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1991
    Geliefert am 17. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the east of swinley rd., Ascot, berks. T/no. Bk 201675.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 29. Jan. 1990
    Geliefert am 13. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of funds totalling sterling pounds 6,100,000 invested now or in the future with barclays de zoete wedd limited.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    • 29. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 19. Juni 1989
    Geliefert am 28. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Nov. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equitable charge
    Erstellt am 16. Dez. 1988
    Geliefert am 20. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 133,846 and all other moneys due or to become due from the company and/or selltime limited or any subsidiary to the chargee or any associated trading or subsidiary company
    Kurze Angaben
    L/H units 100, 101, 1/79 and 1/80 metro centre gateshead tyne and wear.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle Breweris PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Nov. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equitable charge
    Erstellt am 16. Nov. 1988
    Geliefert am 19. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 216,154 and all other moneys due or to become due (including moneys due for goods supplied) from the company and/or selltime limited or any subsidiary to scottish & newcastle breweries PLC or any associated at trading subsidiary as defined in the deed
    Kurze Angaben
    L/H units 100, 101, 1/79 and 1/80 metro centre gateshead tyne and wear.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Nov. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 07. Nov. 1988
    Geliefert am 14. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 29. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 17. Juni 1988
    Geliefert am 28. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 354,000 and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and/or the trading companies' (as defined) under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Nov. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 22. Dez. 1986
    Geliefert am 07. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 29. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TOMORROWS LEISURE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. März 2012Aufgelöst am
    21. Okt. 2005Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew David Conquest
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praktiker
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praktiker
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0