BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01963380 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED?
- (6512) /
Wo befindet sich BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5th Floor 16 Eastcheap EC3M 1BD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE UNION DISCOUNT COMPANY OF LONDON LIMITED | 27. Juli 2001 | 27. Juli 2001 |
| UNION DISCOUNT COMPANY LIMITED | 06. Jan. 1986 | 06. Jan. 1986 |
| CRATEFLEET LIMITED | 22. Nov. 1985 | 22. Nov. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Finsbury Square London EC2A 1AD am 03. Sept. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Juli 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2007 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2006 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBRUS LIMITED | Sekretär | Finsbury Square EC2A 1AD London 10 | 99212380004 | |||||||
| BROWALLIA CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AD London 10 | 96468430005 | |||||||
| DAVENPORT, Kathryn Anne | Sekretär | 117 Chiswick Village W4 3BZ London | British | 60311620002 | ||||||
| STEADMAN, Valentine Germaine Cecile | Sekretär | 11 Titmore Green Little Wymondley SG4 7JT Hitchin Hertfordshire | British | 81906140001 | ||||||
| TRANTOR, Colin Grant | Sekretär | 25 Courtenay Avenue SM2 5ND Sutton Surrey | British | 52881000001 | ||||||
| VARDY, Richard John | Sekretär | Court Cottage Headley Road GU26 6DL Grayshott Surrey | British | 153085180001 | ||||||
| WOOD, David Roy | Sekretär | 37 Branscombe Gardens Thorpe Bay SS1 3PJ Southend On Sea Essex | British | 53910300002 | ||||||
| WOOD, David Roy | Sekretär | 6 Old School Field Springfield Green CM1 7HU Chelmsford Essex | British | 53910300001 | ||||||
| ANDERSON, Andrew John | Geschäftsführer | 19 Chishill Road Heydon SG8 8PW Royston Hertfordshire | England | British | 33765840001 | |||||
| ANDERSON, Andrew John | Geschäftsführer | 19 Chishill Road Heydon SG8 8PW Royston Hertfordshire | England | British | 33765840001 | |||||
| BABER, Ralph Peter | Geschäftsführer | Oaklands 5 Queenborough Gardens BR7 6NP Chislehurst Kent | England | British | 150093220001 | |||||
| BASKERVILLE, David William | Geschäftsführer | 1 Broadstone Cottage Withies Lane GU3 1JD Compton Guildford Surrey | British | 33765850001 | ||||||
| BLUNDEN, George Patrick | Geschäftsführer | 63 Leopold Road Wimbledon SW19 7JG London | Uk | British | 33722340001 | |||||
| BRADLEY, John Heasman | Geschäftsführer | Spinners Welle Sutton Road Kington Langley SN15 5NE Chippenham Wiltshire | British | 33735400001 | ||||||
| BURBANKS, Magnus Philip | Geschäftsführer | 14 Rosemary Gardens Mortlake SW14 7HD London | British | 99211440001 | ||||||
| COSSEY, Geoffrey William | Geschäftsführer | Old Rectory Henny Road, Lamarsh CO8 5EU Bures Suffolk | British | 37377430002 | ||||||
| DIXON, Peter John Bellett, Sir | Geschäftsführer | 34 Canonbury Park North N1 2JJ London | United Kingdom | British | 4902740001 | |||||
| FEX, Lars Gustav | Geschäftsführer | Karolineragen 6 Lerhamn Nyhamnslager 260 41 Sweden | Sweden | Swedish | 114092280001 | |||||
| GENT, Brian Stanley Page | Geschäftsführer | Greenacres Framfield TN22 5PN Uckfield East Sussex | British | 7401460001 | ||||||
| JOHNSON, James Richard | Geschäftsführer | 47 Denmans Lane Lindfield RH16 2JN West Sussex | British | 33646390001 | ||||||
| LYNN, George | Geschäftsführer | The Birches London Road SG4 9ET Hitchin Herts | British | 7179760001 | ||||||
| LYONS, Derek Jack | Geschäftsführer | 8 Firs Avenue East Sheen SW14 7NZ London | United Kingdom | British | 78419110001 | |||||
| MARTIN, Ian James | Geschäftsführer | Domaine De Peyloubere 32550 Pavie France | British | 33782910001 | ||||||
| PONTIFEX, Anthony Marshall Richard | Geschäftsführer | 1 Manor Grove BR3 5LB Beckenham Kent | British | 83068930001 | ||||||
| THURSFIELD, John Richard | Geschäftsführer | Hodges Farm Lower Froyle GU34 4LL Alton Hampshire | United Kingdom | British | 33723780001 | |||||
| TRIMMING, John Colin | Geschäftsführer | Timbers Knowle Lane Loxwood Road Alfold GU6 8AP Cranleigh Surrey | British | 41835200001 | ||||||
| WALKER, James Alan Fairley | Geschäftsführer | Priddeons Hadley Common EN5 5QE Barnet Hertfordshire | England | British | 7945280002 | |||||
| WIGLEY, Ewen | Geschäftsführer | Little Harps Crouch Lane TN15 8LX St Marys Platt Kent | England | British | 45904370004 | |||||
| WIGLEY, Ewen | Geschäftsführer | Little Harps Crouch Lane TN15 8LX St Marys Platt Kent | England | British | 45904370004 | |||||
| WOOD, David Roy | Geschäftsführer | 37 Branscombe Gardens Thorpe Bay SS1 3PJ Southend On Sea Essex | British | 53910300002 | ||||||
| WOOD, David Roy | Geschäftsführer | 37 Branscombe Gardens Thorpe Bay SS1 3PJ Southend On Sea Essex | British | 53910300002 |
Hat BROWALLIA DISCOUNT COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Erstellt am 21. Okt. 2003 Geliefert am 08. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,745,702 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the issued shares of the union discount company of london limited together with all future shares or securities rights dividends monies warrants or property paid. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge letter | Erstellt am 23. Juli 1996 Geliefert am 27. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge all the company's right title and interest to and in all designated securities.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of fixed charge | Erstellt am 21. Sept. 1992 Geliefert am 26. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge all sums now and from time to time hereafter receivable by the company by reason or in respect of any transfer or debit of stock or other securites from any stock account for full details see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 06. Aug. 1991 Geliefert am 24. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Designated securities as defined by letter of charge dated 6TH august 1991. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Juli 1991 Geliefert am 22. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the company's right title and interest in all designated securities as defined in a legal charge dated 4/7/91. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of fixed charge | Erstellt am 04. Juli 1991 Geliefert am 20. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in all designated securities by way of fixed charge see form 3395 for full details. S. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 04. Juli 1991 Geliefert am 17. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Securities which shall include but not be limited to stocks and shares, bills of exchange etc. see 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge. | Erstellt am 09. Feb. 1987 Geliefert am 11. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement dated 9/2/87 and this charge on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All sums being receivable by the company by reasons or in respect of any transfer or debit of stock or other securities by way of floating charge all right titlle & interest of the company in (1) stock & other securities see doc for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral agreement. | Erstellt am 20. Jan. 1987 Geliefert am 03. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All the borrowers right title interest in & to all securities clearance accounts which morgan guaranty brussels currently has opened or in the future may open in the name of the borrower & the amount of all securities which now or in the future shall be standing to the credit of a pledged securities account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0