MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED

MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMILTON KEYNES CITY BUS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01963446
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Daw Bank
    Stockport
    SK3 0DU Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MILTON KEYNES CITYBUS LIMITED22. Nov. 198522. Nov. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 03. Mai 2012

    • Kapital: GBP 1,992,947
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2011

    4 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    7 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Michael John Vaux am 10. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    4 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Leslie Brian Warneford am 01. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Colin Brown am 15. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Michael John Vaux am 07. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2007

    4 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Sekretär
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant85970020003
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director49771140004
    CLAYTON, Michael Bruce
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    Sekretär
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    BritishAccountant27890500005
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Sekretär
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant70283550001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Sekretär
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant70283550001
    HOUSTON, Guy Alan
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant54321810002
    SANKEY, John Frederick
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    Sekretär
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    British7542050001
    SMITH, Richard George
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    Sekretär
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Director1817090001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Sekretär
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Sekretär
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    BritishManager54184420002
    ATKINSON, Gary
    36 Plumstead Avenue
    Bradwell Common
    MK13 8AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    36 Plumstead Avenue
    Bradwell Common
    MK13 8AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director15789380001
    CLAYTON, Michael Bruce
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    BritishAccountant27890500005
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Geschäftsführer
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    BritishCompany Director47574960002
    CONROY, Michael James
    65 Lowlands Close
    NN3 5EX Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    65 Lowlands Close
    NN3 5EX Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director26775900001
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritishExecutive Director1436830002
    EDEN, Philip Brookes, Mr.
    27 Williams Close
    CB7 4FQ Ely
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    27 Williams Close
    CB7 4FQ Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector63838120003
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant70283550001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant70283550001
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Geschäftsführer
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritishFinance Director61722690002
    GUNDEL, Jeffrey
    72 Lowick Court
    Moulton
    NN3 7TY Northampton
    Geschäftsführer
    72 Lowick Court
    Moulton
    NN3 7TY Northampton
    BritishCompany Director37176070001
    HARGREAVES, John Banks
    2 Capel Close
    Summertown
    OX2 7LA Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    2 Capel Close
    Summertown
    OX2 7LA Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director4955990001
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritishCompany Director2268190002
    HOUSTON, Guy Alan
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant54321810002
    MERRYWEATHER, Paul Anthony
    42 Great Lane
    Reach
    CB5 0JF Cambridge
    Cambs
    Geschäftsführer
    42 Great Lane
    Reach
    CB5 0JF Cambridge
    Cambs
    BritishChairman/Director10329770001
    MOORS, Michael Eric
    5 Ridge House
    Ridge House Drive, Festival Park
    ST1 5SJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    5 Ridge House
    Ridge House Drive, Festival Park
    ST1 5SJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director26926420002
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant73518280001
    SANKEY, John Frederick
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    Geschäftsführer
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    BritishCompany Director7542050001
    SMITH, Richard George
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Director1817090001
    WARNER, Barry Alfred
    20 East Butterfield Court
    Goldenash
    NN3 8JG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    20 East Butterfield Court
    Goldenash
    NN3 8JG Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector37224390001
    WILLIAMS, Stephen James
    28 Barnstaple Close
    NN3 3BH Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    28 Barnstaple Close
    NN3 3BH Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director84510700001
    WINTER, John Michael
    7 London Road
    Great Shelford
    CB2 5DB Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    7 London Road
    Great Shelford
    CB2 5DB Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director19625590001

    Hat MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Single debenture
    Erstellt am 29. Apr. 1993
    Geliefert am 04. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Mai 1992
    Geliefert am 27. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M720C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 08. Aug. 1989
    Geliefert am 10. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £702224.21 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    782 aseol marcedes benz minibuses. (See doc. For full details).
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 17. Juni 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Sept. 1988
    Geliefert am 14. Sept. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Sept. 1988Registrierung einer Belastung
    • 17. Juni 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security amendment
    Erstellt am 04. Mai 1988
    Geliefert am 06. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Amending the terms of a debenture dated 7.8.87.
    Kurze Angaben
    The rights & interests conferred on and granted by mckb to spel by clause 3 of the debenture. (See doc. For full details).
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific Euro Finance (U.K.) Limited.
    Transaktionen
    • 06. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    • 17. Juni 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Convertible debenture
    Erstellt am 26. Apr. 1988
    Geliefert am 29. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or generalouter limited to the chargee under or in respect "the indebtedness" (as that term is defined in the charge)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capitalbuildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Pmt Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1988Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Aug. 1987
    Geliefert am 20. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sale agreement a title purchase agreement, a guarantee and debenture cash dated 7 8 87 (as defined) and this charge a any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1/. all the company's right, title and interest in and to the account with security pacific national bank, N.A. or such other account or accounts as may be established by the company pursuant to the provisions of the hire purchase agreement or the debenture and in and to all the moneys that has from time to time accured or is accruing therein which form time to time constitute, the balance standing to the credit of the charged account and 2/. floating charge the whole of the company's undertaking and all property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific Euro Finance (U.K.) Limited
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1987Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0