AEW LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AEW LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01968355 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AEW LIMITED?
- (5030) /
Wo befindet sich AEW LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place London SE1 2AF |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AEW LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AUTELA COMPONENTS LIMITED | 16. Dez. 1985 | 16. Dez. 1985 |
| BELLRITE LIMITED | 04. Dez. 1985 | 04. Dez. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AEW LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | |
Welche sind die letzten Einreichungen für AEW LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. Dez. 2018 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 2 Seiten | RM02 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2018 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2017 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2016 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2015 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2014 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2013 | 3 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2012 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2011 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2010 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2009 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Okt. 2008 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
legacy | 1 Seiten | 405(2) | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von AEW LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHLETT, Mark Roy | Sekretär | 68 Belbroughton Road Blakedown Kidderminster Worcestershire | British | 41420180001 | ||||||
| FAIRCLOUGH, Ian Peter | Sekretär | 17 Claremont Road CV31 3EH Leamington Spa Warwickshire | British | 55444950001 | ||||||
| REDDY, Vuchuru Sadhana | Sekretär | Heathfield House Rotherhams Oak Lane B94 6RW Hockley Heath Warwickshire | British | 25611890006 | ||||||
| SWANSTON, Cindy Leigh | Sekretär | 206 Evesham Road CV37 9AS Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 66129620002 | ||||||
| AMPHLETT, Mark Roy | Geschäftsführer | 68 Belbroughton Road Blakedown Kidderminster Worcestershire | British | 41420180001 | ||||||
| BEST, Nicholas Roger Norman | Geschäftsführer | The Old Coach House Castle Lane BN44 3GA Steyning West Sussex | England | British | 45305900001 | |||||
| HARRIS, John Edwin | Geschäftsführer | 2 Holly Tree Walk Claybrook Magna LE17 5AL Lutterworth Leicestershire | British | 71811150002 | ||||||
| JOYNER, Peter Gordon | Geschäftsführer | The Gables Millers Lane Hornton OX15 6BS Banbury | United Kingdom | British | 10425740001 | |||||
| REDDY, Vuchuru Sadhana | Geschäftsführer | Heathfield House Rotherhams Oak Lane B94 6RW Hockley Heath Warwickshire | British | 25611890006 | ||||||
| RITCHIE, Brian Christopher | Geschäftsführer | 25 Abbeyfields Drive Abbots Lea B80 7BF Studley Warwickshire | British | 74079450001 | ||||||
| SCHOLZE, Robert | Geschäftsführer | 6 Vinefields EH34 5HD Pencaitland East Lothian | Austrian | 23232860001 | ||||||
| SWAN, Christopher Paul Mckinley | Geschäftsführer | Kissingtree House Kissingtree Lane CV37 7QT Alveston Warwickshire | United Kingdom | British | 23232880002 |
Hat AEW LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit charge | Erstellt am 21. Feb. 2001 Geliefert am 13. März 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and other sums payable under a lease made on 27 march 1998 | |
Kurze Angaben All its right title and entitlement to the monies from time to time standing to the credit of the deposit account number 42468106 with hsbc bank PLC and ots right and entitlement to be repaid the same or an amount equal to the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Juli 2000 Geliefert am 24. Juli 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due by any obligor to any secured party under any finance document and all costs charges and expenses incurred in connection therewith (all terms as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Standard security presented for registration in SCOTLAND21ST july 2000 | Erstellt am 30. Juni 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All money and liabilties now or herefater due owing or incurred to the chargee (as security agent and trustee for the benefit of itself and the other secured parties) and to any of the finance parties (as defined in the facility agreement dated 27TH april 2000 (the senior facility agreement) and to the bondholders (as defined in the agreement dated 27TH april 2000 (the "new mezzanine subscription agreement") and to the bondholders and the bondholders'representative as defined in the agreement dated 27TH april 200 (the "restructured mezzanine subscription agreement") by the debtor | |
Kurze Angaben 25/27 new road perth unit 1 forth avenue kircaldy,21 & 211/2 high street and other properties please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 21. März 2000 Geliefert am 31. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £8,350 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 22. März 1996 Geliefert am 30. März 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The whole or any part of the rents reserved by the lease and all other obligations from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Initial deposit £8,350.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 05. Feb. 1991 Geliefert am 06. Feb. 1991 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £6,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 30.12.69 and this charge | |
Kurze Angaben Rent deposit of £6,000 paid under the deed dated 5.2.91 (see doc). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 10. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 and all other moneys due or to become due from the co. To the chargee under the terms of the acquisition agreement d/d 27/7/89 | |
Kurze Angaben All stock in trade of the company both present and future. (Please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H piece of land having a frontage to west side of clausentum road, southampton. Proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 42, elizabeth street, blackpool, lancashire. T/n la 439910 proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2, heigham street, city of norwich. T/n wk 14689. proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 66 the fairway, leamington spa, warwickshire. T/n wk 313339. proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H westbridge road, launceston, cornwall. Proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 32A, lower cathedral rd, riverside, cardiff. T/n wa 1623 proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 & 3 fairhurst, blackpool, lancashire. T/n la 439922 proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H treruffe hill redruth cornwall. Proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property in stewart st. Wolverhampton t/n sf 46633 proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat AEW LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Administrativer Receiver bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0