BROAD OAK TOILETRIES LIMITED

BROAD OAK TOILETRIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBROAD OAK TOILETRIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01971053
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BROAD OAK TOILETRIES LIMITED?

    • Herstellung von Parfüms und Toilettenzubereitungen (20420) / Verarbeitendes Gewerbe
    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich BROAD OAK TOILETRIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BDO LLP
    Finzels Reach
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BROAD OAK TOILETRIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROAK OAK TOILETRIES LIMITED24. Juli 198924. Juli 1989
    BROAD OAK SOAP COMPANY LIMITED13. Dez. 198513. Dez. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BROAD OAK TOILETRIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für BROAD OAK TOILETRIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    27 SeitenAM10

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    27 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    24 SeitenAM10

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11

    Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    12 SeitenAM16

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    23 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    21 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Nov. 2016

    24 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Aug. 2016

    31 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    72 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    66 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    24 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tiverton Way Tiverton Business Park Tiverton Devon EX16 6TG zum C/O Bdo Llp Finzels Reach Counterslip Bristol Bristol BS1 6BX am 19. Feb. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 18. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 505,127
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Tiverton Way Tiverton Business Park Tiverton Devon EX16 6TG verlegt

    1 SeitenAD04

    Beendigung der Bestellung von Mark Ashley Goodden als Sekretär am 01. Dez. 2015

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Philip Kenneth Charles Marsh als Geschäftsführer am 01. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2015

    23 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 019710530007, erstellt am 24. Feb. 2015

    16 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 019710530006 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 17. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 505,127
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von BROAD OAK TOILETRIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BODENHAM, Edward John
    c/o Bdo Llp
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Finzels Reach
    Bristol
    Geschäftsführer
    c/o Bdo Llp
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Finzels Reach
    Bristol
    EnglandBritishDirector182200230001
    BODENHAM, John Hugh
    c/o Bdo Llp
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Finzels Reach
    Bristol
    Geschäftsführer
    c/o Bdo Llp
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Finzels Reach
    Bristol
    United KingdomBritishPerfumier70736020002
    BOTSARIS, Emily Clare
    c/o Bdo Llp
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Finzels Reach
    Bristol
    Geschäftsführer
    c/o Bdo Llp
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Finzels Reach
    Bristol
    EnglandBritishDirector182200240001
    BROWN, Robert Adam Southall
    c/o Bdo Llp
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Finzels Reach
    Bristol
    Geschäftsführer
    c/o Bdo Llp
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Finzels Reach
    Bristol
    EnglandBritishDirector185661250001
    BODENHAM, John Hugh
    Spurfold House
    Radnor Road, Peaslake
    GU5 9SZ Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Spurfold House
    Radnor Road, Peaslake
    GU5 9SZ Guildford
    Surrey
    British70736020001
    GOODDEN, Mark Ashley
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    Sekretär
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    British99002590002
    BODENHAM, Patrick Michael
    25 Bay Tree Close
    TN21 8YG Heathfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    25 Bay Tree Close
    TN21 8YG Heathfield
    East Sussex
    BritishDirector53488570001
    COLLINS, Adrian James
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    Geschäftsführer
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    United KingdomBritishSite Director175839750001
    COSTER, John
    2 Kentismore Cottages
    Kentisbeare
    EX15 2BS Cullompton
    Devon
    Geschäftsführer
    2 Kentismore Cottages
    Kentisbeare
    EX15 2BS Cullompton
    Devon
    BritishTechnical Director14182750001
    MARSH, Andrew
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    Geschäftsführer
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    EnglandBritishExecutive14182720002
    MARSH, Christopher Robert
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    Geschäftsführer
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    EnglandBritishPerfumier14109030001
    MARSH, Philip Kenneth Charles
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    Geschäftsführer
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    EnglandBritishManaging Director154375560001
    MAYNARD, Robin Roy
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    Geschäftsführer
    Tiverton Way
    Tiverton Business Park
    Tiverton
    Devon Ex16 6tg
    EnglandBritishProduction Director14182730004
    STEVENS, Mark Alexander
    32 Leonard Avenue
    Otford
    TN14 5RB Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    32 Leonard Avenue
    Otford
    TN14 5RB Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant50139790001
    TOMS, Alan Adrian
    7 Hatchlands
    Lemmington Way
    RH12 5JX Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    7 Hatchlands
    Lemmington Way
    RH12 5JX Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant99064850001
    WINDETT, Peter
    50 Lansdowne Road
    W11 2LR London
    Geschäftsführer
    50 Lansdowne Road
    W11 2LR London
    United KingdomBritishDesigner4602310002

    Hat BROAD OAK TOILETRIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 24. Feb. 2015
    Geliefert am 28. Feb. 2015
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 14. Feb. 2014
    Geliefert am 17. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Each relevant company with full title guarantee charges to the security trustee, by way of first legal mortgage, each of the properties known as 88-90 jermyn street, london, SW1Y 6JH; unit 3 woodlands business park, burlescombe, tiverton, devon, EX16 7LL; 101 tierney road, streatham, london, SW2 4QH; 5 tiverton way, tiverton business park, tiverton, devon, EX16 6TG; and comprising title numbers 148456, LN213630, LN220504, DN431975, LN196520, and DN420368.. Each company with full title guarantee charges to the security trustee by way of fixed charge; all properties acquired by that company in the future; all present and future interests of that company not effectively mortgaged or charged under the preceding provisions, in, or over, freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to each property; all licences, consents and authorisations (statutory or otherwise) held or required in connection with the company's business or the use of any secured asset (as defined in the debenture), and all rights in connection with them; and all intellectual property.. "Company" means each of floris of london holdings limited; j floris limited; floris estates limited; broad oak toiletries limited; jf 2009 limited; fe 2009 limited; bot 2009 limited.. "Intellectual property" means a company's present and future patents, trade marks, service marks, trade names, designs, copyrights, inventions, topographical or similar rights, confidential information and know-how and any interest in any of these rights, whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration and all fees, royalties and other rights derived from, or incidental to, these rights.. "Properties" means all freehold and leasehold properties (whether registered or unregistered) and all commonhold properties, now or in the future (and from time to time) owned by a company, or in which a company holds an interest, (including, but not limited to, the properties comprising of the title numbers detailed above), and property means any of them.. "Secured assets" means all the assets, the properties and undertaking for the time being subject to the security created by, or pursuant to, the debenture.. "Secured liabilities" all present and future monies, obligations and liabilities owed by each company to any or all of the noteholders (as defined in the debenture) and/or the security trustee, whether actual or contingent and whether owed jointly or severally, as principal or surety and/or in any other capacity, under or in connection with the loan note instrument (as defined in the debenture) or the debenture, together with all interest (including, without limitation, default interest) accruing in respect of those monies or liabilities.. For further information please refer to the debenture.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Christopher Marsh as Security Trustee
    Transaktionen
    • 17. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 21. Mai 2013
    Geliefert am 23. Mai 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juli 1998
    Geliefert am 14. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Okt. 1992
    Geliefert am 31. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property being land and buildings lying to the south of lowman way tiverton together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property; and the benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 13. Juni 1991
    Geliefert am 17. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    One new evrard E22 pleat wrapper serial no. 672/91.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 17. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 11. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 01. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 20. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BROAD OAK TOILETRIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Feb. 2016Beginn der Verwaltung
    16. Okt. 2018Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Danny Dartnaill
    Thames Tower Level 12 Station Road
    RG1 1LX Reading
    Berkshire
    Praktiker
    Thames Tower Level 12 Station Road
    RG1 1LX Reading
    Berkshire
    Simon Edward Jex Girling
    Bdo Llp Bridgewater House Finzels Reach
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Avon
    Praktiker
    Bdo Llp Bridgewater House Finzels Reach
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Avon
    James Joseph Bannon
    5th Floor Bridgewater House
    Finzels Reach
    BS1 6BX Counterslip
    Bristol
    Praktiker
    5th Floor Bridgewater House
    Finzels Reach
    BS1 6BX Counterslip
    Bristol

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0