GREENLINE CARRIERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREENLINE CARRIERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01973783
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREENLINE CARRIERS LIMITED?

    • Güterkraftverkehr (49410) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich GREENLINE CARRIERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 291 & 296 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GREENLINE CARRIERS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GREEN LINE CARRIERS LIMITED25. Feb. 198625. Feb. 1986
    FIDARON LIMITED24. Dez. 198524. Dez. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREENLINE CARRIERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREENLINE CARRIERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Nov. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 25. Mai 2012

    • Kapital: GBP 694,100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Peter Louden als Geschäftsführer am 13. März 2012

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Crestwood House Birches Rise Willenhall West Midlands WV13 2DB am 11. Apr. 2012

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Louden am 07. Dez. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Louden am 26. Nov. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2009

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Bernard Burns als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Peter Louden als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Ian David Horsfall am 01. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Bernard Kenneth Robbie Burns am 01. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ian David Horsfall am 01. Mai 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von GREENLINE CARRIERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HORSFALL, Ian David
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Sekretär
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    BritishFinance Director104565220001
    HORSFALL, Ian David
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    EnglandBritishFinance Director104565220001
    BOWD, Andre Paul
    170 Heanor Road
    Smalley
    DE7 6DY Ilkeston
    Derbyshire
    Sekretär
    170 Heanor Road
    Smalley
    DE7 6DY Ilkeston
    Derbyshire
    British34016480001
    DICKINSON, George
    23 Helmshore Road
    Haslingden
    BB4 4BN Rossendale
    Lancashire
    Sekretär
    23 Helmshore Road
    Haslingden
    BB4 4BN Rossendale
    Lancashire
    British2755810001
    GWILLIAM, Stephen Paul
    5 Andover Crescent
    DY6 8PH Kingswinford
    West Midlands
    Sekretär
    5 Andover Crescent
    DY6 8PH Kingswinford
    West Midlands
    British93396970001
    JACKSON, Paul
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    BritishAccountant40294740001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Sekretär
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director35522270001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Sekretär
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director35522270001
    BLACK, David Russell
    18 College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    18 College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    BritishCompany Director2755270005
    BOWD, Andre Paul
    170 Heanor Road
    Smalley
    DE7 6DY Ilkeston
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    170 Heanor Road
    Smalley
    DE7 6DY Ilkeston
    Derbyshire
    United KingdomBritishCompany Director34016480001
    BURNS, Bernard Kenneth Robbie
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    EnglandBritishDirector239557120001
    DICKINSON, George
    23 Helmshore Road
    Haslingden
    BB4 4BN Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    23 Helmshore Road
    Haslingden
    BB4 4BN Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director2755810001
    DICKINSON, John Richard
    Rawsthorne Avenue
    Haslingden
    BB4 4BN Rossendale
    25
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Rawsthorne Avenue
    Haslingden
    BB4 4BN Rossendale
    25
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director35711670001
    DICKINSON, Peggy
    23 Helmshore Road
    Haslingden
    BB4 4BG Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    23 Helmshore Road
    Haslingden
    BB4 4BG Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director13796500001
    DUNN, Lloyd John Charles
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector105512500001
    JACKSON, Paul
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishAccountant40294740001
    KELLY, Robert David Lindsay
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandWelshDirector161123860001
    LOUDEN, Peter
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector172376370001
    POTTER, Ian Roger
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant63766210003
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director22018030002
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director35522270001
    TYSON, Paul Louis
    57 Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    57 Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DA Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishSales Director23566060001

    Hat GREENLINE CARRIERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed to the third guarantee and debenture (the "debenture") dated 20 june 2001 made between greenline carriers limited and the governor and company of the bank of scotland
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 02. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    As set out in the assignment dated 03 july 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    As set out in the 395 registered on 3 july 2001 in relation to the debenture.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to the second guarantee and debenture (the "debenture") dated 05 march 2001 made between greenline carriers limited and the governor and company of the bank of scotland
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 02. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    As set out in the assignment dated 13 march 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    As set out in the 395 registered on 13 march 2001 in relation to the debenture.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2001
    Geliefert am 03. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred by the company (the "chargor") to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined therein) to which it is expressed to be a party; and each other company to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) (as therein defined) (except as a guarantor for the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Geliefert am 13. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for the benficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and each other company (as defined) (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever and all monies and liabilities owing or incurred to each beneficiary by the compan under or pursuant to the mezzanine finance documents (as defined) and each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Aug. 1997
    Geliefert am 27. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. März 1990
    Geliefert am 05. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 19. Feb. 1990
    Geliefert am 22. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    Fixed charge
    Erstellt am 15. Mai 1989
    Geliefert am 24. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £90,000.00 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    A first fixed charge over commercial vehicles more particularly described in the schedule to form 395 (please see doc for details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 24. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 21. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 15. Mai 1989
    Geliefert am 22. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 10. Aug. 1988
    Geliefert am 23. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures including trade fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 06. Jan. 1988
    Geliefert am 08. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over 4 erf 'c' series tractor units reg no chassis no engine no A130 grf 48301 8LXCT231331 A128 grf 48283 8LXCT 231332 evt 698Y 48223 8LXCT 231277 evt 699Y 48229 8LXCT 231226.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 21. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GREENLINE CARRIERS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2012Beginn der Liquidation
    06. Mai 2013Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0