GREENLINE CARRIERS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GREENLINE CARRIERS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01973783 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GREENLINE CARRIERS LIMITED?
- Güterkraftverkehr (49410) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich GREENLINE CARRIERS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 291 & 296 Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Worcestershire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GREENLINE CARRIERS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GREEN LINE CARRIERS LIMITED | 25. Feb. 1986 | 25. Feb. 1986 |
FIDARON LIMITED | 24. Dez. 1985 | 24. Dez. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREENLINE CARRIERS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GREENLINE CARRIERS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Louden als Geschäftsführer am 13. März 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Crestwood House Birches Rise Willenhall West Midlands WV13 2DB am 11. Apr. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Louden am 07. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Louden am 26. Nov. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bernard Burns als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter Louden als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian David Horsfall am 01. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Bernard Kenneth Robbie Burns am 01. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ian David Horsfall am 01. Mai 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von GREENLINE CARRIERS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORSFALL, Ian David | Sekretär | Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Unit 291 & 296 Worcestershire | British | Finance Director | 104565220001 | |||||
HORSFALL, Ian David | Geschäftsführer | Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Unit 291 & 296 Worcestershire | England | British | Finance Director | 104565220001 | ||||
BOWD, Andre Paul | Sekretär | 170 Heanor Road Smalley DE7 6DY Ilkeston Derbyshire | British | 34016480001 | ||||||
DICKINSON, George | Sekretär | 23 Helmshore Road Haslingden BB4 4BN Rossendale Lancashire | British | 2755810001 | ||||||
GWILLIAM, Stephen Paul | Sekretär | 5 Andover Crescent DY6 8PH Kingswinford West Midlands | British | 93396970001 | ||||||
JACKSON, Paul | Sekretär | 14 Redmain Way West Derby L12 0LU Liverpool Merseyside | British | Accountant | 40294740001 | |||||
RUSSELL, Craig | Sekretär | Windrush 2 Firdene Crescent CH43 9TN Birkenhead Merseyside | British | Company Director | 35522270001 | |||||
RUSSELL, Craig | Sekretär | Windrush 2 Firdene Crescent CH43 9TN Birkenhead Merseyside | British | Company Director | 35522270001 | |||||
BLACK, David Russell | Geschäftsführer | 18 College Road WR14 3DD Malvern Worcestershire | British | Company Director | 2755270005 | |||||
BOWD, Andre Paul | Geschäftsführer | 170 Heanor Road Smalley DE7 6DY Ilkeston Derbyshire | United Kingdom | British | Company Director | 34016480001 | ||||
BURNS, Bernard Kenneth Robbie | Geschäftsführer | Crestwood House Birches Rise WV13 2DB Willenhall West Midlands | England | British | Director | 239557120001 | ||||
DICKINSON, George | Geschäftsführer | 23 Helmshore Road Haslingden BB4 4BN Rossendale Lancashire | British | Company Director | 2755810001 | |||||
DICKINSON, John Richard | Geschäftsführer | Rawsthorne Avenue Haslingden BB4 4BN Rossendale 25 Lancashire | England | British | Company Director | 35711670001 | ||||
DICKINSON, Peggy | Geschäftsführer | 23 Helmshore Road Haslingden BB4 4BG Rossendale Lancashire | British | Company Director | 13796500001 | |||||
DUNN, Lloyd John Charles | Geschäftsführer | Goodison 38 Mill Lane Barrow Upon Soar LE12 8LH Loughborough Leicestershire | England | British | Director | 105512500001 | ||||
JACKSON, Paul | Geschäftsführer | 14 Redmain Way West Derby L12 0LU Liverpool Merseyside | England | British | Accountant | 40294740001 | ||||
KELLY, Robert David Lindsay | Geschäftsführer | Glanville House Alcester Road Wooton Wawen B95 6BQ Henley In Arden Warwickshire | England | Welsh | Director | 161123860001 | ||||
LOUDEN, Peter | Geschäftsführer | Hartlebury Trading Estate DY10 4JB Hartlebury Unit 291 & 296 Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 172376370001 | ||||
POTTER, Ian Roger | Geschäftsführer | 17 Victoria Mill Drive Willaston CW5 6RR Nantwich Cheshire | England | British | Accountant | 63766210003 | ||||
REDBURN, Timothy John | Geschäftsführer | Little Abbotts Snower Hill Road RH3 7AQ Betchworth Surrey | England | British | Company Director | 22018030002 | ||||
RUSSELL, Craig | Geschäftsführer | Windrush 2 Firdene Crescent CH43 9TN Birkenhead Merseyside | British | Company Director | 35522270001 | |||||
TYSON, Paul Louis | Geschäftsführer | 57 Lawton Road Alsager ST7 2DA Stoke On Trent Staffordshire | British | Sales Director | 23566060001 |
Hat GREENLINE CARRIERS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed to the third guarantee and debenture (the "debenture") dated 20 june 2001 made between greenline carriers limited and the governor and company of the bank of scotland | Erstellt am 19. Dez. 2001 Geliefert am 02. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag As set out in the assignment dated 03 july 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein) | |
Kurze Angaben As set out in the 395 registered on 3 july 2001 in relation to the debenture. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed to the second guarantee and debenture (the "debenture") dated 05 march 2001 made between greenline carriers limited and the governor and company of the bank of scotland | Erstellt am 19. Dez. 2001 Geliefert am 02. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag As set out in the assignment dated 13 march 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein) | |
Kurze Angaben As set out in the 395 registered on 13 march 2001 in relation to the debenture. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Juni 2001 Geliefert am 03. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred by the company (the "chargor") to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined therein) to which it is expressed to be a party; and each other company to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) (as therein defined) (except as a guarantor for the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 05. März 2001 Geliefert am 13. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for the benficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and each other company (as defined) (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever and all monies and liabilities owing or incurred to each beneficiary by the compan under or pursuant to the mezzanine finance documents (as defined) and each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the mezzanine finance documents on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Aug. 1997 Geliefert am 27. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. März 1990 Geliefert am 05. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 19. Feb. 1990 Geliefert am 22. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 15. Mai 1989 Geliefert am 24. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £90,000.00 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge | |
Kurze Angaben A first fixed charge over commercial vehicles more particularly described in the schedule to form 395 (please see doc for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 15. Mai 1989 Geliefert am 22. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Aug. 1988 Geliefert am 23. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures including trade fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Jan. 1988 Geliefert am 08. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge over 4 erf 'c' series tractor units reg no chassis no engine no A130 grf 48301 8LXCT231331 A128 grf 48283 8LXCT 231332 evt 698Y 48223 8LXCT 231277 evt 699Y 48229 8LXCT 231226. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat GREENLINE CARRIERS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0