CULINA AMBIENT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CULINA AMBIENT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01974240 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CULINA AMBIENT LIMITED?
- Betrieb von Lager- und Umschlagsanlagen für den Landverkehr (52103) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich CULINA AMBIENT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o CULINA GROUP LIMITED Culina Logistics Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Shropshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CULINA AMBIENT LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CULINA AMBIENT PLC | 24. Juli 2012 | 24. Juli 2012 |
CERT OCTAVIAN PLC | 25. Okt. 2007 | 25. Okt. 2007 |
CERT GROUP OF COMPANIES PLC | 02. Juli 1997 | 02. Juli 1997 |
CERT PLC | 10. Aug. 1989 | 10. Aug. 1989 |
CERT SERVICES GROUP PLC | 01. Dez. 1986 | 01. Dez. 1986 |
R.B. SERIES SIXTY LIMITED | 30. Dez. 1985 | 30. Dez. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CULINA AMBIENT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CULINA AMBIENT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Juli 2020
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 138 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 138 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 28 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 25 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 24 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Steven James Winwood als Direktor am 24. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Christian Lee Price als Direktor am 24. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CULINA AMBIENT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JURY, Nigel Stephen | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Logistics Limited Shropshire United Kingdom | 186262340001 | |||||||
JURY, Nigel Stephen | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Logistics Limited Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 169320190001 | ||||
PRICE, Christian Lee | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Logistics Limited Shropshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205439820001 | ||||
VAN MOURIK, Thomas | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Logistics Limited Shropshire United Kingdom | England | Dutch | Businessman | 108562780001 | ||||
WINWOOD, Steven James | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Logistics Limited Shropshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 149351750001 | ||||
JURY, Nigel Stephen | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Logistics Limited Shropshire United Kingdom | 169306850001 | |||||||
NAYLOR, Michael Thomas Arthur | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Logistics Limited Shropshire United Kingdom | 176032210001 | |||||||
O'BRIEN, Vincent | Sekretär | Haslemere Avenue EN4 8EY Barnet 17 Hertfordshire United Kingdom | Irish | Accountant | 138590150001 | |||||
TAYLOR, Gregory Robert | Sekretär | 37 Clifford Road EN5 5PD New Barnet Hertfordshire | British | Accountant | 38832300001 | |||||
RB SECRETARIAT LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006270001 | |||||||
ABEL, Laurence Donal | Geschäftsführer | 1 Kingfisher Grove Swallownest S26 4SH Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 123023600001 | ||||
BYRNE, John Peter | Geschäftsführer | La Corbiere High Road Fobbing SS17 9HT Stanford Le Hope Essex | British | Company Director | 27391810001 | |||||
DANIEL, Stephen Charles | Geschäftsführer | The Byre House Great Fowle Hall Darman Lane TN12 6PW Paddock Wood Kent | British | Company Director | 43976670001 | |||||
EVANS, Darrell Leigh | Geschäftsführer | 248 Kentish Town Road NW5 2AB London | British | Company Director | 11743950001 | |||||
FINLAYSON-GREEN, Anthony Raymond | Geschäftsführer | 141 Three Bridges Road Three Bridges RH10 1JT Crawley Woodcroft West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 128136310001 | ||||
FORD, John Charles | Geschäftsführer | 33 Egerton Gardens Ealing W13 8HG London | England | British | Information Technology | 46300750002 | ||||
GIBSON, Graham | Geschäftsführer | 117b Stagsden Road MK43 8QL Bromham Bedfordshire | British | Director | 125029420001 | |||||
GORDON, Stuart Linton | Geschäftsführer | 62 Park Head Road S11 9RB Sheffield South Yorkshire | England | British | Company Director | 155580001 | ||||
GREER, Laurence Arthur | Geschäftsführer | Cert Octavian House St Martins Road EN11 0BT Hoddesdon Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 16797530001 | ||||
JAGGER, Nigel Mark | Geschäftsführer | Maison De Bas Rue Degypte Trinity Jersey Channel Islands | Channel Islands | British | Company Director | 202830830001 | ||||
LAINAS, Michael Constantine | Geschäftsführer | Seeleys Farmhouse Seeleys Road HP9 1TW Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 15284390002 | ||||
MURRAY, Carl Peter | Geschäftsführer | 71 Wellington Street Bengeo SG14 3AN Hertford Hertfordshire | British | Customer Services | 30721740003 | |||||
NAYLOR, Arthur Thomas Michael | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Logistics Limited Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 169270540001 | ||||
O'BRIEN, Vincent | Geschäftsführer | Haslemere Avenue EN4 8EY Barnet 17 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | Accountant | 138590150001 | ||||
RENNIE, Barry | Geschäftsführer | Inglewood 36 Hulmes Road Failsworth M35 0PL Manchester Lancashire | British | Company Director | 1030100001 | |||||
REYNOLDS, Keith Carrington | Geschäftsführer | 6a Downwood Close SP6 1EA Fordingbridge Hampshire | British | Director | 121267680001 | |||||
SELBY, Stephen Paul | Geschäftsführer | The Barbary New Road Wood Walton PE28 5YT Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | Director | 123023720001 | ||||
SPIBEY, George Arthur | Geschäftsführer | 5 Spicers Close Claverley WV5 7BY Wolverhampton West Midlands | British | Company Director | 16797520001 | |||||
STANTON, Jeffrey | Geschäftsführer | 9 Brownswood Road HP9 2NU Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 41676230001 | ||||
TAYLOR, Gregory Robert | Geschäftsführer | 37 Clifford Road EN5 5PD New Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 38832300001 | ||||
THOMPSON, Jack | Geschäftsführer | 111 Queens Road SG13 8BJ Hertford Hertfordshire | British | Company Director | 3998970001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CULINA AMBIENT LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culina Group Limited | 06. Apr. 2016 | Shrewsbury Road TF9 3SQ Market Drayton Tern Valley Business Park Shropshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CULINA AMBIENT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 03. Feb. 2014 Geliefert am 03. Feb. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal assignment | Erstellt am 18. Aug. 2011 Geliefert am 19. Aug. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge on non-vesting debts and floating charge | Erstellt am 17. Juni 2011 Geliefert am 21. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Juni 2011 Geliefert am 17. Juni 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 09. Juni 2011 Geliefert am 25. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben No 2 sub depot eastlays gastard corsham t/no WT111303 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 15. Juni 2009 Geliefert am 16. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £290,000 credited to account designation number 60867604 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Jan. 2009 Geliefert am 22. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All assets of the company by way of fixed and floating charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Juli 1999 Geliefert am 03. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H vaults & warehouse situate at gastard corsham wiltshire-WT111303. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 07. Nov. 1997 Geliefert am 13. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date | |
Kurze Angaben The sum of £250,000 at national westminster bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 01. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Feb. 1992 Geliefert am 28. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Please see doc 395 tc ref M246C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Credit agreement | Erstellt am 16. Mai 1991 Geliefert am 29. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £196655-80 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All right, title and interest in and to all sums payable under the insurance. See form 895 (ref 92) for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Confirmatory charge | Erstellt am 24. Okt. 1989 Geliefert am 03. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 21/8/86 on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & property at the south east of charltonmead lane hoddesdon hertfordshire t/no hd 165312 as charged by legal charge dated 21/8/86 and or proceeds o f sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Confirmatory charge | Erstellt am 24. Okt. 1989 Geliefert am 03. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 2/6/86 on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property and assets as charged by mortgage debenture of 2/6/86. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 25. Aug. 1987 Geliefert am 01. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a premises and land at chaseways sawbridgeworth herts and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 21. Aug. 1986 Geliefert am 09. Sept. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings to the south east of charltonmead lane, hoddesdon hertfordshire t/n - hd 165312. and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 02. Juni 1986 Geliefert am 13. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & the benefit of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0