CULINA AMBIENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCULINA AMBIENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01974240
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CULINA AMBIENT LIMITED?

    • Betrieb von Lager- und Umschlagsanlagen für den Landverkehr (52103) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich CULINA AMBIENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o CULINA GROUP LIMITED
    Culina Logistics Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Shropshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CULINA AMBIENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CULINA AMBIENT PLC24. Juli 201224. Juli 2012
    CERT OCTAVIAN PLC25. Okt. 200725. Okt. 2007
    CERT GROUP OF COMPANIES PLC02. Juli 199702. Juli 1997
    CERT PLC10. Aug. 198910. Aug. 1989
    CERT SERVICES GROUP PLC01. Dez. 198601. Dez. 1986
    R.B. SERIES SIXTY LIMITED30. Dez. 198530. Dez. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CULINA AMBIENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für CULINA AMBIENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 17. Juli 2020

    • Kapital: GBP 0.01
    5 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share prem a/c 01/07/2020
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    19 SeitenAA

    legacy

    138 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    138 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    28 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    25 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    24 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Steven James Winwood als Direktor am 24. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Christian Lee Price als Direktor am 24. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CULINA AMBIENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JURY, Nigel Stephen
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    186262340001
    JURY, Nigel Stephen
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant169320190001
    PRICE, Christian Lee
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United KingdomBritishChartered Accountant205439820001
    VAN MOURIK, Thomas
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandDutchBusinessman108562780001
    WINWOOD, Steven James
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United KingdomBritishChartered Accountant149351750001
    JURY, Nigel Stephen
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    169306850001
    NAYLOR, Michael Thomas Arthur
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    176032210001
    O'BRIEN, Vincent
    Haslemere Avenue
    EN4 8EY Barnet
    17
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Haslemere Avenue
    EN4 8EY Barnet
    17
    Hertfordshire
    United Kingdom
    IrishAccountant138590150001
    TAYLOR, Gregory Robert
    37 Clifford Road
    EN5 5PD New Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    37 Clifford Road
    EN5 5PD New Barnet
    Hertfordshire
    BritishAccountant38832300001
    RB SECRETARIAT LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006270001
    ABEL, Laurence Donal
    1 Kingfisher Grove
    Swallownest
    S26 4SH Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Kingfisher Grove
    Swallownest
    S26 4SH Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector123023600001
    BYRNE, John Peter
    La Corbiere High Road
    Fobbing
    SS17 9HT Stanford Le Hope
    Essex
    Geschäftsführer
    La Corbiere High Road
    Fobbing
    SS17 9HT Stanford Le Hope
    Essex
    BritishCompany Director27391810001
    DANIEL, Stephen Charles
    The Byre House Great Fowle Hall
    Darman Lane
    TN12 6PW Paddock Wood
    Kent
    Geschäftsführer
    The Byre House Great Fowle Hall
    Darman Lane
    TN12 6PW Paddock Wood
    Kent
    BritishCompany Director43976670001
    EVANS, Darrell Leigh
    248 Kentish Town Road
    NW5 2AB London
    Geschäftsführer
    248 Kentish Town Road
    NW5 2AB London
    BritishCompany Director11743950001
    FINLAYSON-GREEN, Anthony Raymond
    141 Three Bridges Road
    Three Bridges
    RH10 1JT Crawley
    Woodcroft
    West Sussex
    Geschäftsführer
    141 Three Bridges Road
    Three Bridges
    RH10 1JT Crawley
    Woodcroft
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director128136310001
    FORD, John Charles
    33 Egerton Gardens
    Ealing
    W13 8HG London
    Geschäftsführer
    33 Egerton Gardens
    Ealing
    W13 8HG London
    EnglandBritishInformation Technology46300750002
    GIBSON, Graham
    117b Stagsden Road
    MK43 8QL Bromham
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    117b Stagsden Road
    MK43 8QL Bromham
    Bedfordshire
    BritishDirector125029420001
    GORDON, Stuart Linton
    62 Park Head Road
    S11 9RB Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    62 Park Head Road
    S11 9RB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director155580001
    GREER, Laurence Arthur
    Cert Octavian House
    St Martins Road
    EN11 0BT Hoddesdon
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Cert Octavian House
    St Martins Road
    EN11 0BT Hoddesdon
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector16797530001
    JAGGER, Nigel Mark
    Maison De Bas
    Rue Degypte Trinity
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Maison De Bas
    Rue Degypte Trinity
    Jersey
    Channel Islands
    Channel IslandsBritishCompany Director202830830001
    LAINAS, Michael Constantine
    Seeleys Farmhouse
    Seeleys Road
    HP9 1TW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Seeleys Farmhouse
    Seeleys Road
    HP9 1TW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director15284390002
    MURRAY, Carl Peter
    71 Wellington Street
    Bengeo
    SG14 3AN Hertford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    71 Wellington Street
    Bengeo
    SG14 3AN Hertford
    Hertfordshire
    BritishCustomer Services30721740003
    NAYLOR, Arthur Thomas Michael
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Logistics Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant169270540001
    O'BRIEN, Vincent
    Haslemere Avenue
    EN4 8EY Barnet
    17
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Haslemere Avenue
    EN4 8EY Barnet
    17
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishAccountant138590150001
    RENNIE, Barry
    Inglewood 36 Hulmes Road
    Failsworth
    M35 0PL Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Inglewood 36 Hulmes Road
    Failsworth
    M35 0PL Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Director1030100001
    REYNOLDS, Keith Carrington
    6a Downwood Close
    SP6 1EA Fordingbridge
    Hampshire
    Geschäftsführer
    6a Downwood Close
    SP6 1EA Fordingbridge
    Hampshire
    BritishDirector121267680001
    SELBY, Stephen Paul
    The Barbary
    New Road Wood Walton
    PE28 5YT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    The Barbary
    New Road Wood Walton
    PE28 5YT Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishDirector123023720001
    SPIBEY, George Arthur
    5 Spicers Close
    Claverley
    WV5 7BY Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    5 Spicers Close
    Claverley
    WV5 7BY Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director16797520001
    STANTON, Jeffrey
    9 Brownswood Road
    HP9 2NU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    9 Brownswood Road
    HP9 2NU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector41676230001
    TAYLOR, Gregory Robert
    37 Clifford Road
    EN5 5PD New Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    37 Clifford Road
    EN5 5PD New Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant38832300001
    THOMPSON, Jack
    111 Queens Road
    SG13 8BJ Hertford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    111 Queens Road
    SG13 8BJ Hertford
    Hertfordshire
    BritishCompany Director3998970001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CULINA AMBIENT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Culina Group Limited
    Shrewsbury Road
    TF9 3SQ Market Drayton
    Tern Valley Business Park
    Shropshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Shrewsbury Road
    TF9 3SQ Market Drayton
    Tern Valley Business Park
    Shropshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer5525931
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat CULINA AMBIENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 03. Feb. 2014
    Geliefert am 03. Feb. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal assignment
    Erstellt am 18. Aug. 2011
    Geliefert am 19. Aug. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Erstellt am 17. Juni 2011
    Geliefert am 21. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transaktionen
    • 21. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Juni 2011
    Geliefert am 17. Juni 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Juni 2011
    Geliefert am 25. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    No 2 sub depot eastlays gastard corsham t/no WT111303 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge of deposit
    Erstellt am 15. Juni 2009
    Geliefert am 16. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit initially of £290,000 credited to account designation number 60867604 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2009
    Geliefert am 22. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All assets of the company by way of fixed and floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Juli 1999
    Geliefert am 03. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H vaults & warehouse situate at gastard corsham wiltshire-WT111303. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 07. Nov. 1997
    Geliefert am 13. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Kurze Angaben
    The sum of £250,000 at national westminster bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • Brixton Estate PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Nov. 1995
    Geliefert am 01. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 28. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Please see doc 395 tc ref M246C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 16. Mai 1991
    Geliefert am 29. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £196655-80 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in and to all sums payable under the insurance. See form 895 (ref 92) for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 29. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 08. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Confirmatory charge
    Erstellt am 24. Okt. 1989
    Geliefert am 03. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 21/8/86 on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & property at the south east of charltonmead lane hoddesdon hertfordshire t/no hd 165312 as charged by legal charge dated 21/8/86 and or proceeds o f sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    Confirmatory charge
    Erstellt am 24. Okt. 1989
    Geliefert am 03. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 2/6/86 on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property and assets as charged by mortgage debenture of 2/6/86.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Aug. 1987
    Geliefert am 01. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a premises and land at chaseways sawbridgeworth herts and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Aug. 1986
    Geliefert am 09. Sept. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings to the south east of charltonmead lane, hoddesdon hertfordshire t/n - hd 165312. and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1986Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 02. Juni 1986
    Geliefert am 13. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 1986Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0