COOLING POWER INDUSTRIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COOLING POWER INDUSTRIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01976333 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COOLING POWER INDUSTRIES LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich COOLING POWER INDUSTRIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Freeman Road North Hykeham Lincoln Ln6 9ap |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COOLING POWER INDUSTRIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COOLING POWER INDUSTRIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Nov. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Evans als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Northover als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Northover am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael Evans am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian Christopher Sheriff am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COOLING POWER INDUSTRIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONTA, Walter | Sekretär | Via Tiepolo 12/B 31057 Silea Tv Italy | Italian | 118517690001 | ||||||
| BERTI, Gino | Geschäftsführer | Via G Puccini 28 S.Dona'Di Piave Ve 30024 Italy | Italy | Italian | 120293780001 | |||||
| SHERIFF, Ian Christopher | Geschäftsführer | Owmby Road Spridlington LN8 2DD Market Rasen Birnam Lincolnshire England | England | British | 124327040001 | |||||
| ZONTA, Walter | Geschäftsführer | Via Tiepolo 12/B 31057 Silea Tv Italy | Italy | Italian | 118517690001 | |||||
| BARKER, Philip Dennison | Sekretär | 7 Brecks Gardens Kippax LS25 7LP Leeds | British | 40070580001 | ||||||
| FERGUSON, Andrew | Sekretär | 2 Fitzwalter Road CM6 3FH Little Dunmow Essex | British | 174600320001 | ||||||
| REDMOND, Paul | Sekretär | 32 Curle Avenue LN2 4AN Lincoln Lincolnshire | British | 6100890001 | ||||||
| BARKER, Philip Dennison | Geschäftsführer | 7 Brecks Gardens Kippax LS25 7LP Leeds | United Kingdom | British | 40070580001 | |||||
| BEASANT, Norman Charles Aubrey | Geschäftsführer | 8 Welby Gardens NG31 8BN Grantham Lincolnshire | British | 39224910003 | ||||||
| BEECH, John Leonard | Geschäftsführer | 4 Lincoln Road North Hykeham LN6 8HE Lincoln Lincolnshire | British | 25424060001 | ||||||
| BURNET, Alex James | Geschäftsführer | 33 The Moorings Burton Waters LN1 2WQ Lincoln | British | 66176050003 | ||||||
| BUSH, Martin | Geschäftsführer | 36 Stamford Avenue Styvechale CV3 5BX Coventry West Midlands | British | 6698370001 | ||||||
| EVANS, Michael | Geschäftsführer | 3/4 Church Lane Harpswell DN21 5UY Gainsborough Lincolnshire | England | British | 75039430001 | |||||
| GOODCHILD, Michael Patrick | Geschäftsführer | 35 Norwood Park HD2 2DU Huddersfield West Yorkshire | British | 37816520002 | ||||||
| MCBRIDE, Ralph Douglas | Geschäftsführer | 9 The Pinfold Thulston DE72 3FD Derby | United Kingdom | British | 25291190001 | |||||
| NORTHOVER, Paul | Geschäftsführer | The Little Grange Park Lane Heighington LN4 1RF Lincoln Lincolnshire | England | British | 85513660001 | |||||
| REDMOND, Paul | Geschäftsführer | 32 Curle Avenue LN2 4AN Lincoln Lincolnshire | British | 6100890001 | ||||||
| WATSON, John | Geschäftsführer | 67 Albion Crescent LN1 1EB Lincoln Lincolnshire | British | 6100900001 | ||||||
| WHYLES, Donald Arthur | Geschäftsführer | The Manor House Burton LN1 2RD Lincoln Lincs | United Kingdom | British | 3830230001 | |||||
| WRIGHT, David John | Geschäftsführer | 1 Sandra Crescent Washingborough LN4 1QZ Lincoln | British | 47255760001 |
Hat COOLING POWER INDUSTRIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Nov. 1997 Geliefert am 25. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Sept. 1994 Geliefert am 05. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Field barn peddars way holme next the sea norfolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft mortgage | Erstellt am 30. Juni 1994 Geliefert am 05. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £287,504.17 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The aircraft:- type: cessna citation 500 registration marks: g-ocpi manufacturers no: sn 500-0093. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Prompt credit application | Erstellt am 08. Juli 1993 Geliefert am 14. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £65,765 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1993 Geliefert am 26. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £139,589.35 and all other monies due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben One plate fin manufacturing machine supplied by gbs srl of italy and located at freeman road, north hykeham, lincoln. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A credit agreement | Erstellt am 01. Juli 1992 Geliefert am 10. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £63,033.30 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interst in and to all sums payable under the insurance for full details see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 29. Aug. 1991 Geliefert am 29. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben The aircraft:- cessna citation 500. reg mars g-OCP1 manufacturers no. S n 500-0093. (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 17. Nov. 1989 Geliefert am 28. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 18. Nov. 1988 Geliefert am 29. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Aug. 1987 Geliefert am 12. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or specialist heat exchangers limited to the chargee on any account whatsover | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0