DO IT ALL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DO IT ALL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01977522 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DO IT ALL LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich DO IT ALL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Barbirolli Square M2 3EY Manchester Greater Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DO IT ALL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PAYLESS D.I.Y. LIMITED | 28. Apr. 1986 | 28. Apr. 1986 |
| SPRIGTEAM LIMITED | 05. Feb. 1986 | 05. Feb. 1986 |
| PEACOCK & VINNELL LIMITED | 15. Jan. 1986 | 15. Jan. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DO IT ALL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 21. Feb. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DO IT ALL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 01. Mai 2012 | 27 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Nov. 2011 | 38 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 96 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 96 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 9 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William Grimsey am 13. Mai 2011 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Gawsworth House Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6XB am 11. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Robbins als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Dawn Michelle Wilkinson am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Thomas Christopher Morgan am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Bird als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Patrick Gladwin am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Brian Keith Robbins am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 21. Feb. 2010 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Brian Keith Robbins als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 06. Juli 2010 | 2 Seiten | 1.3 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Ernennung von Thomas Christopher Morgan als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Unitt als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Penelope Teale als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DO IT ALL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKINSON, Dawn Michelle | Sekretär | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire United Kingdom | British | 105435010001 | ||||||
| GLADWIN, Robert Patrick | Geschäftsführer | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | 130288970001 | |||||
| GRIMSEY, William | Geschäftsführer | 9 The Avenue WD7 7DG Radlett Tall Timbers Hertfordshire | United Kingdom | British | 50647840004 | |||||
| MORGAN, Thomas Christopher | Geschäftsführer | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | 152428250002 | |||||
| FENNELL, Sonia | Sekretär | Gilliver Cottage Gilliver Lane Clipston On The Wolds NG12 5PD Nottingham | British | 9591230004 | ||||||
| HOSKINS, William | Sekretär | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | 121893830001 | ||||||
| HUGHES, Gerard Maxwell | Sekretär | 53 Chesilton Road Fulham SW6 5AA London | British | 70698270002 | ||||||
| RIMMER, Barbara | Sekretär | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||
| STEVENS, Philip Alan | Sekretär | 31 Summit Drive IG8 8QW Woodford Green Essex | British | 9581300001 | ||||||
| WILLIAMS, David Robert | Sekretär | 15 St Stephens Road CH42 8PP Prenton Merseyside | British | 157062220001 | ||||||
| WILSON, Geoffrey Charles | Sekretär | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 72996700001 | ||||||
| ACKROYD, Keith | Geschäftsführer | 32 Far Street Bradmore NG11 6PF Nottingham Nottinghamshire | British | 9261020001 | ||||||
| ACKROYD, Keith | Geschäftsführer | 32 Far Street Bradmore NG11 6PF Nottingham Nottinghamshire | British | 9261020001 | ||||||
| ARCHER, William Ernest | Geschäftsführer | The Priory 2 Astley Close WA16 8GJ Knutsford Cheshire | British | 15170380004 | ||||||
| BIRD, Richard Sidney | Geschäftsführer | 80 Wolsey Road HA6 2EH Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 111500210002 | |||||
| BOWE, Alan Laurence | Geschäftsführer | Church View Farmhouse Church Lane, Osgathorpe LE12 9SY Loughborough Leicestershire | British | 64241650002 | ||||||
| CLAYTON SMITH, David Charles | Geschäftsführer | Church Farm Church Lane Edingale B79 9JD Tamworth Staffordshire | British | 59541540001 | ||||||
| COCKBURN, William | Geschäftsführer | 9 Avenue Road GU14 7BW Farnborough Hampshire | British | 32511820004 | ||||||
| COHEN, John Alexander | Geschäftsführer | 7 Rectory Gardens Wollaton NG8 2AR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 25406220001 | |||||
| FIELD, Malcolm, Sir | Geschäftsführer | 15 Eaton Terrace SW1W 9DD London | British | 74857040001 | ||||||
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Geschäftsführer | 3 Cottage Farm Close Osgathorpe LE12 9UE Loughborough Leicestershire | British | 52040210002 | ||||||
| FURNISS, Ronald William | Geschäftsführer | 30 Marlock Close Fiskerton NG25 0UB Southwell Nottinghamshire | British | 24556400001 | ||||||
| GILES, Alan James | Geschäftsführer | Tanglewood Crowsley Road RG9 3LE Shiplake Oxfordshire | England | British | 156046020001 | |||||
| GRIFFITHS, David | Geschäftsführer | 32 Nearsby Drive West Bridgford NG2 6LB Nottingham | England | British | 51114640001 | |||||
| HOOD, John | Geschäftsführer | Briarwood 15 Twatling Road Barnt Green B45 8HX Birmingham West Midlands | British | 39644740001 | ||||||
| HOSKINS, William | Geschäftsführer | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | 121893830001 | ||||||
| JOHNSON, Stephen Richard | Geschäftsführer | The Old Vicarage Lower Dunsforth YO26 9SA York | England | British | 87398750001 | |||||
| KIDD, Geoffrey David | Geschäftsführer | Orchard House Grey Green Lane Wribbenhall DY12 1LT Bewdley Worcestershire | British | 21889890002 | ||||||
| MCDOUGAL, Robert Hugh | Geschäftsführer | 41 Tensing Close Great Sankey WA5 5AN Warrington Cheshire | British | 15170390002 | ||||||
| MORTON, Ivor Malcolm | Geschäftsführer | Lysander 8 Pine Close Shottery CV37 9FB Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 30725390003 | ||||||
| MURRAY, Stephan Peter | Geschäftsführer | Red Brick Barn Caythorpe NG14 7EB Nottingham Nottinghamshire | British | 53490630001 | ||||||
| NAPIER, John Alexander | Geschäftsführer | Rocks Stud Farm Brantridge Lane RH17 6JR Balcombe West Sussex | British | 14311010002 | ||||||
| PIGGOTT, Kenneth Stanton | Geschäftsführer | 172 Loughborough Road NG11 6LF Ruddington Nottingham | United Kingdom | British | 144061950001 | |||||
| RADFORD, Kenneth Thomas | Geschäftsführer | 21 Melton Road Tollerton NG12 4EL Nottingham | British | 47191400001 | ||||||
| RICE, John Michael | Geschäftsführer | Wayside Cottage Street Lane Rodeheath ST7 3SN Cheshire | British | 72718070001 |
Hat DO IT ALL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mezzanine debenture | Erstellt am 03. März 2005 Geliefert am 10. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Feb. 2005 Geliefert am 25. Feb. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordinated debenture | Erstellt am 16. Feb. 2005 Geliefert am 25. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A mezzanine debenture | Erstellt am 28. Juli 2003 Geliefert am 13. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Senior security accession deed | Erstellt am 29. Jan. 2003 Geliefert am 13. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Throstle st,blackburn,bank top; LA558611; 2/26 rushbottom lane,gt.tarpotts,benfleet; EX316600; respryn rd,bodmin,CL152989. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordinated security accession deed | Erstellt am 29. Jan. 2003 Geliefert am 13. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Caernarfon rd,bangor;throstle st,blackburn,bank top; LA558611; 2/26 rushbottom lane,great tarpotts,benfleet; EX316600. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Dez. 2000 Geliefert am 09. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Dez. 2000 Geliefert am 09. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Sept. 2000 Geliefert am 17. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 19. Aug. 1998 Geliefert am 03. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any group company (as therein defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries, as therein defined) under the banking documents and the mezzanine loan agreement (both as therein defined) whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise and in each case under the working capital facility letter | |
Kurze Angaben F/H property known as bonehill road tamworth t/n SF319160, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DO IT ALL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0