EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01979747 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EMBASSY DEVELOPMENTS LIMITED | 10. Juli 1986 | 10. Juli 1986 |
| EMBASSY DEVELOPMENTS (EDGBASTON) LIMITED | 13. Juni 1986 | 13. Juni 1986 |
| TASKPLACE LIMITED | 20. Jan. 1986 | 20. Jan. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Aktienkonsolidierung am 03. Sept. 2021 | 4 Seiten | SH02 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Sept. 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 02. Sept. 2021
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 1 Seiten | DS02 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf L öschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Clement Scott als Geschäftsführer am 07. Juni 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Clement Scott als Sekretär am 07. Juni 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 45 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Alexandria Varley am 15. Nov. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Clement Scott am 15. Nov. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paul Clement Scott am 15. Nov. 2019 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 2 Langley Park Waterside Drive Langley Slough SL3 6AD zum The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden Banbury OX17 1LL am 22. Okt. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARLEY, Alexandria | Geschäftsführer | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | England | British | 114926980004 | |||||
| PRIEST, Malcolm John | Sekretär | 197a Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 106610560001 | ||||||
| SCOTT, Paul Clement | Sekretär | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | British | 22634560001 | ||||||
| WOODSIDE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 61 Woodside Road KT3 3AW New Malden Surrey | 8879140001 | |||||||
| BENDER, Stephen David | Geschäftsführer | 56 Casewick Lane Uffington PE9 4SX Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 80314720001 | |||||
| BRIDGES, Stuart John | Geschäftsführer | Jasmine Cottage Nuptown RG42 6HS Warfield Berkshire | United Kingdom | British | 42176090002 | |||||
| CLEVELEY, Michael Richard | Geschäftsführer | 75 Tiddington Road CV37 7AF Stratford Upon Avon Warwickshire | Great Britain | British | 116430680001 | |||||
| HOLBECHE, Roger Malcolm | Geschäftsführer | Barnmoor House Kington Lane CV35 8PP Claverdon Warwickshire | United Kingdom | British | 16353130007 | |||||
| KINGSHOTT, Michael James | Geschäftsführer | Church Farm House Brick Kiln Lane TN12 8EN Horsmonden Kent | United Kingdom | British | 83713020001 | |||||
| NUTTALL, Peter Donald | Geschäftsführer | 41 Nags Head Avening GL8 8NZ Tetbury Gloucestershire | British | 29476820001 | ||||||
| PASCAN, Paul Michael | Geschäftsführer | 38 Hillcroft LU6 1TU Dunstable Bedfordshire | British | 52572380001 | ||||||
| PRIEST, Malcolm John | Geschäftsführer | 197a Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 106610560001 | |||||
| RUSSELL, Barry Charles | Geschäftsführer | 21 The Albany 67 Woodcote Road SM6 0PS Wallington Surrey | British | 38094780002 | ||||||
| SCOTT, Paul Clement | Geschäftsführer | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | England | British | 22634560001 | |||||
| TICEHURST, Jonathon Mark | Geschäftsführer | The Old House 64 High Street SN14 8LP Marshfield Wiltshire | British | 87622850001 | ||||||
| TORLAGE, Kevin Edgar | Geschäftsführer | 130 Westway Raynes Park SW20 9LS London | United Kingdom | South African | 88938440001 | |||||
| TRUEMAN, Peter Roy | Geschäftsführer | 52 Dodford Road Bournheath B61 9JR Bromsgrove Worcestershire | England | British | 31798580001 | |||||
| WINDER, Simon Paul | Geschäftsführer | Flat 2 9 Westbury Road N12 7NY London | British | 75937140001 | ||||||
| WINDUSS, David Alexander | Geschäftsführer | Glebe House Buckland Dinham BA11 2QW Frome Somerset | England | British | 64556700001 | |||||
| YERBURY, John William Richard | Geschäftsführer | 10 Bannerdown Close Batheaston BA1 7NJ Bath | British | 50339880001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidvest Outsourced Services Limited | 01. Juli 2016 | Waterside Drive Langley SL3 6AD Slough Unit 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Third party legal charge | Erstellt am 29. Sept. 2003 Geliefert am 11. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from astindale properties limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land k/a the timber yard, cranbrook road, gills green, cranbrook t/no K422631. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Okt. 2001 Geliefert am 25. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a the timber yard cranbrook road gills green cranbrook kent t/n K422631. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. März 2001 Geliefert am 11. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the north of station road goudhurst kent K703321. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 13. März 1997 Geliefert am 20. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 26. Mai 1995 Geliefert am 15. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Agreements for lease in respect of phase iii, kingsway retails park, rowditch derby. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of further charge | Erstellt am 23. Nov. 1993 Geliefert am 25. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined in the further charge | |
Kurze Angaben L/H property situate on the south-east side of harbourne road and on the north west side of calthorpe road birmingham west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 01. Sept. 1993 Geliefert am 15. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Site of former electricity sub-station at kingsway retail park derby. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 14. Sept. 1992 Geliefert am 17. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 08/07/91 | |
Kurze Angaben The monies from time to time standing to the credit of account number 9837 with hill samuel bank limited opened by embassy developments limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of further charge | Erstellt am 11. Sept. 1992 Geliefert am 16. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined | |
Kurze Angaben Leasehold property situate on the south east side of harborne road and the northwest side of calthorpe road birmingham west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 20. Aug. 1992 Geliefert am 04. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All rental income due to the company in respect of the provision of car parking spaces or advertising hoarding spaces at any of the following property:- 23 great prescot street, stepney t/no. 165026 and 62/63 royal mint street and 4-10 dock street t/no. EGL221445. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 1992 Geliefert am 08. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 08. Juli 1991 Geliefert am 11. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 23/03/89 | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to two agreements dated 8TH july 1991 relating to the sale of two parts of land charged to the mortgagee and an agreement for lease dated 26/07/90. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 08. Juli 1991 Geliefert am 09. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Phase 1 kingsway retail park rowditch derby with all buildings and fixtures from time to time thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Apr. 1991 Geliefert am 17. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property k/as land on the south-east side of harborne road and on the north-west side of calthorpe road birmingham title no WM406016. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of further charge and variation | Erstellt am 11. Apr. 1991 Geliefert am 15. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold situate on the south east side of harborne road and the north west side of calthorpe road, birmingham, west midlands title no WM406016 agreements dated 13/1/8M and 31/3/8. and all profit and rents of the above property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Nov. 1990 Geliefert am 06. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a or being helena house ormskirk st., St helens merseyside, with all buildings & fixtures assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Nov. 1990 Geliefert am 06. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a or being 13/15 warwick new road leamington spa, warwickshire t/no. Wk 324538 assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Okt. 1990 Geliefert am 11. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold land at buildwin street st helens merseyside t/no. Ms 289876. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 27. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 23 prescot street london t/no. Ln 165026. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 27. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 62/63 royal mint st., London E1 t/no. LN144343. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 27. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10 dock street london E1 t/no. Ln 101125. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 27. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 8 dock street london E1 t/no. Ln 93398. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 27. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 4-6 dock street london E1 t/no. Ln 101926. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Sept. 1990 Geliefert am 19. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold land & buildings k/a prospect ii phoenix way swansea enterprise zone swansea, west glam with all buildings & fixtures the goodwill of the business and the full benefit of all present & future licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Sept. 1990 Geliefert am 19. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold land & buildings k/a castle lodge castle square ludlow, shrops with all buildings & fixtures the goodwill of the business and the full benefit of all present & future licences.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0