EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED

EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01979747
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Handover Centre Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EMBASSY DEVELOPMENTS LIMITED10. Juli 198610. Juli 1986
    EMBASSY DEVELOPMENTS (EDGBASTON) LIMITED13. Juni 198613. Juni 1986
    TASKPLACE LIMITED20. Jan. 198620. Jan. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2021 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Aktienkonsolidierung am 03. Sept. 2021

    4 SeitenSH02

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Kapitalaufstellung am 06. Sept. 2021

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Consolidation 03/09/2021
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 02. Sept. 2021

    • Kapital: GBP 50,002
    3 SeitenSH01

    Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft

    1 SeitenDS02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Paul Clement Scott als Geschäftsführer am 07. Juni 2021

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Clement Scott als Sekretär am 07. Juni 2021

    1 SeitenTM02

    Erfüllung der Belastung 45 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2020

    9 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Alexandria Varley am 15. Nov. 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Clement Scott am 15. Nov. 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paul Clement Scott am 15. Nov. 2019

    1 SeitenCH03

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 2 Langley Park Waterside Drive Langley Slough SL3 6AD zum The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden Banbury OX17 1LL am 22. Okt. 2019

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019

    9 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VARLEY, Alexandria
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Geschäftsführer
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritish114926980004
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British106610560001
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Sekretär
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    British22634560001
    WOODSIDE SECRETARIES LIMITED
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    Sekretär
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    8879140001
    BENDER, Stephen David
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish80314720001
    BRIDGES, Stuart John
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish42176090002
    CLEVELEY, Michael Richard
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Great BritainBritish116430680001
    HOLBECHE, Roger Malcolm
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritish16353130007
    KINGSHOTT, Michael James
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    Geschäftsführer
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritish83713020001
    NUTTALL, Peter Donald
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    British29476820001
    PASCAN, Paul Michael
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    British52572380001
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish106610560001
    RUSSELL, Barry Charles
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    Geschäftsführer
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    British38094780002
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Geschäftsführer
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritish22634560001
    TICEHURST, Jonathon Mark
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    British87622850001
    TORLAGE, Kevin Edgar
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    Geschäftsführer
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    United KingdomSouth African88938440001
    TRUEMAN, Peter Roy
    52 Dodford Road
    Bournheath
    B61 9JR Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    52 Dodford Road
    Bournheath
    B61 9JR Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish31798580001
    WINDER, Simon Paul
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    Geschäftsführer
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    British75937140001
    WINDUSS, David Alexander
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    EnglandBritish64556700001
    YERBURY, John William Richard
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    Geschäftsführer
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    British50339880001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bidvest Outsourced Services Limited
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    01. Juli 2016
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUk Companies Act
    RegistrierungsortCompanies House Cardiff
    Registrierungsnummer1997606
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Third party legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2003
    Geliefert am 11. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from astindale properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land k/a the timber yard, cranbrook road, gills green, cranbrook t/no K422631. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Okt. 2001
    Geliefert am 25. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a the timber yard cranbrook road gills green cranbrook kent t/n K422631. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. März 2001
    Geliefert am 11. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the north of station road goudhurst kent K703321. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. März 1997
    Geliefert am 20. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 26. Mai 1995
    Geliefert am 15. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Agreements for lease in respect of phase iii, kingsway retails park, rowditch derby. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of further charge
    Erstellt am 23. Nov. 1993
    Geliefert am 25. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined in the further charge
    Kurze Angaben
    L/H property situate on the south-east side of harbourne road and on the north west side of calthorpe road birmingham west midlands.
    Berechtigte Personen
    • Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 01. Sept. 1993
    Geliefert am 15. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Site of former electricity sub-station at kingsway retail park derby.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 14. Sept. 1992
    Geliefert am 17. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 08/07/91
    Kurze Angaben
    The monies from time to time standing to the credit of account number 9837 with hill samuel bank limited opened by embassy developments limited.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 17. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of further charge
    Erstellt am 11. Sept. 1992
    Geliefert am 16. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined
    Kurze Angaben
    Leasehold property situate on the south east side of harborne road and the northwest side of calthorpe road birmingham west midlands.
    Berechtigte Personen
    • Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 20. Aug. 1992
    Geliefert am 04. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All rental income due to the company in respect of the provision of car parking spaces or advertising hoarding spaces at any of the following property:- 23 great prescot street, stepney t/no. 165026 and 62/63 royal mint street and 4-10 dock street t/no. EGL221445.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 08. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Juli 1991
    Geliefert am 11. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 23/03/89
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to two agreements dated 8TH july 1991 relating to the sale of two parts of land charged to the mortgagee and an agreement for lease dated 26/07/90. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 08. Juli 1991
    Geliefert am 09. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Phase 1 kingsway retail park rowditch derby with all buildings and fixtures from time to time thereon.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Apr. 1991
    Geliefert am 17. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as land on the south-east side of harborne road and on the north-west side of calthorpe road birmingham title no WM406016.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of further charge and variation
    Erstellt am 11. Apr. 1991
    Geliefert am 15. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold situate on the south east side of harborne road and the north west side of calthorpe road, birmingham, west midlands title no WM406016 agreements dated 13/1/8M and 31/3/8. and all profit and rents of the above property.
    Berechtigte Personen
    • Singer & Freidlander Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 02. Nov. 1990
    Geliefert am 06. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a or being helena house ormskirk st., St helens merseyside, with all buildings & fixtures assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 02. Nov. 1990
    Geliefert am 06. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a or being 13/15 warwick new road leamington spa, warwickshire t/no. Wk 324538 assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Okt. 1990
    Geliefert am 11. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land at buildwin street st helens merseyside t/no. Ms 289876.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 17. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 1990
    Geliefert am 27. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    23 prescot street london t/no. Ln 165026.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 1990
    Geliefert am 27. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    62/63 royal mint st., London E1 t/no. LN144343.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 1990
    Geliefert am 27. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 dock street london E1 t/no. Ln 101125.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 1990
    Geliefert am 27. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    8 dock street london E1 t/no. Ln 93398.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 1990
    Geliefert am 27. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4-6 dock street london E1 t/no. Ln 101926.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 1990
    Geliefert am 19. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold land & buildings k/a prospect ii phoenix way swansea enterprise zone swansea, west glam with all buildings & fixtures the goodwill of the business and the full benefit of all present & future licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 1990
    Geliefert am 19. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land & buildings k/a castle lodge castle square ludlow, shrops with all buildings & fixtures the goodwill of the business and the full benefit of all present & future licences.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0