R.T. MASTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameR.T. MASTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01981078
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von R.T. MASTS LIMITED?

    • (3220) /

    Wo befindet sich R.T. MASTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von R.T. MASTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CASTLECO (105) LIMITED22. Jan. 198622. Jan. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von R.T. MASTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für R.T. MASTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. März 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2009

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten403a

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 19. Dez. 2008

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    21 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    5 Seiten288a

    legacy

    5 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von R.T. MASTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOLLIDAY, Peter John
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    British73600480004
    CLARKE, James Stuart
    3 Burlington Road
    Birkdale
    PR8 4RX Southport
    Geschäftsführer
    3 Burlington Road
    Birkdale
    PR8 4RX Southport
    British79483030004
    CLARKE, James
    Silvertrees 98 Victoria Road
    Formby
    L37 1LP Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Silvertrees 98 Victoria Road
    Formby
    L37 1LP Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish122650860001
    HOLLIDAY, Peter John
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish73600480004
    BYRNES, Anthony James
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    Sekretär
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    British68917030002
    CHEANEY, Bryan
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British3450590001
    DENNEHY, Angela Mary
    Holmwood Leamington Road
    WR12 7EB Broadway
    Worcestershire
    Sekretär
    Holmwood Leamington Road
    WR12 7EB Broadway
    Worcestershire
    British53952890001
    ELLISON, John Beaumont
    25a High Street
    GU19 5AF Bagshot
    Surrey
    Sekretär
    25a High Street
    GU19 5AF Bagshot
    Surrey
    British93434850001
    GREEN, Natalie Ursula
    8 Birkdale Close
    NN2 7PD Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    8 Birkdale Close
    NN2 7PD Northampton
    Northamptonshire
    British55480450001
    GREW, Christopher Adam
    15 Noel Road
    Islington
    N1 8HQ London
    Sekretär
    15 Noel Road
    Islington
    N1 8HQ London
    British40188850002
    HALL, Graeme Andrew
    4 Roman Close
    Weldon
    NN17 3JA Corby
    Northamptonshire
    Sekretär
    4 Roman Close
    Weldon
    NN17 3JA Corby
    Northamptonshire
    British66755120001
    LADHA, Alnoor
    59 Williamson Way
    WD3 8GL Rickmansworth
    Hertfordshire
    Sekretär
    59 Williamson Way
    WD3 8GL Rickmansworth
    Hertfordshire
    British89311330001
    PERKINS, William Robert
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British3450600001
    WONG, Thomas Chow Woei
    22 Hatchgate Gardens
    Burnham
    SL1 8DD Slough
    Berkshire
    Sekretär
    22 Hatchgate Gardens
    Burnham
    SL1 8DD Slough
    Berkshire
    Malaysian75111230001
    ANTONIUCCI, Pier Giorgio
    17474 Pleasant View Avenue
    Monte Sereno
    95030 California
    Usa
    Geschäftsführer
    17474 Pleasant View Avenue
    Monte Sereno
    95030 California
    Usa
    American56303650001
    BYRNES, Anthony James
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    Geschäftsführer
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    United KingdomBritish68917030002
    CHEANEY, Bryan
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British3450590001
    COLLINS, Robert
    1473 Los Rios Drive
    San Jose, California, 95120
    FOREIGN Usa
    Geschäftsführer
    1473 Los Rios Drive
    San Jose, California, 95120
    FOREIGN Usa
    American67233600001
    COPLEY, Stephen Gerald
    The Croft Banbury Road
    Ladbroke
    CV47 2BY Southam
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Croft Banbury Road
    Ladbroke
    CV47 2BY Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish99105730001
    CROFTS, Paul Nicholas
    1 College Gardens
    PE15 8LF March
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    1 College Gardens
    PE15 8LF March
    Cambridgeshire
    British105233500001
    DORAN, Michael John
    Hope Cottage
    Ashorne
    CV35 9DR Warwick
    Geschäftsführer
    Hope Cottage
    Ashorne
    CV35 9DR Warwick
    EnglandBritish81077000001
    GEORGE, Alan Stanley
    4 Woodbine Street
    CV32 5BG Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    4 Woodbine Street
    CV32 5BG Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish53459730002
    HARRIS, Stephen Vincent
    Barn House North Street
    Rothersthorpe
    NN7 3JB Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Barn House North Street
    Rothersthorpe
    NN7 3JB Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish109731100001
    LYONS, Peter
    43 Whitefields Road
    B91 3NX Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    43 Whitefields Road
    B91 3NX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish54930900001
    MACDONALD, Bruce
    43 Kingsway Gardens
    SO53 1FF Chandlers Ford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    43 Kingsway Gardens
    SO53 1FF Chandlers Ford
    Hampshire
    United KingdomBritish182949740001
    MACLEAN, Ian Charles
    Duart House
    Broad Hinton
    SN4 9PQ Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Duart House
    Broad Hinton
    SN4 9PQ Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish79096180001
    MANNIX, Daniel
    4 Canterbury Close
    Aintree
    L10 8LA Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    4 Canterbury Close
    Aintree
    L10 8LA Liverpool
    Merseyside
    British89797230001
    MARSHALL, Steven Christopher
    Latimer Lodge
    Burtons Lane
    HP8 4BS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Latimer Lodge
    Burtons Lane
    HP8 4BS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish122373680001
    NEWTON, Nigel Ernest
    Brantwood House
    Thorp, Royton
    OL2 5TH Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Brantwood House
    Thorp, Royton
    OL2 5TH Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritish96221070002
    PERKINS, Andrew William
    45 Swinford Hollow
    Little Billing
    NN3 9HP Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    45 Swinford Hollow
    Little Billing
    NN3 9HP Northampton
    Northamptonshire
    British55838180001
    PERKINS, Mark Robert
    22 Turnberry Lane
    Collingtree Park
    NN4 0PA Northampton
    Northants
    Geschäftsführer
    22 Turnberry Lane
    Collingtree Park
    NN4 0PA Northampton
    Northants
    United KingdomBritish99080730001
    PERKINS, William Robert
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British3450600001
    RANSLEY, Brandon William
    15 Hardingstone Lane
    Hardingstone
    NN4 6DF Northampton
    Geschäftsführer
    15 Hardingstone Lane
    Hardingstone
    NN4 6DF Northampton
    British61675530001
    ROBERTS, George Powers
    15163 Alondra Lane
    Saratoga
    California
    95070
    Usa
    Geschäftsführer
    15163 Alondra Lane
    Saratoga
    California
    95070
    Usa
    American56335490002
    SHONE, Christopher John
    27 Dale Avenue
    NN8 3QT Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    27 Dale Avenue
    NN8 3QT Wellingborough
    Northamptonshire
    British3633520001

    Hat R.T. MASTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 24. Jan. 2008
    Geliefert am 06. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 3 morris close, park farm, north wellingborough t/no. NN142728. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Mai 2007
    Geliefert am 18. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 2, 3 morris close park farm industrial estate wellingborough t/n NN142728. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Nov. 2005
    Geliefert am 03. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Mai 2005
    Geliefert am 19. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited 'Security Holder'
    Transaktionen
    • 19. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 29. Apr. 1997
    Geliefert am 07. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Apr. 1997
    Geliefert am 07. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 3 (formerly unit 2) morris close park farm north wellingborough northamptonshire t/no.NN142728 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Apr. 1997
    Geliefert am 07. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 4 (formerly unit 3) morris close park farm north wellingborough northamptonshire and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 09. Sept. 1994
    Geliefert am 21. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 2, chieftain business park, park farm industrial estate, wellingborough, northants and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Sept. 1992
    Geliefert am 25. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal charge over the bookdebts and the benefit of all rights thereto now and from time to time due or owing to the company.
    Berechtigte Personen
    • Maddox Factoring (UK) LTD
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 20. Apr. 1988
    Geliefert am 22. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 03. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 23. Mai 1986
    Geliefert am 02. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1986Registrierung einer Belastung

    Hat R.T. MASTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Dez. 2008Beginn der Liquidation
    16. Juni 2010Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Brian Green
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0