HUTHCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HUTHCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01982875 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HUTHCO LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich HUTHCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Baris House Nunn Brook Road NG17 2HU County Estate, Huthwaite, Notts |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HUTHCO LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BARIS UK LIMITED | 07. Apr. 1992 | 07. Apr. 1992 |
| BARIS (FIRE PROTECTION) LIMITED | 28. Jan. 1986 | 28. Jan. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HUTHCO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HUTHCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2009 | 6 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2008 | 6 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2007 | 5 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2006 | 5 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2005 | 5 Seiten | AA | ||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2004 | 4 Seiten | AA | ||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2003 | 4 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von HUTHCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRY, Laura Margaret | Sekretär | Abbeydale Hall Abbeydale Road South S173LJ Dore 26 Sheffield England | Other | 77297900007 | ||||||
| BRUCE, Anthony | Geschäftsführer | Croft House Farm 31 Bar Road North Beckingham DN10 4NN Doncaster South Yorkshire | England | British | 59900860001 | |||||
| DAMMS, Terence Alan | Geschäftsführer | Bower Cottage Bland Lane Wadsley S6 4BQ Sheffield | United Kingdom | British | 13195770002 | |||||
| HINCHCLIFFE, Howard George | Sekretär | 10 Eskdale Close S18 8PQ Dronfield Derbyshire | British | 111605450001 | ||||||
| LINFORD, Stephen Geoffrey | Sekretär | Brook House School Road Snitterfield CV37 0JL Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 15354310001 | ||||||
| THOMSON, William Robert | Sekretär | 39 Sheffield Park Avenue DN15 8PJ Scunthorpe South Humberside | British | 40774820001 | ||||||
| GAMBLE, John Russell | Geschäftsführer | 5 Knowle Green Dore S17 3AP Sheffield South Yorkshire | British | 45620710003 | ||||||
| HINCHCLIFFE, Howard George | Geschäftsführer | 10 Eskdale Close S18 8PQ Dronfield Derbyshire | British | 111605450001 | ||||||
| HOLMAN, Andrew Philip William | Geschäftsführer | Regents House Clevedon House Prince Of Wales Road NR27 9HR Cromer Norfolk | British | 45620670001 | ||||||
| LINFORD, Stephen Geoffrey | Geschäftsführer | Brook House School Road Snitterfield CV37 0JL Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 15354310001 | ||||||
| SMITH, Robert Ian | Geschäftsführer | The Oaks Newstead Abbey Park NG15 8GD Nottingham Nottinghamshire | England | British | 54241600001 | |||||
| THOMSON, William Robert | Geschäftsführer | 39 Sheffield Park Avenue DN15 8PJ Scunthorpe South Humberside | British | 40774820001 |
Hat HUTHCO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Aug. 1998 Geliefert am 19. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 12. Aug. 1998 Geliefert am 19. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a facility agreement dated 12TH august 1998 or under the mortgage debenture and whether on any current or other account | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Nov. 1994 Geliefert am 30. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever limited to the sum of £300,000 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Juli 1988 Geliefert am 01. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The westbarn, 3 kirkstead abbey mews, upper wortley road, thorpe hesley, south yorkshire. Title no syk 216133 and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 12. Nov. 1987 Geliefert am 18. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0