HEG (NUMBER 1) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HEG (NUMBER 1) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01984677 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HEG (NUMBER 1) LIMITED?
- (5146) /
Wo befindet sich HEG (NUMBER 1) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 822 Fountain Court Birchwood Boulevard Birchwood WA3 7QZ Warrington England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HEG (NUMBER 1) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FIRST AID UK LTD | 10. März 1993 | 10. März 1993 |
| STAFFORDSHIRE FIRST AID SUPPLIES LIMITED | 02. Apr. 1986 | 02. Apr. 1986 |
| DATECOVER LIMITED | 31. Jan. 1986 | 31. Jan. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HEG (NUMBER 1) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HEG (NUMBER 1) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 17 Chesford Grange Woolston Warrington Cheshire WA1 4RQ am 27. Mai 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Lyndon James Gaborit am 26. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed first aid uk LTD\certificate issued on 25/04/08 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2007 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2006 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2005 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HEG (NUMBER 1) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip | Sekretär | Crossfield House Aston By Budworth CW9 6NG Northwich Cheshire | British | 79348050002 | ||||||
| FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip | Geschäftsführer | Crossfield House Aston By Budworth CW9 6NG Northwich Cheshire | England | British | 79348050002 | |||||
| GABORIT, Lyndon James | Geschäftsführer | Lower Addison Gardens W14 8BG London 25 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 133660360001 | |||||
| BRADSHAW, John | Sekretär | 200 Broadway PE1 4DT Peterborough Cambridgeshire | British | 54189670005 | ||||||
| DENOS, Kenneth | Sekretär | 12694 South Rosburg Dr Riverton Utah 84065 Usa | American | 93963450001 | ||||||
| GABORIT, Lyndon James | Sekretär | 28 Welbeck Street W1G 8EW London | Australian | 65921870004 | ||||||
| PEAR, Andrew Mark | Sekretär | Tannen Holmes Chapel Road Somerford CW12 4QB Congleton Cheshire | British | 114397290001 | ||||||
| BRADSHAW, John | Geschäftsführer | 200 Broadway PE1 4DT Peterborough Cambridgeshire | England | British | 54189670005 | |||||
| BRUCK, Stuart | Geschäftsführer | 2116 31st Street 90266 Manhattan Beach California | American | 57236400002 | ||||||
| GABORIT, Lyndon James | Geschäftsführer | 28 Welbeck Street W1G 8EW London | Australian | 65921870004 | ||||||
| PEAR, Andrew Mark | Geschäftsführer | Tannen Holmes Chapel Road Somerford CW12 4QB Congleton Cheshire | England | British | 114397290001 | |||||
| PEAR, Graham | Geschäftsführer | 9 Fenton Close CW12 3TH Congleton Cheshire | England | British | 13275040003 | |||||
| PEAR, Graham | Geschäftsführer | 77 Avon Drive CW12 3RG Congleton Cheshire | British | 13275040001 | ||||||
| PEAR, Susan Dawn | Geschäftsführer | Bramble End The Mount CW12 4FD Congleton Cheshire | British | 100025290001 | ||||||
| TOMPKINS, Henry John Mark | Geschäftsführer | 18 Thurloe Square SW7 2TE London | England | British | 109723760001 | |||||
| WOOD, Gordon Alexander | Geschäftsführer | 19th Street Manhattan Beach 404 Ca 90266 Usa | British | 136141810001 |
Hat HEG (NUMBER 1) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge | Erstellt am 28. Juni 2004 Geliefert am 01. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Sept. 2002 Geliefert am 21. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north east side of back lane radnor park industrial estate congleton cheshire CW12 t/n CH442637. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 29. Okt. 2001 Geliefert am 02. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the financing agreement (as defined in the fixed and floating charge) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 23. Juni 1999 Geliefert am 06. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 14 silk street congleton cheshire t/no: CH360920. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Mai 1997 Geliefert am 24. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge all book and other debts of the company põresent and future save for book and other debts sold by the company and purchased by the security holder under an invoice discounting agreement and not repurchased pursuant to the provisions thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Jan. 1997 Geliefert am 19. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as 12 silk st,congleton cheshire and the proceeds of sale thereof; t/no ch 331506. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 22. Jan. 1991 Geliefert am 28. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0