HEG (NUMBER 1) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHEG (NUMBER 1) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01984677
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    • (5146) /

    Wo befindet sich HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    822 Fountain Court
    Birchwood Boulevard Birchwood
    WA3 7QZ Warrington
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FIRST AID UK LTD10. März 199310. März 1993
    STAFFORDSHIRE FIRST AID SUPPLIES LIMITED02. Apr. 198602. Apr. 1986
    DATECOVER LIMITED31. Jan. 198631. Jan. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 17 Chesford Grange Woolston Warrington Cheshire WA1 4RQ am 27. Mai 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Mai 2010

    Kapitalaufstellung am 26. Mai 2010

    • Kapital: GBP 500
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Lyndon James Gaborit am 26. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed first aid uk LTD\certificate issued on 25/04/08
    3 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2006

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2005

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Sekretär
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    British79348050002
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish79348050002
    GABORIT, Lyndon James
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United Kingdom
    United KingdomAustralian133660360001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Sekretär
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    British54189670005
    DENOS, Kenneth
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    Sekretär
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    American93963450001
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Sekretär
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Australian65921870004
    PEAR, Andrew Mark
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    Sekretär
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    British114397290001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish54189670005
    BRUCK, Stuart
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    Geschäftsführer
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    American57236400002
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Geschäftsführer
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Australian65921870004
    PEAR, Andrew Mark
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish114397290001
    PEAR, Graham
    9 Fenton Close
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    9 Fenton Close
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish13275040003
    PEAR, Graham
    77 Avon Drive
    CW12 3RG Congleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    77 Avon Drive
    CW12 3RG Congleton
    Cheshire
    British13275040001
    PEAR, Susan Dawn
    Bramble End The Mount
    CW12 4FD Congleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bramble End The Mount
    CW12 4FD Congleton
    Cheshire
    British100025290001
    TOMPKINS, Henry John Mark
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    Geschäftsführer
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    EnglandBritish109723760001
    WOOD, Gordon Alexander
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    Geschäftsführer
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    British136141810001

    Hat HEG (NUMBER 1) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 28. Juni 2004
    Geliefert am 01. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 21. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north east side of back lane radnor park industrial estate congleton cheshire CW12 t/n CH442637. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 29. Okt. 2001
    Geliefert am 02. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the financing agreement (as defined in the fixed and floating charge)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Juni 1999
    Geliefert am 06. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 14 silk street congleton cheshire t/no: CH360920. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Mai 1997
    Geliefert am 24. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge all book and other debts of the company põresent and future save for book and other debts sold by the company and purchased by the security holder under an invoice discounting agreement and not repurchased pursuant to the provisions thereof.
    Berechtigte Personen
    • New Court Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 24. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 1997
    Geliefert am 19. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 12 silk st,congleton cheshire and the proceeds of sale thereof; t/no ch 331506. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Jan. 1991
    Geliefert am 28. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 11. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0