B.V.S. RENTALS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameB.V.S. RENTALS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01985727
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von B.V.S. RENTALS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich B.V.S. RENTALS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von B.V.S. RENTALS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für B.V.S. RENTALS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Matthew Jowett als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Philip Harrison als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    5 SeitenAA

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Jan. 2010

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Vt House, Grange Drive Hedge End Southampton Hampshire SO30 2DQ am 15. Feb. 2010

    2 SeitenAD01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Matthew Paul Jowett am 15. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip James Harrison am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Davies am 13. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Okt. 2009

    Kapitalaufstellung am 27. Okt. 2009

    • Kapital: GBP 150,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von B.V.S. RENTALS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, John Richard
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish128289970002
    COKER, Peter John
    12 Crispin Field
    Pitstone
    LU7 9BG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Sekretär
    12 Crispin Field
    Pitstone
    LU7 9BG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British20675290001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Sekretär
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Sekretär
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    GOWER, Angela
    53 Chipping Vale
    Emerson Valley
    MK4 2HT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    53 Chipping Vale
    Emerson Valley
    MK4 2HT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British31041710002
    HODGES, Andrew William
    Flat 202
    7 Garden Walk
    EC2A 3EW London
    Sekretär
    Flat 202
    7 Garden Walk
    EC2A 3EW London
    British77527910003
    IVES, Deborah Ann
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    Sekretär
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    British61720060001
    JONSSON, Elizabeth Irvine Reid
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British71376550001
    JOWETT, Matthew Paul
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Sekretär
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    British205867540001
    RICHARDSON, Elaine
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    British36633090001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Sekretär
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    COSGROVE, Peter
    36 Grove Road
    LE10 2AD Burbage
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    36 Grove Road
    LE10 2AD Burbage
    Leicestershire
    British33464380002
    CUNDY, Christopher John
    74 Downscroft Gardens
    Hedge End
    SO30 4RS Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    74 Downscroft Gardens
    Hedge End
    SO30 4RS Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish61210490001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Geschäftsführer
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritish105999210001
    GREEN, Tresham Edward David
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    Geschäftsführer
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    British20695790001
    HARRIS, Peter Robert
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritish50619920001
    HARRISON, Philip James
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritish126366670001
    ILIC, Kosovka
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    Geschäftsführer
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    British20675310001
    JONSSON, Elizabeth Irvine Reid
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British71376550001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    British145338560001
    PRICE, David John
    Wykham Helmdon Road
    Sulgrave
    OX17 2SQ Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Wykham Helmdon Road
    Sulgrave
    OX17 2SQ Banbury
    Oxfordshire
    British45828440002
    SIMPSON, Alan Keith
    Watchbury Hill Hareway Lane
    Barford
    CV35 8DD Warwick
    Geschäftsführer
    Watchbury Hill Hareway Lane
    Barford
    CV35 8DD Warwick
    British35940110003
    SMALE, Sarah Anne Margaret
    2 The Green
    Longwick
    HP27 9QY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 The Green
    Longwick
    HP27 9QY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British37137790002
    SMITH, David Michael
    Woodlands
    Main Drive
    CV35 9BT Moreton Paddox
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Woodlands
    Main Drive
    CV35 9BT Moreton Paddox
    Warwickshire
    British47361390001
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    The Old Rectory
    Longham
    NR19 2RG East Dereham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Longham
    NR19 2RG East Dereham
    Norfolk
    British145338520001
    TARRANT, Simon Edward
    Redlands Farm
    Duncton
    GU28 0JY Petworth
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Redlands Farm
    Duncton
    GU28 0JY Petworth
    West Sussex
    British35197570012
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Geschäftsführer
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    AVIVA DIRECTOR SERVICES LIMITED
    St. Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Geschäftsführer
    St. Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    60496090003

    Hat B.V.S. RENTALS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 06. Okt. 1995
    Geliefert am 10. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over the benfit of hire contracts.
    Berechtigte Personen
    • Hitachi Credit (UK) PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First fixed charge
    Erstellt am 08. Okt. 1993
    Geliefert am 12. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase or lease agreements
    Kurze Angaben
    (I)all sub-lease agreements.(ii)the full benefit and advantage of the moneys payable.(iii)the benefit of all guarantees and indemnities.(iv)the benefit of all insurance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master agreement
    Erstellt am 06. Juli 1993
    Geliefert am 13. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee s
    Kurze Angaben
    All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in supplementary schedules from time to time entered into pursuant to the master agreement and in all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Leasing Limited
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    Transaktionen
    • 13. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Aug. 1987
    Geliefert am 11. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the and or B.V.S. watford limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    • 06. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 10. März 1987
    Geliefert am 19. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. März 1987Registrierung einer Belastung
    • 03. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat B.V.S. RENTALS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Jan. 2010Beginn der Liquidation
    04. Aug. 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0