B.V.S. RENTALS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | B.V.S. RENTALS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01985727 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von B.V.S. RENTALS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich B.V.S. RENTALS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von B.V.S. RENTALS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für B.V.S. RENTALS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Jan. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Jowett als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Harrison als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:replacement of liquidator | 8 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Vt House, Grange Drive Hedge End Southampton Hampshire SO30 2DQ am 15. Feb. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Matthew Paul Jowett am 15. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip James Harrison am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Davies am 13. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von B.V.S. RENTALS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, John Richard | Geschäftsführer | Salisbury Square EC4Y 8BB London 8 | United Kingdom | British | 128289970002 | |||||
| COKER, Peter John | Sekretär | 12 Crispin Field Pitstone LU7 9BG Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 20675290001 | ||||||
| COLES, Pamela Mary | Sekretär | 41 Baring Road HP9 2NB Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980001 | ||||||
| COLES, Pamela Mary | Sekretär | 41 Baring Road HP9 2NB Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980001 | ||||||
| GOWER, Angela | Sekretär | 53 Chipping Vale Emerson Valley MK4 2HT Milton Keynes Buckinghamshire | British | 31041710002 | ||||||
| HODGES, Andrew William | Sekretär | Flat 202 7 Garden Walk EC2A 3EW London | British | 77527910003 | ||||||
| IVES, Deborah Ann | Sekretär | Chukwani The Friary Old Windsor SL4 2NS Windsor Berkshire | British | 61720060001 | ||||||
| JONSSON, Elizabeth Irvine Reid | Sekretär | The Spinney Featherbed Lane, Pathlow CV37 0ER Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 71376550001 | ||||||
| JOWETT, Matthew Paul | Sekretär | Salisbury Square EC4Y 8BB London 8 | British | 205867540001 | ||||||
| RICHARDSON, Elaine | Sekretär | The Willows Willowside London Colney AL2 1DP St Albans Hertfordshire | British | 36633090001 | ||||||
| YOUNG, Mark Lees | Sekretär | 68 Wycherley Crescent EN5 1AP New Barnet Hertfordshire | British | 32782910002 | ||||||
| YOUNG, Mark Lees | Sekretär | 68 Wycherley Crescent EN5 1AP New Barnet Hertfordshire | British | 32782910002 | ||||||
| YOUNG, Mark Lees | Sekretär | 68 Wycherley Crescent EN5 1AP New Barnet Hertfordshire | British | 32782910002 | ||||||
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 1278390004 | |||||||
| COLES, Pamela Mary | Geschäftsführer | 41 Baring Road HP9 2NB Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980001 | ||||||
| COSGROVE, Peter | Geschäftsführer | 36 Grove Road LE10 2AD Burbage Leicestershire | British | 33464380002 | ||||||
| CUNDY, Christopher John | Geschäftsführer | 74 Downscroft Gardens Hedge End SO30 4RS Southampton Hampshire | England | British | 61210490001 | |||||
| EASTER, Philip Charles | Geschäftsführer | Arlington House Arlington Lane NR2 2DB Norwich | England | British | 105999210001 | |||||
| GREEN, Tresham Edward David | Geschäftsführer | Anesham Cottage Brownlow Avenue LU6 2JE Edlesborough Beds | British | 20695790001 | ||||||
| HARRIS, Peter Robert | Geschäftsführer | Four Winds Fireball Hill SL5 9PJ Sunningdale Berkshire | United Kingdom | British | 50619920001 | |||||
| HARRISON, Philip James | Geschäftsführer | Salisbury Square EC4Y 8BB London 8 | England | British | 126366670001 | |||||
| ILIC, Kosovka | Geschäftsführer | Anesham Cottage Brownlow Avenue LU6 2JE Edlesborough Beds | British | 20675310001 | ||||||
| JONSSON, Elizabeth Irvine Reid | Geschäftsführer | The Spinney Featherbed Lane, Pathlow CV37 0ER Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 71376550001 | ||||||
| MACHELL, Simon Christopher | Geschäftsführer | Gooch's Farm Rushall IP21 4QB Diss Norfolk | British | 145338560001 | ||||||
| PRICE, David John | Geschäftsführer | Wykham Helmdon Road Sulgrave OX17 2SQ Banbury Oxfordshire | British | 45828440002 | ||||||
| SIMPSON, Alan Keith | Geschäftsführer | Watchbury Hill Hareway Lane Barford CV35 8DD Warwick | British | 35940110003 | ||||||
| SMALE, Sarah Anne Margaret | Geschäftsführer | 2 The Green Longwick HP27 9QY Princes Risborough Buckinghamshire | British | 37137790002 | ||||||
| SMITH, David Michael | Geschäftsführer | Woodlands Main Drive CV35 9BT Moreton Paddox Warwickshire | British | 47361390001 | ||||||
| SNOWBALL, Patrick Joseph Robert | Geschäftsführer | The Old Rectory Longham NR19 2RG East Dereham Norfolk | British | 145338520001 | ||||||
| TARRANT, Simon Edward | Geschäftsführer | Redlands Farm Duncton GU28 0JY Petworth West Sussex | British | 35197570012 | ||||||
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 1278390004 | |||||||
| AVIVA DIRECTOR SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | St. Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 60496090003 |
Hat B.V.S. RENTALS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 06. Okt. 1995 Geliefert am 10. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over the benfit of hire contracts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First fixed charge | Erstellt am 08. Okt. 1993 Geliefert am 12. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase or lease agreements | |
Kurze Angaben (I)all sub-lease agreements.(ii)the full benefit and advantage of the moneys payable.(iii)the benefit of all guarantees and indemnities.(iv)the benefit of all insurance.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Master agreement | Erstellt am 06. Juli 1993 Geliefert am 13. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee s | |
Kurze Angaben All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in supplementary schedules from time to time entered into pursuant to the master agreement and in all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Aug. 1987 Geliefert am 11. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the and or B.V.S. watford limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 10. März 1987 Geliefert am 19. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat B.V.S. RENTALS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0